ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01105441
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    • Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    FTBF LEASING DECEMBER (A) LIMITED15/02/199515/02/1995
    FORWARD ASSET LEASING DECEMBER (A) LIMITED14/08/199214/08/1992
    MIDLAND MONTAGU EQUIPMENT FINANCE LIMITED30/03/197330/03/1973

    Quais são as últimas contas de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Quais são as últimas submissões para ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Segunda apresentação para a cessação de funções de Robin Louise Henning Bencard como administrador

    5 páginasRP04TM01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Término da nomeação de Robin Louis Henning Bencard como diretor em 08/08/2016

    2 páginasTM01
    Anotações
    DataAnotação
    09/09/2016Clarification A second filed TM01 was registered on 09/09/2016

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    4 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Declaração anual preparada até 01/05/2016 com lista completa de acionistas

    9 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital05/05/2016

    Estado do capital em 05/05/2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nomeação de Mr Simon Einar Long como diretor em 15/03/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David John Cavanna como diretor em 31/12/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Michael Connelly Anderson como diretor em 16/12/2015

    2 páginasAP01

    Renúncia do auditor

    2 páginasAUD

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    19 páginasAA

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Término da nomeação de Hannah Elizabeth Shepherd como secretário em 28/05/2015

    1 páginasTM02

    Nomeação de Ms Romana Lewis como secretário em 28/05/2015

    2 páginasAP03

    Declaração anual preparada até 01/05/2015 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/05/2015

    Estado do capital em 08/05/2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nomeação de Hannah Elizabeth Shepherd como secretário em 05/01/2015

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Tony Bhambhra como secretário em 05/01/2015

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    20 páginasAA

    Nomeação de Tony Bhambhra como secretário

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Katherine Dean como secretário

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 01/05/2014 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/05/2014

    Estado do capital em 08/05/2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Resoluções

    Resolutions
    52 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Quem são os diretores de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Secretário
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    198057230001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Secretário
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    187824150001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092200001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Secretário
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Secretário
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Secretário
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Secretário
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Secretário
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Secretário
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Secretário
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Secretário
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194209400001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154911860001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967460001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    BROOKES, Malcolm James
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    Diretor
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    British61727900003
    CARNEY, Brian
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    British100001170001
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Diretor
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Diretor
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Diretor
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HARRIS, Christopher David
    8 Verdon Place
    Barford
    CV35 8BT Warwick
    Diretor
    8 Verdon Place
    Barford
    CV35 8BT Warwick
    British28742940002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Diretor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Diretor
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Diretor
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Diretor
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    LEECH, Ian Robert
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    Diretor
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    British52909330001
    LESTER, Edward Paul
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    Diretor
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    British4300370001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Diretor
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001

    ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Amended and restated intercreditor agreement
    Criado em 19/12/1997
    Entregue em 31/12/1997
    Pendente
    Montante garantido
    In favour of chase manhattan international limited as security agent and trustee for the senior creditors (as defined) and the lessors (as defined) (1)the senior debt, subject to clause 11.2, clause 11.4, clause 27.3(iii) and clause 27.4(b) of the intercreditor agreement all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents (as defined), (2)the lease debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the lessors under or in connection with the lease finance documents (as defined) and (3) the subordinated debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the subordinated creditors (as defined) under or in connection with the subordinated debt documents or in connection with treasury debt and all indemnity rights
    Breve descrição
    If at any time prior to the later of the senior discharge date the company receives a payment or distribution in cash or kind of or on account of any lease debt or prior to the senior discharge date any lease debt is discharged in each case in a manner not permitted by clause 6 (permitted lease payments) by clause 7 (permitted subordinated payments) or clause 15.1 (permitted lease enforcement) clause 15.2 (permitted enforcement action in respect of vat) or by clause 17 (proceeds of enforcement of security) the company will subject to clause 10.9 (exclusion of trust) hold such recovery payment distribution proceeds set-off or other amount in trust for the security trustee.
    Pessoas com direito
    • Chase Manhattan International Limited
    Transações
    • 31/12/1997Registro de uma garantia (395)
    Chattel mortgage
    Criado em 19/12/1997
    Entregue em 31/12/1997
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the chattel mortgage under and in accordance with clause 4 (sales representative) of the direct agreement
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the english assets ,the scottish assets and the northern irish assets including the sale proceeds thereof for full details of charged assets please refer to form 395.
    Pessoas com direito
    • Chase Manhattan International Limited
    Transações
    • 31/12/1997Registro de uma garantia (395)
    Lessor's security assignment (as defined)
    Criado em 19/12/1996
    Entregue em 27/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage
    Breve descrição
    All rights,title and interest in respect of clause 5.1 of the conditional sale agreement to acquire ownership of the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Samoco 1233 Trust
    Transações
    • 27/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 12/02/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 10/12/1996
    Entregue em 20/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage
    Breve descrição
    All rights,title,interest,insurances and proceeds of sale in the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Samoco 1233 Trust
    Transações
    • 20/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 12/02/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0