ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01105441 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
- Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| FTBF LEASING DECEMBER (A) LIMITED | 15/02/1995 | 15/02/1995 |
| FORWARD ASSET LEASING DECEMBER (A) LIMITED | 14/08/1992 | 14/08/1992 |
| MIDLAND MONTAGU EQUIPMENT FINANCE LIMITED | 30/03/1973 | 30/03/1973 |
Quais são as últimas contas de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2014 |
Quais são as últimas submissões para ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Segunda apresentação para a cessação de funções de Robin Louise Henning Bencard como administrador | 5 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Término da nomeação de Robin Louis Henning Bencard como diretor em 08/08/2016 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/05/2016 com lista completa de acionistas | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Simon Einar Long como diretor em 15/03/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de David John Cavanna como diretor em 31/12/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Michael Connelly Anderson como diretor em 16/12/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Renúncia do auditor | 2 páginas | AUD | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Renúncia do auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Término da nomeação de Hannah Elizabeth Shepherd como secretário em 28/05/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Ms Romana Lewis como secretário em 28/05/2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/05/2015 com lista completa de acionistas | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Hannah Elizabeth Shepherd como secretário em 05/01/2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Tony Bhambhra como secretário em 05/01/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2013 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Tony Bhambhra como secretário | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Katherine Dean como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/05/2014 com lista completa de acionistas | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluções Resolutions | 52 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Quem são os diretores de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Romana | Secretário | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E145HQ London, Greater London 8 England England | 198057230001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| KENT, John Richard | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 174308200001 | |||||
| LONG, Simon Einar | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 206202590001 | |||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||
| SUBRAMANIYAN, Jaya | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | 136924480002 | |||||
| BAYER, George William | Secretário | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| BHAMBHRA, Tony | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 187824150001 | |||||||
| DEAN, Katherine | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180092200001 | |||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Secretário | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| MCKENZIE, John Hume | Secretário | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Secretário | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Secretário | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Secretário | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Secretário | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Secretário | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| READ, Alice | Secretário | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194209400001 | |||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154911860001 | |||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 166967460001 | |||||||
| BARKER, Fiona Ann | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||
| BROOKES, Malcolm James | Diretor | 3 School Close Pinvin WR10 2TZ Pershore Worcestershire | British | 61727900003 | ||||||
| CARNEY, Brian | Diretor | Springwood Lodge Owler Park Road LS29 0BG Ilkley West Yorkshire | British | 100001170001 | ||||||
| CAVANNA, David John | Diretor | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| EVANS, Geoffrey William | Diretor | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 | ||||||
| GILMAN, David William | Diretor | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| HARRIS, Christopher David | Diretor | 8 Verdon Place Barford CV35 8BT Warwick | British | 28742940002 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Diretor | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | 28497420002 | ||||||
| KELL, Christopher Raymond | Diretor | 6 Gorse Close WR9 7SG Droitwich Worcestershire | British | 87307470001 | ||||||
| KENNY, Mary Bridget | Diretor | 178 Empire Square West Long Lane SE1 4NL London | United Kingdom | British | 118995490002 | |||||
| LANE, Robert David | Diretor | 42 Bridgnorth Road WV5 0AA Wombourne Staffordshire | England | British | 150099050001 | |||||
| LEECH, Ian Robert | Diretor | 139 Lordswood Road Harborne B17 9BL Birmingham | British | 52909330001 | ||||||
| LESTER, Edward Paul | Diretor | 26 St Barnabas Road CB1 2BY Cambridge Cambridgeshire | British | 4300370001 | ||||||
| MEAD, David Harry | Diretor | Willowbank Pirton WR8 9ED Worcester Worcestershire | England | British | 254170760001 |
ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Amended and restated intercreditor agreement | Criado em 19/12/1997 Entregue em 31/12/1997 | Pendente | Montante garantido In favour of chase manhattan international limited as security agent and trustee for the senior creditors (as defined) and the lessors (as defined) (1)the senior debt, subject to clause 11.2, clause 11.4, clause 27.3(iii) and clause 27.4(b) of the intercreditor agreement all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents (as defined), (2)the lease debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the lessors under or in connection with the lease finance documents (as defined) and (3) the subordinated debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the subordinated creditors (as defined) under or in connection with the subordinated debt documents or in connection with treasury debt and all indemnity rights | |
Breve descrição If at any time prior to the later of the senior discharge date the company receives a payment or distribution in cash or kind of or on account of any lease debt or prior to the senior discharge date any lease debt is discharged in each case in a manner not permitted by clause 6 (permitted lease payments) by clause 7 (permitted subordinated payments) or clause 15.1 (permitted lease enforcement) clause 15.2 (permitted enforcement action in respect of vat) or by clause 17 (proceeds of enforcement of security) the company will subject to clause 10.9 (exclusion of trust) hold such recovery payment distribution proceeds set-off or other amount in trust for the security trustee. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Chattel mortgage | Criado em 19/12/1997 Entregue em 31/12/1997 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the chattel mortgage under and in accordance with clause 4 (sales representative) of the direct agreement | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the english assets ,the scottish assets and the northern irish assets including the sale proceeds thereof for full details of charged assets please refer to form 395. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Lessor's security assignment (as defined) | Criado em 19/12/1996 Entregue em 27/12/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage | |
Breve descrição All rights,title and interest in respect of clause 5.1 of the conditional sale agreement to acquire ownership of the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage | Criado em 10/12/1996 Entregue em 20/12/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage | |
Breve descrição All rights,title,interest,insurances and proceeds of sale in the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0