JENWAY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaJENWAY LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01119693
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de JENWAY LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica JENWAY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de JENWAY LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2013

    Qual é o status da última declaração anual para JENWAY LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para JENWAY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 5

    2 páginasMR05

    Detalhes do diretor alterados para Michael Eric Nevin em 01/06/2015

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Adam David Robson como diretor em 12/04/2015

    TM01

    Declaração anual preparada até 04/01/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/02/2015

    Estado do capital em 02/02/2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Michael Eric Nevin em 09/10/2014

    2 páginasCH01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração anual preparada até 04/01/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital23/01/2014

    Estado do capital em 23/01/2014

    • Capital: GBP 415,639
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2013

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 04/01/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2012

    5 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Adam David Robson em 15/02/2012

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Adam David Robson em 15/02/2012

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 04/01/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2011

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 04/01/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Adam David Robson em 06/12/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Michael Eric Nevin em 06/12/2010

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2010

    5 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2009

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 04/01/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Quem são os diretores de JENWAY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    JAMESTOWN INVESTMENTS LIMITED
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    Secretário
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    43844040001
    NEVIN, Michael Eric
    Suite 1924
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House
    United Kingdom
    Diretor
    Suite 1924
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Partner112409940001
    BASHFORD, Sidney George
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    Secretário
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    British2938770002
    BEAN, Roger James
    10 Highwood Close
    SL7 3PG Marlow
    Buckinghamshire
    Secretário
    10 Highwood Close
    SL7 3PG Marlow
    Buckinghamshire
    British8855620001
    CULSHAW, Alasdair Douglas
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    Secretário
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    BritishDirector5333430001
    FAHY, Michael Jon
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary12938290003
    MORTON, John George
    13 Fermoy Road
    SS1 3HA Southend On Sea
    Essex
    Secretário
    13 Fermoy Road
    SS1 3HA Southend On Sea
    Essex
    BritishFund Accountant45914390002
    SMITH, Eugene Luke
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    Secretário
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    BritishFinance Director55201820001
    BANNISTER, Andrew Charles
    Buckleigh
    Oval Way
    SL9 8QB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    Buckleigh
    Oval Way
    SL9 8QB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director64381410001
    BASHFORD, Sidney George
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    Diretor
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    BritishElectronics Engineer2938770002
    BOYD, Simon John
    The Stables
    Millfarm Black Bourton
    OX18 2PE Bampton
    Oxfordshire
    Diretor
    The Stables
    Millfarm Black Bourton
    OX18 2PE Bampton
    Oxfordshire
    BritishCompany Director59715820002
    CHRISTIE, James Archibald
    Belmont
    2 Plums Lane Bardfield Saling
    CM7 5EH Braintree
    Essex
    Diretor
    Belmont
    2 Plums Lane Bardfield Saling
    CM7 5EH Braintree
    Essex
    BritishManaging Director14773320002
    CULSHAW, Alasdair Douglas
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    Diretor
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    BritishDirector5333430001
    DE FLORIN, Jill Wendy
    Lower Lodge
    Hope End
    HR8 1JG Ledbury
    Herefordshire
    Diretor
    Lower Lodge
    Hope End
    HR8 1JG Ledbury
    Herefordshire
    BritishCompany Director14773310001
    FAHY, Michael Jon
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary12938290003
    FALL, Martyn John
    Slough Farm
    Stambourne
    CO9 4PD Halstead
    Essex
    Diretor
    Slough Farm
    Stambourne
    CO9 4PD Halstead
    Essex
    EnglandBritishManaging Director106960880001
    HART, Paul Clifford
    11 Bulford Lane
    Black Notley
    CM7 8NW Braintree
    Essex
    Diretor
    11 Bulford Lane
    Black Notley
    CM7 8NW Braintree
    Essex
    EnglandBritishManufacturing Director164220500001
    HORSFIELD, Philip
    Woodbine Cottage
    Priest Hutton
    LA6 1JL Carnforth
    Lancashire
    Diretor
    Woodbine Cottage
    Priest Hutton
    LA6 1JL Carnforth
    Lancashire
    BritishFinance Director1842690001
    JONES, Kathryn Ada
    11b Osward Road
    SW17 7SS London
    Diretor
    11b Osward Road
    SW17 7SS London
    United KingdomBritishInvestment Associate117914790001
    MAY, Richard Michael
    Garretts Garretts Lane
    Shalford
    CM7 5BA Braintree
    Essex
    Diretor
    Garretts Garretts Lane
    Shalford
    CM7 5BA Braintree
    Essex
    BritishChairman30835240001
    MAYBURY, Peter Joseph
    Glenburn 13 Riddings Road
    Hale
    WA15 9DS Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    Glenburn 13 Riddings Road
    Hale
    WA15 9DS Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishChief Executive2889740001
    O'CONNOR, Christopher James
    Canterbury House
    191 Huntingdon Road
    CB3 0DL Cambridge
    Cambridgeshire
    Diretor
    Canterbury House
    191 Huntingdon Road
    CB3 0DL Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishManaging Director126446780001
    PARTRIDGE, David John
    Beauchamp House 26 Leam Terrace
    CV31 1BB Leamington Spa
    Warwickshire
    Diretor
    Beauchamp House 26 Leam Terrace
    CV31 1BB Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector3880730002
    PERROTT, Hugh Richard Iliff
    Gilletts Farm Oast
    Water Lane
    TN27 8QB Smarden
    Kent
    Diretor
    Gilletts Farm Oast
    Water Lane
    TN27 8QB Smarden
    Kent
    BritishCompany Director61012290001
    POSSEE, David Rowland
    22 Stubbs Lane
    CM7 3NR Braintree
    Essex
    Diretor
    22 Stubbs Lane
    CM7 3NR Braintree
    Essex
    BritishAccountant77192600001
    RAMPTON, Geoffrey Roy
    Gunn Cottage
    Station Road South Leigh
    OX8 6XJ Witney
    Oxfordshire
    Diretor
    Gunn Cottage
    Station Road South Leigh
    OX8 6XJ Witney
    Oxfordshire
    BritishDirector12413300001
    ROBSON, Adam David
    Floor
    Cayzer House 30 Buckingham Gate
    SW1E 6NN London
    1st
    United Kingdom
    Diretor
    Floor
    Cayzer House 30 Buckingham Gate
    SW1E 6NN London
    1st
    United Kingdom
    EnglandBritishOperating Partner125503850001
    RUTHERFORD, James
    97 High Street
    CB2 5QB Harston
    Cambridgeshire
    Diretor
    97 High Street
    CB2 5QB Harston
    Cambridgeshire
    BritishDirector92778600001
    SMITH, Desmond John
    5 The Rettery
    Hoxne Road
    IT23 7NJ Eye
    Suffolk
    Diretor
    5 The Rettery
    Hoxne Road
    IT23 7NJ Eye
    Suffolk
    BritishDirector57814530001
    SMITH, Eugene Luke
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    Diretor
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director55201820001
    SPINK, Geoffrey
    Fiddlers Green
    Clandon Road, West Clandon
    GU4 7TL Guildford
    Surrey
    Diretor
    Fiddlers Green
    Clandon Road, West Clandon
    GU4 7TL Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector84940730001
    WHEELER, Mervyn James
    43 Nether Court
    CO9 2HN Halstead
    Essex
    Diretor
    43 Nether Court
    CO9 2HN Halstead
    Essex
    BritishSales Director14773330001
    WICKS, Jonathon Neil
    2 Northbrook Copse
    Forest Park
    RG12 0UA Bracknell
    Berkshire
    Diretor
    2 Northbrook Copse
    Forest Park
    RG12 0UA Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director56518060001
    WYNN, Edward Charles
    34 Windmill Lane
    DE6 1EY Ashbourne
    Derbyshire
    Diretor
    34 Windmill Lane
    DE6 1EY Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishSales And Marketing Director60801950001

    JENWAY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of accession
    Criado em 30/11/2007
    Entregue em 08/12/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The mortgaged property means the real property listed in the schedule 2 to the debenture, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 08/12/2007Registro de uma garantia (395)
    • 18/06/2015Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Criado em 19/08/1993
    Entregue em 01/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £19,176.35 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Breve descrição
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 01/09/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed charge over book debts
    Criado em 18/12/1990
    Entregue em 29/12/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement leasing agreement or on any account whatsoever.
    Breve descrição
    The ultimate balance due or owing to the company by tih under any present or future factoring agreement providing for the purchase by tih of book debts of the company. All other book and other debts and claims both present and future. (Please see doc M395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Trade Indemnity -Heller Commercial Financial Limited
    Transações
    • 29/12/1990Registro de uma garantia
    • 13/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 22/11/1990
    Entregue em 26/11/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    The cottage gransmore green, felsted, essex.
    Pessoas com direito
    • Sidney George Bashford
    • Richard Michael May
    Transações
    • 26/11/1990Registro de uma garantia
    • 23/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 24/08/1978
    Entregue em 13/09/1978
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land & factory premises at grasmore green felsted essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank LTD
    Transações
    • 13/09/1978Registro de uma garantia
    • 13/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0