ASPECT VISION CARE

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaASPECT VISION CARE
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada de responsabilidade ilimitada
    Número da empresa 01134463
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ASPECT VISION CARE?

    • outras atividades de fabricação n.e.c. (32990) / Indústrias transformadoras
    • Comércio por grosso não especializado (46900) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

    Onde fica ASPECT VISION CARE?

    Endereço do escritório registrado
    Delta Park, Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Hampshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ASPECT VISION CARE?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    COOPERVISION LIMITED26/03/199926/03/1999
    ASPECT VISION CARE LIMITED27/09/199127/09/1991
    FOCUS CONTACT LENS LABORATORY LIMITED17/09/197317/09/1973

    Quais são as últimas contas de ASPECT VISION CARE?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/10/2007

    Qual é o status da última declaração anual para ASPECT VISION CARE?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para ASPECT VISION CARE?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Alan Edwards como secretário

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 14/09/2013 com lista completa de acionistas

    15 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital11/10/2013

    Estado do capital em 11/10/2013

    • Capital: GBP 7,411,297.061115
    SH01

    Detalhes do secretário alterados para Alan Wayne Edwards em 05/02/2013

    2 páginasCH03

    Declaração anual preparada até 14/09/2012 com lista completa de acionistas

    15 páginasAR01

    Término da nomeação de Juan Aragon como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Michael Francis Wilkinson como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Juan Carlos Aragon como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Gregory Wayne Matz como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Eugene Midlock como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Andrew Sedgwick como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 14/09/2011 com lista completa de acionistas

    15 páginasAR01

    Declaração anual preparada até 14/09/2010 com lista completa de acionistas

    15 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Andrew Nigel Sedgwick em 17/08/2010

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 14/09/2009 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Contas anuais preparadas até 31/10/2007

    11 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Sub diveded 13/07/2008
    RES13

    legacy

    1 páginas225

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    Quem são os diretores de ASPECT VISION CARE?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    KAUFMAN, Carol Rose
    3400 Oakhill Court
    San Mateo
    California
    Usa
    Diretor
    3400 Oakhill Court
    San Mateo
    California
    Usa
    United StatesAmerican80908120001
    MATZ, Gregory Wayne
    White Oak Way
    94949 Novato
    1
    California
    United States Of America
    Diretor
    White Oak Way
    94949 Novato
    1
    California
    United States Of America
    UsaAmerican165444120001
    WILKINSON, Michael Francis
    Hill Pound
    SO32 2UN Swanmore
    Hawthorn Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Hill Pound
    SO32 2UN Swanmore
    Hawthorn Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131404720001
    BUSSEY, Ian Robert
    3 Chapel Court
    SO20 8AD Broughton
    Hampshire
    Secretário
    3 Chapel Court
    SO20 8AD Broughton
    Hampshire
    British124114740001
    EDWARDS, Alan Wayne
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretário
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    British136806120001
    EDWARDS, Alan Wayne
    Apartment 33
    23 Hulse Road
    SO15 2QZ Southampton
    Hampshire
    Secretário
    Apartment 33
    23 Hulse Road
    SO15 2QZ Southampton
    Hampshire
    British63648340002
    GALLEY, Anthony David
    Beacon Wey The Hangers
    Bishops Waltham
    SO32 1FZ Southampton
    Hampshire
    Secretário
    Beacon Wey The Hangers
    Bishops Waltham
    SO32 1FZ Southampton
    Hampshire
    British16170510004
    HENDERSON, James Peter
    Flat 2
    Mirage, 33 Shore Road
    BH13 7PJ Poole
    Dorset
    Secretário
    Flat 2
    Mirage, 33 Shore Road
    BH13 7PJ Poole
    Dorset
    British108797680003
    ARAGON, Juan Carlos
    Alma Avenue #202
    Walnut Creek
    1800
    California 94596
    United States Of America
    Diretor
    Alma Avenue #202
    Walnut Creek
    1800
    California 94596
    United States Of America
    United States Of AmericaAmerican165443000001
    BEVIS, Barrie
    53 Wilderness Heights
    West End
    SO18 3PS Southampton
    Hampshire
    Diretor
    53 Wilderness Heights
    West End
    SO18 3PS Southampton
    Hampshire
    British41012560001
    BROOKER, Wilfred Trevor
    Grimbles Barn
    Buckland Village
    HP22 5HY Aston Clinton
    Buckinghamshire
    Diretor
    Grimbles Barn
    Buckland Village
    HP22 5HY Aston Clinton
    Buckinghamshire
    British19394670001
    BUSSEY, Ian Robert
    3 Chapel Court
    SO20 8AD Broughton
    Hampshire
    Diretor
    3 Chapel Court
    SO20 8AD Broughton
    Hampshire
    United KingdomBritish124114740001
    CARROLL, Glenn Anthony John
    34 Spitfire Way
    Hamble
    SO31 4RT Southampton
    Hampshire
    Diretor
    34 Spitfire Way
    Hamble
    SO31 4RT Southampton
    Hampshire
    British74851390003
    DE CARLE, John Trevor
    Lowicks House Sandy Lane
    Tilford
    GU10 2EX Farnham
    Surrey
    Diretor
    Lowicks House Sandy Lane
    Tilford
    GU10 2EX Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish25107730001
    EDWARDS, Alan Wayne
    Apartment 33
    23 Hulse Road
    SO15 2QZ Southampton
    Hampshire
    Diretor
    Apartment 33
    23 Hulse Road
    SO15 2QZ Southampton
    Hampshire
    British63648340002
    FRYLING, Gregory Alan
    29802 High View Circle
    San Juan Capistrano
    FOREIGN California
    92675
    Usa
    Diretor
    29802 High View Circle
    San Juan Capistrano
    FOREIGN California
    92675
    Usa
    American55962330001
    GALLEY, Anthony David
    Summer Lodge
    The Coach Road, West Tytherley
    SP5 1LB Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Summer Lodge
    The Coach Road, West Tytherley
    SP5 1LB Salisbury
    Wiltshire
    British16170510006
    GALLEY, Geoffrey Harrison
    Red Lodge The Close
    Totteridge
    N20 8PJ London
    Diretor
    Red Lodge The Close
    Totteridge
    N20 8PJ London
    United KingdomBritish13521740001
    HENDERSON, James Peter
    Flat 2
    Mirage, 33 Shore Road
    BH13 7PJ Poole
    Dorset
    Diretor
    Flat 2
    Mirage, 33 Shore Road
    BH13 7PJ Poole
    Dorset
    British108797680003
    MCDERMOTT, Ian Arthur
    North View 75 Upper Barn Copse
    Fair Oak
    SO50 8DB Eastleigh
    Hampshire
    Diretor
    North View 75 Upper Barn Copse
    Fair Oak
    SO50 8DB Eastleigh
    Hampshire
    British62576510001
    MIDLOCK, Eugene Joseph
    Campbell Avenue
    CA 94024 Los Altos
    999
    California
    United States Of America
    Diretor
    Campbell Avenue
    CA 94024 Los Altos
    999
    California
    United States Of America
    Other128896780001
    NEIL, Steven Mead
    26343 Esperanza Drive
    Los Altos Hills
    California
    Ca 94022
    United States Of America
    Diretor
    26343 Esperanza Drive
    Los Altos Hills
    California
    Ca 94022
    United States Of America
    United States Of AmericaUnited States108650690001
    SEDGWICK, Andrew Nigel
    Garrison Hill
    Droxford
    SO32 3QL Southampton
    The Crest
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Garrison Hill
    Droxford
    SO32 3QL Southampton
    The Crest
    Hampshire
    United Kingdom
    British103237160003
    WEISS, Robert Stephen
    1775 Spumante Place
    Pleasanton
    California Ca 94566
    Usa
    Diretor
    1775 Spumante Place
    Pleasanton
    California Ca 94566
    Usa
    American86354710001
    WYATT, Simon David
    14 Bleriot Crescent
    Whiteley
    PO15 7JD Fareham
    Hampshire
    Diretor
    14 Bleriot Crescent
    Whiteley
    PO15 7JD Fareham
    Hampshire
    British76917880001

    ASPECT VISION CARE possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 01/05/2002
    Entregue em 14/05/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any of the UK borrowers or any of the UK guarantors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Keybank National Association (As Security Trustee)
    Transações
    • 14/05/2002Registro de uma garantia (395)
    • 18/01/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 16/06/1997
    Entregue em 01/07/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property known as land lying to the south of hamble lane hamble hampshire t/n-HP359537.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 01/07/1997Registro de uma garantia (395)
    • 29/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 27/09/1996
    Entregue em 16/10/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £300,000 (the defered payment) due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement of even date
    Breve descrição
    F/H land at south point industrial park ensign way hamble k/a unit 2 ensign way and adjoining land.
    Pessoas com direito
    • Arc Property Developments Limited
    Transações
    • 16/10/1996Registro de uma garantia (395)
    • 20/02/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 27/09/1996
    Entregue em 04/10/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a unit 2 southpoint hamble southampton hampshire part t/no.HP516344 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/10/1996Registro de uma garantia (395)
    • 29/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed equitable charge
    Criado em 02/09/1994
    Entregue em 09/09/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation (receivables) the subject of a factoring agreement, all title property right or interest in any goods & all guarantees indemnities insurances or securities. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Griffin Factors Limited
    Transações
    • 09/09/1994Registro de uma garantia (395)
    • 31/03/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Criado em 19/07/1994
    Entregue em 08/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The due performance and observance of the covenants,agreements and conditions from the company to the chargee under the lease
    Breve descrição
    £13,000 in an account in the name of baker & mckenzie of 100 new bridge st,london EC4V 6JA pursuant to the rent deposit deed.
    Pessoas com direito
    • Arc Properties Developments Limited
    Transações
    • 08/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 19/11/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 29/10/1991
    Entregue em 31/10/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All book debts and benefits thereto.
    Pessoas com direito
    • Maddox Factoring (UK) Limited
    Transações
    • 31/10/1991Registro de uma garantia
    • 05/06/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 28/06/1989
    Entregue em 05/07/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Legal mortgage over unit b northbridge road berkhamsted herts t/n hd 133568 and/or proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 05/07/1989Registro de uma garantia
    • 29/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 02/11/1988
    Entregue em 04/11/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £112,226.77 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of a the charge.
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Geoffrey Harrison Galley
    Transações
    • 04/11/1988Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 08/12/1982
    Entregue em 16/12/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/12/1982Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 27/04/1981
    Entregue em 06/05/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All book debts and other debts now and from time to time due owing or incurred to the company.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 06/05/1981Registro de uma garantia
    Mortgage
    Criado em 04/08/1980
    Entregue em 08/08/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land & premises unit b nathbridge road beckhamsted herts together with fixtures whatsoever.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 08/08/1980Registro de uma garantia
    Floating charge
    Criado em 07/03/1980
    Entregue em 14/03/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A floating charge over the undertaking and all property and assets presen t and future including book debts uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 14/03/1980Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0