LOGICA IT SERVICES UK LIMITED

LOGICA IT SERVICES UK LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaLOGICA IT SERVICES UK LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01137188
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de LOGICA IT SERVICES UK LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica LOGICA IT SERVICES UK LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    250 Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de LOGICA IT SERVICES UK LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CMG UK LIMITED07/05/199607/05/1996
    CMG COMPUTER MANAGEMENT GROUP (UK) LIMITED14/12/199214/12/1992
    C.M.G. COMPUTER MANAGEMENT GROUP (UK) LIMITED01/10/197301/10/1973

    Quais são as últimas contas de LOGICA IT SERVICES UK LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2012

    Qual é o status da última declaração anual para LOGICA IT SERVICES UK LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para LOGICA IT SERVICES UK LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 23/05/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/06/2014

    Estado do capital em 18/06/2014

    • Capital: GBP 4,962,118
    SH01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2012

    21 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr. Timothy Walter Gregory em 24/07/2013

    3 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 23/05/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 30/06/2012 para 30/09/2012

    1 páginasAA01

    Nomeação de Mr. Timothy Walter Gregory como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr. Faris Mehdi Kadhim Mohammed como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Gavin Griggs como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Janathan Kay como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Robert David Anderson como diretor

    3 páginasAP01

    Diversos

    Statement under section 519 companies act 2006
    4 páginasMISC

    Nomeação de Janathan Walton Kay como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de William Floydd como diretor

    2 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 23/05/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2011

    26 páginasAA

    Término da nomeação de Logica International Limited como secretário

    2 páginasTM02

    Nomeação de Logica Cosec Limited como secretário

    3 páginasAP04

    Término da nomeação de Seamus Keating como diretor

    2 páginasTM01

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Resoluções

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01
    capital

    Resoluções

    Authorise in accordance with 175(5)a 05/10/2011
    RES13
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Detalhes do diretor alterados para Mr Seamus Keating em 04/07/2011

    3 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 23/05/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Quem são os diretores de LOGICA IT SERVICES UK LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LOGICA COSEC LIMITED
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United Kingdom
    Secretário
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro7745327
    165432230001
    ANDERSON, Robert David, Mr.
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    CanadaCanadian122988350004
    GREGORY, Timothy Walter
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish149429760002
    MOHAMMED, Faris Mehdi Kadhim
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish67645590001
    BENNETT, Judith Margaret
    4 Cornwall Grove
    Chiswick
    W4 2LB London
    Secretário
    4 Cornwall Grove
    Chiswick
    W4 2LB London
    British25441620001
    FRANCIS, Richard John
    7 Kinderscout
    HP3 8HW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretário
    7 Kinderscout
    HP3 8HW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British67742720001
    HORSLEY, Terence Edward
    29 Kelso Close
    Worth
    RH10 7XH Crawley
    West Sussex
    Secretário
    29 Kelso Close
    Worth
    RH10 7XH Crawley
    West Sussex
    British527880001
    LOGICA INTERNATIONAL LIMITED
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United Kingdom
    Secretário
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro1237299
    45193120003
    BAILEY, David Christopher
    Auryn
    Wilderness Road
    RH8 9HS Oxted
    Surrey
    Diretor
    Auryn
    Wilderness Road
    RH8 9HS Oxted
    Surrey
    EnglandBritish65594700001
    BYERS, David
    17 Kenilworth Gardens
    Shooters Hill
    SE18 3JB London
    Diretor
    17 Kenilworth Gardens
    Shooters Hill
    SE18 3JB London
    British11411240001
    CLACK, Michael
    Flat 6
    1 Nile Street
    N1 7LX London
    Diretor
    Flat 6
    1 Nile Street
    N1 7LX London
    British75153470001
    CLARKE, John Anthony
    1 Melville Avenue
    CR2 7HZ South Croydon
    Surrey
    Diretor
    1 Melville Avenue
    CR2 7HZ South Croydon
    Surrey
    British39262140001
    CLARKE, John Anthony
    1 Melville Avenue
    CR2 7HZ South Croydon
    Surrey
    Diretor
    1 Melville Avenue
    CR2 7HZ South Croydon
    Surrey
    British39262140001
    DOWNIE, Andrew Richard
    Mimosa House
    Hook Hill Lane Hook Heath
    GU22 0QB Woking
    Surrey
    Diretor
    Mimosa House
    Hook Hill Lane Hook Heath
    GU22 0QB Woking
    Surrey
    British91632650001
    FLOYDD, William James Spencer
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United KingdomBritish179831560001
    FLOYDD, William
    27 Dagden Road
    GU4 8DD Shalford
    Surrey
    Diretor
    27 Dagden Road
    GU4 8DD Shalford
    Surrey
    British101702410001
    FOLL, Paul Jonathan
    18
    Ray Park Avenue
    SL6 8DS Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    18
    Ray Park Avenue
    SL6 8DS Maidenhead
    Berkshire
    British2551750002
    GRIGGS, Gavin Peter
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish154536120001
    HAMMILL, George
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    Diretor
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    British76504500001
    HARRISON, Christopher Charles
    The Barn 70 Leaves Green Road
    BR2 6DQ Keston
    Kent
    Diretor
    The Barn 70 Leaves Green Road
    BR2 6DQ Keston
    Kent
    British11411250002
    HENNESSY, Christopher Brian
    8 Westbury Court
    73 Park Road
    BR3 2DN Beckenham
    Kent
    England
    Diretor
    8 Westbury Court
    73 Park Road
    BR3 2DN Beckenham
    Kent
    England
    British77506730001
    KAY, Janathan Walton
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United KingdomBritish171334020001
    KEATING, Seamus Declan
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United KingdomIrish67763120002
    MACKAY, Thomas Owen
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United KingdomBritish125924240001
    MADIGAN, Peter Lewis
    9 Ardshiel Drive
    Pendleton Road
    RH1 6QN Redhill
    Surrey
    Diretor
    9 Ardshiel Drive
    Pendleton Road
    RH1 6QN Redhill
    Surrey
    British69670680001
    MCKENNA, James Anthony Patrick
    86 Monkton Farleigh
    BA15 2QJ Bradford-On-Avon
    Petersfield
    Wiltshire
    Diretor
    86 Monkton Farleigh
    BA15 2QJ Bradford-On-Avon
    Petersfield
    Wiltshire
    EnglandBritish131332620001
    NEVILLE, Geoffrey Leslie
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    Diretor
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    United KingdomBritish39989270002
    PATON, Daryl Marc
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    Diretor
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    EnglandBritish104564540001
    RADLEY, Kevin John
    47 Norsey Road
    CM11 1BG Billericay
    Essex
    Diretor
    47 Norsey Road
    CM11 1BG Billericay
    Essex
    EnglandBritish74685410001
    RIOCH, John Francis
    18 Abbotts Green
    Addington
    CR0 5BH Croydon
    Surrey
    Diretor
    18 Abbotts Green
    Addington
    CR0 5BH Croydon
    Surrey
    British1265260001
    SCOTT, Stephen
    Bickleigh Ridge
    Yew Gate Love Lane
    RG14 2JG Donnington Newbury
    West Berkshire
    Diretor
    Bickleigh Ridge
    Yew Gate Love Lane
    RG14 2JG Donnington Newbury
    West Berkshire
    United KingdomBritish79564910002
    SEQUEIRA, Denzyl Joseph
    23 The Heath
    CR3 5DJ Chaldon
    Surrey
    England
    Diretor
    23 The Heath
    CR3 5DJ Chaldon
    Surrey
    England
    British34933360001
    TAYLOR, Ian
    Hoddington
    RG25 2RT Upton Gray
    Keepers House
    Hampshire
    Diretor
    Hoddington
    RG25 2RT Upton Gray
    Keepers House
    Hampshire
    EnglandBritish94373040008
    WALTERS, Brian Michael
    8 The Hollow
    Lindfield
    RH16 2SX Haywards Heath
    West Sussex
    Diretor
    8 The Hollow
    Lindfield
    RH16 2SX Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish75835450001
    WEAVER, Paul
    Brookside
    CM11 1DT Billericay
    36
    Essex
    Diretor
    Brookside
    CM11 1DT Billericay
    36
    Essex
    United KingdomBritish45193280002

    LOGICA IT SERVICES UK LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deposit agreement
    Criado em 24/02/1998
    Entregue em 06/03/1998
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The deposit of £5,653,765 on account number 4500 074007 510 together with interest thereon.
    Pessoas com direito
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transações
    • 06/03/1998Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 06/01/1993
    Entregue em 19/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Clydesdale Bank PLC
    Transações
    • 19/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 07/06/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 23/02/1982
    Entregue em 04/03/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts & uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transações
    • 04/03/1982Registro de uma garantia
    • 21/10/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0