PNEUPAC LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | PNEUPAC LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01148992 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de PNEUPAC LIMITED?
- usinagem (25620) / Indústrias transformadoras
Onde fica PNEUPAC LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 1500 Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford Kent |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de PNEUPAC LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
SIMS PNEUPAC LIMITED | 17/11/1997 | 17/11/1997 |
PNEUPAC LIMITED | 03/12/1973 | 03/12/1973 |
Quais são as últimas contas de PNEUPAC LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/07/2021 |
Quais são as últimas submissões para PNEUPAC LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 5 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Estado do capital em 19/04/2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de Deloitte Llp 2 New Street Square London EC4A 3BZ United Kingdom para Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/07/2021 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Brian Bonnell como diretor em 25/01/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Ramon De Ridder como diretor em 25/01/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Cornelis De Rooij como diretor em 25/01/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Miss Jasmine Annabelle Cleaver como secretário em 30/09/2021 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Joanne Ede como secretário em 30/09/2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/07/2020 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de Eversheds Llp, Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES England para Deloitte Llp 2 New Street Square London EC4A 3BZ | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/07/2019 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/07/2018 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de PNEUPAC LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEAVER, Jasmine Annabelle | Secretário | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent | 288430580001 | |||||||
BARK, Nigel John | Diretor | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 United Kingdom | United Kingdom | British | Vice President Sales, Emea | 170963820001 | ||||
BONNELL, Brian | Diretor | Calle Amanecer San Clemente 951 California United States | United States | American | Businessman | 291877250001 | ||||
DE RIDDER, Ramon | Diretor | Hofspoor 3994 Vz Houten 3 Netherlands | Netherlands | Dutch | Business Executive | 291361500001 | ||||
DE ROOIJ, Cornelis | Diretor | Hofspoor 3994 Vz Houten 3 Netherlands | Netherlands | Dutch | Business Executive | 291876980001 | ||||
JONES, Louis Philip | Diretor | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 United Kingdom | England | British | Finance Director | 209239660001 | ||||
BENNETT, Roisin | Secretário | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent United Kingdom | Other | 137268090001 | ||||||
BURDETT, Neil Robert | Secretário | 765 Finchley Road NW11 8DS London | British | 188620003 | ||||||
CARTER, Brian Sydney | Secretário | 17 Exenden Park Drive CT6 8UB Herne Bay Kent | British | 4836800001 | ||||||
EDE, Joanne | Secretário | 1500 Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford Smiths Medical International Limited Kent United Kingdom | 203676310001 | |||||||
KENTISH, Barry | Secretário | 3 Derwent Drive LU6 3PB Dunstable Bedfordshire | British | Accountant | 33208630001 | |||||
SMITH, Alan | Secretário | 37 Pattison Road NW2 2HL London | British | 32394380001 | ||||||
BATTERSBY, Paul | Diretor | 7 Botany Close BN16 2BH Rustington West Sussex | British | Director | 32410170002 | |||||
BENNETT, Roisin | Diretor | WD24 4LG Watford Colonial Way Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Secretary | 150353170001 | ||||
BROAD, Donald Andrew Robertson | Diretor | Floor Cardinal Place 80 Victoria Street SW1E 5JL London 2nd | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 46824520004 | ||||
CARLISLE, Malcolm John Calder Glen | Diretor | 1 Jessica Road SW18 2QL London | United Kingdom | British | Barrister | 21835030001 | ||||
DAVEY-TURNER, Geoffrey Edward | Diretor | The Manor House OX17 2BB Culworth Northants | British | Engineer | 4836820001 | |||||
DUNSMORE, Alan David | Diretor | The Studio House 113 Bridge Street Wye TN25 5ED Ashford Kent | British | Chartered Accountant | 57416420002 | |||||
EGGLESTON, Steven Andrew | Diretor | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 150302530002 | ||||
FLACK, Paul Anthony | Diretor | 4 Wellington House 51 Seabrook Road CT21 5QB Hythe Kent | British | Director | 26551520002 | |||||
HARDY, Suzanne Ruth | Diretor | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 United Kingdom | England | British | Finance Director | 171577960001 | ||||
IRELAND, Robert | Diretor | Waverley Southview Road GU35 8HX Headley Down Hampshire | England | British | Director | 88177570001 | ||||
JAMIESON, Martin Clive | Diretor | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent Uk | British | Director | 42951230008 | |||||
JAYNE, Kimberley Anne | Diretor | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent | United Kingdom | British | Sales Director | 228156580001 | ||||
JONES, Norman Stewart | Diretor | 46 Station Road Ivinghoe LU7 9EB Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Engineer | 4836830001 | |||||
KENNEDY, George Macdonald | Diretor | Deepwell House Maidstone Road, Chilham CT4 8DB Canterbury Kent | England | British | Director | 14451190006 | ||||
KOCKOTT, John Douglas | Diretor | Oaktree Barn Brookley Farm Sway Road SO42 7RX Brockenhurst Hampshire | South African | Director | 29991160001 | |||||
O'BRIEN, Susan Lynn | Diretor | 180 Longfield Lane Cheshunt EN7 6AQ Waltham Cross Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 123851410001 | |||||
PENN, David Alfred | Diretor | 2 Salmons Lane Middleton Cheney OX17 2NF Banbury Oxon | England | British | Chartered Secretary | 64115230001 | ||||
SASSONE, Matthew Giovanni | Diretor | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 156019710001 | ||||
SIMPSON, Jeremy John Cobbett | Diretor | 765 Finchley Road NW11 8DS London | British | Chartered Accountant | 83467360003 | |||||
SPEAKMAN, Michael James | Diretor | HP13 | United Kingdom | British | Accountant | 88515760001 | ||||
SURCH, Christopher | Diretor | 765 Finchley Road NW11 8DS London | British | Finance Director | 97578250002 | |||||
WEISS, George | Diretor | 40 New End Square NW3 1LS London | British | Engineer | 4836810002 | |||||
WHITE, Robert | Diretor | Zircon Lane North 55447 Plymouth 3105 Minnesota | British | Vp Finance | 139191600001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de PNEUPAC LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiths Medical International Limited | 06/04/2016 | Eureka Park Lower Pemberton TN25 4BF Ashford 1500 Kent United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
PNEUPAC LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Criado em 21/05/1996 Entregue em 29/05/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed | Criado em 24/08/1981 Entregue em 25/08/1981 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with fixed parts machinery and fixtures incl trade fixtures. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Further guarantee & debenture | Criado em 28/03/1977 Entregue em 15/04/1977 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee and debenture | Criado em 19/12/1974 Entregue em 02/01/1975 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição By way of first fixed and floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Fixtures fixed plant and machinery. (See doc 8). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Single debenture | Criado em 09/09/1974 Entregue em 16/09/1974 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição By way of a floating charge tog with plant machinery fixtures implements and utensils. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0