PNEUPAC LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPNEUPAC LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01148992
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PNEUPAC LIMITED?

    • usinagem (25620) / Indústrias transformadoras

    Onde fica PNEUPAC LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1500 Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    Kent
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PNEUPAC LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SIMS PNEUPAC LIMITED17/11/199717/11/1997
    PNEUPAC LIMITED03/12/197303/12/1973

    Quais são as últimas contas de PNEUPAC LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/07/2021

    Quais são as últimas submissões para PNEUPAC LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    4 páginasDS01

    Satisfação total da garantia 5

    2 páginasMR04

    Estado do capital em 19/04/2023

    • Capital: GBP 0.50
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF

    1 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Deloitte Llp 2 New Street Square London EC4A 3BZ United Kingdom para Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF

    1 páginasAD02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/07/2021

    3 páginasAA

    Nomeação de Brian Bonnell como diretor em 25/01/2022

    2 páginasAP01

    Nomeação de Ramon De Ridder como diretor em 25/01/2022

    2 páginasAP01

    Nomeação de Cornelis De Rooij como diretor em 25/01/2022

    2 páginasAP01

    Nomeação de Miss Jasmine Annabelle Cleaver como secretário em 30/09/2021

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Joanne Ede como secretário em 30/09/2021

    1 páginasTM02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/07/2020

    3 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Eversheds Llp, Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES England para Deloitte Llp 2 New Street Square London EC4A 3BZ

    1 páginasAD02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/07/2019

    3 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/07/2018

    3 páginasAA

    Quem são os diretores de PNEUPAC LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CLEAVER, Jasmine Annabelle
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    Secretário
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    288430580001
    BARK, Nigel John
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    Diretor
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    United KingdomBritishVice President Sales, Emea170963820001
    BONNELL, Brian
    Calle Amanecer
    San Clemente
    951
    California
    United States
    Diretor
    Calle Amanecer
    San Clemente
    951
    California
    United States
    United StatesAmericanBusinessman291877250001
    DE RIDDER, Ramon
    Hofspoor
    3994 Vz
    Houten
    3
    Netherlands
    Diretor
    Hofspoor
    3994 Vz
    Houten
    3
    Netherlands
    NetherlandsDutchBusiness Executive291361500001
    DE ROOIJ, Cornelis
    Hofspoor
    3994 Vz
    Houten
    3
    Netherlands
    Diretor
    Hofspoor
    3994 Vz
    Houten
    3
    Netherlands
    NetherlandsDutchBusiness Executive291876980001
    JONES, Louis Philip
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    Diretor
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director209239660001
    BENNETT, Roisin
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Secretário
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Other137268090001
    BURDETT, Neil Robert
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    Secretário
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    British188620003
    CARTER, Brian Sydney
    17 Exenden Park Drive
    CT6 8UB Herne Bay
    Kent
    Secretário
    17 Exenden Park Drive
    CT6 8UB Herne Bay
    Kent
    British4836800001
    EDE, Joanne
    1500 Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    Smiths Medical International Limited
    Kent
    United Kingdom
    Secretário
    1500 Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    Smiths Medical International Limited
    Kent
    United Kingdom
    203676310001
    KENTISH, Barry
    3 Derwent Drive
    LU6 3PB Dunstable
    Bedfordshire
    Secretário
    3 Derwent Drive
    LU6 3PB Dunstable
    Bedfordshire
    BritishAccountant33208630001
    SMITH, Alan
    37 Pattison Road
    NW2 2HL London
    Secretário
    37 Pattison Road
    NW2 2HL London
    British32394380001
    BATTERSBY, Paul
    7 Botany Close
    BN16 2BH Rustington
    West Sussex
    Diretor
    7 Botany Close
    BN16 2BH Rustington
    West Sussex
    BritishDirector32410170002
    BENNETT, Roisin
    WD24 4LG Watford
    Colonial Way
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    WD24 4LG Watford
    Colonial Way
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSecretary150353170001
    BROAD, Donald Andrew Robertson
    Floor
    Cardinal Place 80 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    2nd
    Diretor
    Floor
    Cardinal Place 80 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    2nd
    United KingdomBritishChartered Accountant46824520004
    CARLISLE, Malcolm John Calder Glen
    1 Jessica Road
    SW18 2QL London
    Diretor
    1 Jessica Road
    SW18 2QL London
    United KingdomBritishBarrister21835030001
    DAVEY-TURNER, Geoffrey Edward
    The Manor House
    OX17 2BB Culworth
    Northants
    Diretor
    The Manor House
    OX17 2BB Culworth
    Northants
    BritishEngineer4836820001
    DUNSMORE, Alan David
    The Studio House 113 Bridge Street
    Wye
    TN25 5ED Ashford
    Kent
    Diretor
    The Studio House 113 Bridge Street
    Wye
    TN25 5ED Ashford
    Kent
    BritishChartered Accountant57416420002
    EGGLESTON, Steven Andrew
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director150302530002
    FLACK, Paul Anthony
    4 Wellington House
    51 Seabrook Road
    CT21 5QB Hythe
    Kent
    Diretor
    4 Wellington House
    51 Seabrook Road
    CT21 5QB Hythe
    Kent
    BritishDirector26551520002
    HARDY, Suzanne Ruth
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    Diretor
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director171577960001
    IRELAND, Robert
    Waverley
    Southview Road
    GU35 8HX Headley Down
    Hampshire
    Diretor
    Waverley
    Southview Road
    GU35 8HX Headley Down
    Hampshire
    EnglandBritishDirector88177570001
    JAMIESON, Martin Clive
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    Uk
    Diretor
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    Uk
    BritishDirector42951230008
    JAYNE, Kimberley Anne
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    Diretor
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United KingdomBritishSales Director228156580001
    JONES, Norman Stewart
    46 Station Road
    Ivinghoe
    LU7 9EB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Diretor
    46 Station Road
    Ivinghoe
    LU7 9EB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishEngineer4836830001
    KENNEDY, George Macdonald
    Deepwell House
    Maidstone Road, Chilham
    CT4 8DB Canterbury
    Kent
    Diretor
    Deepwell House
    Maidstone Road, Chilham
    CT4 8DB Canterbury
    Kent
    EnglandBritishDirector14451190006
    KOCKOTT, John Douglas
    Oaktree Barn Brookley Farm
    Sway Road
    SO42 7RX Brockenhurst
    Hampshire
    Diretor
    Oaktree Barn Brookley Farm
    Sway Road
    SO42 7RX Brockenhurst
    Hampshire
    South AfricanDirector29991160001
    O'BRIEN, Susan Lynn
    180 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    Diretor
    180 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant123851410001
    PENN, David Alfred
    2 Salmons Lane
    Middleton Cheney
    OX17 2NF Banbury
    Oxon
    Diretor
    2 Salmons Lane
    Middleton Cheney
    OX17 2NF Banbury
    Oxon
    EnglandBritishChartered Secretary64115230001
    SASSONE, Matthew Giovanni
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director156019710001
    SIMPSON, Jeremy John Cobbett
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    Diretor
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    BritishChartered Accountant83467360003
    SPEAKMAN, Michael James
    HP13
    Diretor
    HP13
    United KingdomBritishAccountant88515760001
    SURCH, Christopher
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    Diretor
    765 Finchley Road
    NW11 8DS London
    BritishFinance Director97578250002
    WEISS, George
    40 New End Square
    NW3 1LS London
    Diretor
    40 New End Square
    NW3 1LS London
    BritishEngineer4836810002
    WHITE, Robert
    Zircon Lane North
    55447 Plymouth
    3105
    Minnesota
    Diretor
    Zircon Lane North
    55447 Plymouth
    3105
    Minnesota
    BritishVp Finance139191600001

    Quem são as pessoas com controle significativo de PNEUPAC LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    06/04/2016
    Eureka Park
    Lower Pemberton
    TN25 4BF Ashford
    1500
    Kent
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro00362847
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    PNEUPAC LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage debenture
    Criado em 21/05/1996
    Entregue em 29/05/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/05/1996Registro de uma garantia (395)
    • 20/04/2023Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed
    Criado em 24/08/1981
    Entregue em 25/08/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with fixed parts machinery and fixtures incl trade fixtures.
    Pessoas com direito
    • Instruments & Movements Limited
    Transações
    • 25/08/1981Registro de uma garantia
    • 10/10/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Criado em 28/03/1977
    Entregue em 15/04/1977
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 15/04/1977Registro de uma garantia
    • 24/06/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 19/12/1974
    Entregue em 02/01/1975
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of first fixed and floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Fixtures fixed plant and machinery. (See doc 8).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 02/01/1975Registro de uma garantia
    • 10/12/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 09/09/1974
    Entregue em 16/09/1974
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of a floating charge tog with plant machinery fixtures implements and utensils. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 16/09/1974Registro de uma garantia
    • 24/06/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0