IMPACT MARCOM LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaIMPACT MARCOM LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01166286
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de IMPACT MARCOM LTD?

    • Outras atividades profissionais, científicas e técnicas n.e.c. (74909) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica IMPACT MARCOM LTD?

    Endereço do escritório registrado
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de IMPACT MARCOM LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MAR-COM SYSTEMS LIMITED03/05/198503/05/1985
    VISUAL MAR-COM SYSTEMS LIMITED31/12/197631/12/1976
    COPYWRITE METHODS LIMITED09/04/197409/04/1974

    Quais são as últimas contas de IMPACT MARCOM LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2017

    Quais são as últimas submissões para IMPACT MARCOM LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 02/05/2019

    11 páginasLIQ03

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    11 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de Europe House 170 Windmill Road West Sunbury on Thames Middlesex TW16 7HB para 55 Baker Street London W1U 7EU em 22/08/2018

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 02/08/2018

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 25/06/2018

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Satisfação total da garantia 7

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 011662860009

    1 páginasMR04

    Contas anuais preparadas até 30/06/2017

    21 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 03/09/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2016

    21 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 03/09/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2015

    18 páginasAA

    Declaração anual preparada até 03/09/2015 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital17/09/2015

    Estado do capital em 17/09/2015

    • Capital: GBP 667,000
    SH01

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Registo da garantia 011662860009, criada em 24/03/2015

    55 páginasMR01

    Satisfação total da garantia 8

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    1 páginasMR04

    Contas anuais preparadas até 30/06/2014

    20 páginasAA

    Declaração anual preparada até 03/09/2014 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital19/09/2014

    Estado do capital em 19/09/2014

    • Capital: GBP 667,000
    SH01

    Quem são os diretores de IMPACT MARCOM LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ALLEN, John
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Diretor
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish182527790001
    COOK, Edward Charles Peregrine Phelps
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Diretor
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish52906920005
    KENNEDY, Ewan Campbell
    Flat 11 Crawley Rise
    18 Portsmouth Road
    GU15 1JX Camberley
    Surrey
    Secretário
    Flat 11 Crawley Rise
    18 Portsmouth Road
    GU15 1JX Camberley
    Surrey
    British33639840003
    PORTER, Simon Neil
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Secretário
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    British174403180001
    SEYMOUR, Barry James
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    Secretário
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    British1306660001
    STEWARD, Charles David
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    Secretário
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    British103109350002
    ALLIN, John Leslie
    5 Elmbrook Vale
    RG11 Wokingham
    Berkshire
    Diretor
    5 Elmbrook Vale
    RG11 Wokingham
    Berkshire
    British16272300001
    AZAM, Mohammed
    Jenner Way
    KT19 7LJ Epsom
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Jenner Way
    KT19 7LJ Epsom
    3
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish135689290001
    BRAY, Myles Edward James
    Woodmancott
    SO21 3BN Winchester
    Woodmancott House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Woodmancott
    SO21 3BN Winchester
    Woodmancott House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135690640001
    CAUSEVIC, Fredd
    Bekkestua 9a
    Bekkestua
    N-1357
    Norway
    Diretor
    Bekkestua 9a
    Bekkestua
    N-1357
    Norway
    NorwayNorwegian75177110001
    DEMPSTER, Brian Leigh Harding
    14 Nutfield Gardens
    UB5 6LT Northolt
    Middlesex
    Diretor
    14 Nutfield Gardens
    UB5 6LT Northolt
    Middlesex
    British16272310001
    ELLIS, Kenneth Leonard
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Diretor
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandBritish149204440001
    GORTON, Robert David
    55 Redhill Wood
    New Ash Green
    DA3 8QP Longfield
    Kent
    Diretor
    55 Redhill Wood
    New Ash Green
    DA3 8QP Longfield
    Kent
    EnglandBritish28341780002
    HUDSON, Mark Alan
    Crawshay Drive
    Emmer Green
    RG4 8SY Reading
    58
    England
    Diretor
    Crawshay Drive
    Emmer Green
    RG4 8SY Reading
    58
    England
    EnglandBritish180576890001
    JEWITT, Anthony John
    13 Pelling Hill
    Old Windsor
    SL4 2LL Windsor
    Berkshire
    Diretor
    13 Pelling Hill
    Old Windsor
    SL4 2LL Windsor
    Berkshire
    British785310001
    KENNEDY, Ewan Campbell
    Braybourne House
    Crawley Ridge
    GU15 2AD Camberley
    Surrey
    Diretor
    Braybourne House
    Crawley Ridge
    GU15 2AD Camberley
    Surrey
    British33639840004
    MORAN, Michael Owen
    Australind The Street
    West Clandon
    GU4 7TE Guildford
    Surrey
    Diretor
    Australind The Street
    West Clandon
    GU4 7TE Guildford
    Surrey
    British1306650001
    PHILLIPS, Julian Brian
    Oakwood
    15 Oxted Green, Milford
    GU8 5D Godalming
    Surrey
    Diretor
    Oakwood
    15 Oxted Green, Milford
    GU8 5D Godalming
    Surrey
    EnglandBritish122795570002
    PORTER, Simon Neil
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Diretor
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandUnited Kingdom55262300006
    RAWLINGS, Timothy Paul
    11 Lulworth Road
    DA16 3LQ Welling
    Kent
    Diretor
    11 Lulworth Road
    DA16 3LQ Welling
    Kent
    British20665210002
    ROBINSON, Mark Laurence
    43 Worminghall Road
    Ickford
    HP18 9JB Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    43 Worminghall Road
    Ickford
    HP18 9JB Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish43184090002
    SEYMOUR, Barry James
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    Diretor
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    EnglandBritish1306660001
    SMITH, John
    Allenwood
    161 London Road
    CM7 8PT Braintree
    Essex
    Diretor
    Allenwood
    161 London Road
    CM7 8PT Braintree
    Essex
    British66391760001
    STEWARD, Charles David
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    Diretor
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish103109350002
    TITLER, Alec
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    Diretor
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    EnglandBritish48506930001
    TITLER, Alec
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    Diretor
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    EnglandBritish48506930001

    Quem são as pessoas com controle significativo de IMPACT MARCOM LTD?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    England
    06/04/2016
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalEnglish
    Local de registroCompanies House
    Número de registro02468436
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    IMPACT MARCOM LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 24/03/2015
    Entregue em 28/03/2015
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transações
    • 28/03/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 21/06/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    A supplemental deed to a debenture
    Criado em 03/12/2012
    Entregue em 10/12/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Indigo Capital V Sarl
    Transações
    • 10/12/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 26/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 03/12/2012
    Entregue em 08/12/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 08/12/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 21/06/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 22/04/2010
    Entregue em 11/05/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 11/05/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 28/11/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed & floating charge
    Criado em 03/03/2008
    Entregue em 08/03/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transações
    • 08/03/2008Registro de uma garantia (395)
    • 12/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 14/08/2007
    Entregue em 24/08/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/08/2007Registro de uma garantia (395)
    • 06/03/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage pursuant to an order of court dated 16/7/91
    Criado em 26/09/1990
    Entregue em 18/07/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 12 capitol park pearce way gloucester.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 18/07/1991Registro de uma garantia
    • 20/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 06/10/1981
    Entregue em 12/10/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book detbs uncalled captial, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 12/10/1981Registro de uma garantia
    • 04/02/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 02/06/1980
    Entregue em 09/06/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 09/06/1980Registro de uma garantia

    IMPACT MARCOM LTD possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    30/08/2019Data prevista de dissolução
    02/08/2018Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profissional
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0