DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED

DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaDALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01172417
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Seton House
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DALEHEAD FOODS LIMITED19/05/198919/05/1989
    DALE HEAD FOODS LIMITED31/05/197431/05/1974

    Quais são as últimas contas de DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2017

    Quais são as últimas submissões para DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Nomeação de Mr Tommy Bro Moelgaard como diretor em 07/02/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Helen Margaret Glennie como diretor em 05/02/2018

    1 páginasTM01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2017

    5 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 13/11/2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 19/09/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Resoluções

    Resolutions
    16 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Término da nomeação de Christopher Malcolm Terry como secretário em 29/06/2017

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mrs Helen Margaret Glennie como diretor em 29/06/2017

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Stephen Ronald William Francis como diretor em 29/06/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Christopher Thomas como diretor em 29/06/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Christopher Malcolm Terry como diretor em 29/06/2017

    1 páginasTM01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 30/09/2016 para 31/03/2017

    1 páginasAA01

    Declaração de confirmação apresentada em 19/09/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2015

    5 páginasAA

    Término da nomeação de Herluf Jensen como diretor em 09/03/2016

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Christopher Malcolm Terry como secretário em 09/03/2016

    2 páginasAP03

    Nomeação de Mr Christopher Malcolm Terry como diretor em 09/03/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Herluf Jensen como secretário em 09/03/2016

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 19/09/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital21/09/2015

    Estado do capital em 21/09/2015

    • Capital: GBP 400,003
    SH01

    Quem são os diretores de DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritishDirector205102630001
    MOELGAARD, Tommy Bro
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandDanishCfo243006590001
    ADAMSON, Robert Mclellan
    April Thatch
    Main Street Little Thetford
    CB6 3HA Ely
    Cambridgeshire
    Secretário
    April Thatch
    Main Street Little Thetford
    CB6 3HA Ely
    Cambridgeshire
    BritishDirector37386000001
    JENSEN, Herluf
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Secretário
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    DanishGroup Director96281690001
    TERRY, Christopher Malcolm
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Secretário
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    206515210001
    TREMBATH, David John
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    Secretário
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    BritishCompany Secretary68807490001
    ADAMSON, Robert Mclellan
    April Thatch
    Main Street Little Thetford
    CB6 3HA Ely
    Cambridgeshire
    Diretor
    April Thatch
    Main Street Little Thetford
    CB6 3HA Ely
    Cambridgeshire
    BritishAccountant37386000001
    AMBLER, Anthony Spencer
    Green Rigg
    Rooking
    CA11 0NP Patterdale
    Cumbria
    Diretor
    Green Rigg
    Rooking
    CA11 0NP Patterdale
    Cumbria
    United KingdomBritishDirector18296040007
    BALAAM, Christopher John
    6 Priory Path
    RM3 9AR Romford
    Essex
    Diretor
    6 Priory Path
    RM3 9AR Romford
    Essex
    BritishDirector73474440001
    COLVIN, Peter
    Spring Cottage
    Linden Gardens
    BA1 2YB Weston Road
    Bath
    Diretor
    Spring Cottage
    Linden Gardens
    BA1 2YB Weston Road
    Bath
    BritishDirector75878040001
    DAY, David
    99 Shaw Lane
    Dintine
    SK13 9EE Glossop
    Derbyshire
    Diretor
    99 Shaw Lane
    Dintine
    SK13 9EE Glossop
    Derbyshire
    BritishCompany Director40448680001
    ENEVOLDSEN, Flemming Nyenstad
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    DenmarkDanishCeo156168570001
    GLENNIE, Helen Margaret
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritishDirector217903040001
    GREENWOOD, James Edward
    104 Hardwick Lane
    IP33 2RA Bury St Edmunds
    Suffolk
    Diretor
    104 Hardwick Lane
    IP33 2RA Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishDirector37386320001
    HANDS, Stuart Peter
    13 Giffords Close
    CB3 0PF Girton
    Cambridge
    Diretor
    13 Giffords Close
    CB3 0PF Girton
    Cambridge
    BritishDirector75878210001
    HUGHES, John Stuart
    Ivy Todd Farmhouse
    West Wickham
    Cambrideshire
    Diretor
    Ivy Todd Farmhouse
    West Wickham
    Cambrideshire
    EnglandBritishDirector160343550001
    JAKOBSEN, Carsten Svejgaard
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    EnglandDanishDirector165874230001
    JENSEN, Herluf
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    EnglandDanishDirector96281690001
    LARTICE, John
    11a Grange Road
    Duxford
    CB2 4QE Cambridge
    Cambridgeshire
    Diretor
    11a Grange Road
    Duxford
    CB2 4QE Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishDirector34734060002
    MURRELLS, Steven Geoffrey
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    EnglandBritishCeo156162510001
    RICHARDS, Philip Jeffrey
    8 Vernon Green
    DE45 1DT Bakewell
    Derbyshire
    Diretor
    8 Vernon Green
    DE45 1DT Bakewell
    Derbyshire
    BritishDirector36144490001
    ROACH, Charles Graham
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    EnglandEnglishCompany Director11070150001
    SAUNDERS, Andrew Keith
    Holly House 4 Pembroke Road
    Framlingham
    IP13 9HA Woodbridge
    Suffolk
    Diretor
    Holly House 4 Pembroke Road
    Framlingham
    IP13 9HA Woodbridge
    Suffolk
    BritishDirector73752140001
    TERRY, Christopher Malcolm, Mr.
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritishChartered Accountant60746700002
    THOMAS, Christopher
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Diretor
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCeo63844650001
    THOMLINSON, Colin Robert
    Brian House 24 London Road
    Amesbury
    SP4 7DY Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Brian House 24 London Road
    Amesbury
    SP4 7DY Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director36057420001
    TREMBATH, David John
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    Diretor
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    EnglandBritishDirector68807490001

    Quem são as pessoas com controle significativo de DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Dalehead Foods Limited
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    England
    06/04/2016
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalComapnies Act
    Local de registroEngland And Wales
    Número de registro1078266
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    DALEHEAD FOODS HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 10/09/1999
    Entregue em 22/09/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    In favour of the chargee all moneys, obligations and liabilities from time to time due, owing or incurred under or pursuant to: (a) the following documents (together, and each as it may from time to time be amended, varied, novated, supplemented or replaced, the "secured documents"), namely: (I) a facilities agreement dated 10TH september 1999; (ii) an ancillary facilities letter dated 10TH september 1999; (iii) any agreements made in respect of hedging arrangements in accordance with the facilities agreement; and (iv) a subordination deed dated 10TH september 1999; (b) the guarantees and indemnities given by the company under the debenture, which secure all the obligations under the secured documents of each of flagship foods limited (the "primary borrower"), dalehead foods holdings limited and roach foods limited and each other subsidiary of the primary borrower which becomes a party to the debenture; and (c) all other provisions of the debenture
    Breve descrição
    First fixed charges over all of the present and future assets including land, plant, machinery and equipment, goodwill and uncalled capital, debts and calims, stocks, shares, bonds and other securities of any kind.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Plcon Behalf of Itself and the Banks and Financialinstitutions from Time to Time Parties to the Secured Documents
    Transações
    • 22/09/1999Registro de uma garantia (395)
    • 25/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 14/02/1997
    Entregue em 26/02/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 26/02/1997Registro de uma garantia (395)
    • 18/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 02/12/1993
    Entregue em 14/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on south side of hallam way,mansfield woodhouse,nottinghamshire. T/n NT264354.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 22/01/1997Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 29/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 29/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 09/08/1991
    Entregue em 28/08/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (See form 395-rep M555C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/08/1991Registro de uma garantia
    • 29/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 28/02/1985
    Entregue em 06/03/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All f/h & l/h property. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/03/1985Registro de uma garantia
    • 29/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 15/01/1975
    Entregue em 24/01/1975
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    By way of first fixed and floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Fixtures fixed plant and machinery. (See doc 7).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/01/1975Registro de uma garantia
    • 29/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0