YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC

YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaYEOMAN (CAMBRIDGE) PLC
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa 01177507
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC?

    Endereço do escritório registrado
    Kpmg One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LASER-SCAN HOLDINGS PLC02/03/199002/03/1990
    IMTEC GROUP PLC12/08/198312/08/1983

    Quais são as últimas contas de YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2011

    Qual é o status da última declaração anual para YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    5 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 19/08/2013

    5 páginas4.68

    Despacho judicial de insolvência

    Court order insolvency:court order replacement liquidators
    24 páginasLIQ MISC OC

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Notificação de cessação de atividade como liquidatário voluntário

    1 páginas4.40

    Endereço do domicílio registado alterado de * Martell House, University Way Cranfield Bedford Bedfordshire MK43 0TR* em 04/09/2012

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Declaração de solvência

    7 páginas4.70

    Declaração anual preparada até 03/07/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital17/07/2012

    Estado do capital em 17/07/2012

    • Capital: GBP 1,687,360.3
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2011

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Debra Shirley como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Radomir Lalovic como secretário

    1 páginasAP03

    Declaração anual preparada até 03/07/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2010

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 03/07/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2009

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2008

    11 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2007

    8 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    Quem são os diretores de YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LALOVIC, Radomir
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    Secretário
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    163442420001
    BERMAN, Stuart Andrew
    100 East End Road
    N3 2SX London
    Diretor
    100 East End Road
    N3 2SX London
    EnglandBritishUk Director45955900002
    EALES, Tony Peter
    23 Calder Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7AH Hatfield
    Hertfordshire
    Diretor
    23 Calder Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7AH Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director62393240004
    ABINGTON, Gordon
    81 Churchill Road
    IP24 2JZ Thetford
    Norfolk
    Secretário
    81 Churchill Road
    IP24 2JZ Thetford
    Norfolk
    British11512020001
    BOND, Nigel Phillip
    The White House
    The Street
    RG8 0JS South Stoke
    Reading Berkshire
    Secretário
    The White House
    The Street
    RG8 0JS South Stoke
    Reading Berkshire
    BritishDirector76442150001
    MARSHALL, Charles Howe
    Woodreed Farm
    Stonehurst Lane Five Ashes
    TN20 6LJ Mayfield
    East Sussex
    Secretário
    Woodreed Farm
    Stonehurst Lane Five Ashes
    TN20 6LJ Mayfield
    East Sussex
    BritishChartered Accountant113204560001
    SHIRLEY, Debra
    Wigmore Lane
    LU2 8AB Luton
    29
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Wigmore Lane
    LU2 8AB Luton
    29
    Bedfordshire
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary128265300001
    WINTER, Roger James
    12 Headley Gardens
    Great Shelford
    CB2 5JZ Cambridge
    Secretário
    12 Headley Gardens
    Great Shelford
    CB2 5JZ Cambridge
    BritishCompany Secretary13341990002
    ABINGTON, Gordon
    81 Churchill Road
    IP24 2JZ Thetford
    Norfolk
    Diretor
    81 Churchill Road
    IP24 2JZ Thetford
    Norfolk
    BritishDirector11512020001
    AGNEW, Hugh John
    38 Southampton Road
    SO41 9GG Lymington
    Hampshire
    Diretor
    38 Southampton Road
    SO41 9GG Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritishHydrographer49277250002
    BOND, Nigel Phillip
    The White House
    The Street
    RG8 0JS South Stoke
    Reading Berkshire
    Diretor
    The White House
    The Street
    RG8 0JS South Stoke
    Reading Berkshire
    United KingdomBritishDirector76442150001
    DOWSON, Philip
    Kitelands House
    Micheldever
    SO21 3AZ Winchester
    Hampshire
    Diretor
    Kitelands House
    Micheldever
    SO21 3AZ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant80655910001
    GEAKE, Vincent Glenn
    Three Gables
    Kings Saltern Road
    SO41 3QH Lymington
    Hampshire
    Diretor
    Three Gables
    Kings Saltern Road
    SO41 3QH Lymington
    Hampshire
    BritishEngineer49077240003
    HEYWOOD, John Axson
    21 Walpole Street
    SW3 4QP London
    Diretor
    21 Walpole Street
    SW3 4QP London
    BritishDirector32442360001
    HOLLANDS, Donald Arthur
    6 Fairfield Avenue
    RH6 7PD Horley
    Surrey
    Diretor
    6 Fairfield Avenue
    RH6 7PD Horley
    Surrey
    BritishDirector13672280001
    JACKSON, Michael John, Professor
    10 Kipling Place
    Eaton Ford
    PE19 7RG St Neots
    Cambridgeshire
    Diretor
    10 Kipling Place
    Eaton Ford
    PE19 7RG St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector97981730002
    MARSHALL, Charles Howe
    Woodreed Farm
    Stonehurst Lane Five Ashes
    TN20 6LJ Mayfield
    East Sussex
    Diretor
    Woodreed Farm
    Stonehurst Lane Five Ashes
    TN20 6LJ Mayfield
    East Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant113204560001
    MONTEITH, James Henry George
    145 Rosendale Road
    Dulwich
    SE21 8HE London
    Diretor
    145 Rosendale Road
    Dulwich
    SE21 8HE London
    EnglandBritishChartered Accountant103511470001
    PATEL, Peter Shantilal, Dr
    60 Lansdowne Road
    W11 2LR London
    Diretor
    60 Lansdowne Road
    W11 2LR London
    BritishManagement Consultant23543690001
    SANDERSON, Michael, Dr
    57 Bates Lane
    WA6 9LH Helsby
    Cheshire
    Diretor
    57 Bates Lane
    WA6 9LH Helsby
    Cheshire
    United KingdomBritishManaging Director76572340002
    SEWELL, Dennis John
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    Diretor
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    CanadianFinance Director3035310003
    UTTERSON, James Purves
    Alytre
    Abbotsbrook
    SL8 5QS Bourne End
    Buckinghamshire
    Diretor
    Alytre
    Abbotsbrook
    SL8 5QS Bourne End
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director23543680001
    WEVILL, Richard Mark
    40 Catherine Place
    SW1E 6HL London
    Diretor
    40 Catherine Place
    SW1E 6HL London
    BritishCompany Director120100570001
    WILLIAMS, Rhys John
    144a Kenilworth Road
    CV4 7AP Coventry
    West Midlands
    Diretor
    144a Kenilworth Road
    CV4 7AP Coventry
    West Midlands
    EnglandBritishDirector3245970001
    WINTER, Roger James
    12 Headley Gardens
    Great Shelford
    CB2 5JZ Cambridge
    Diretor
    12 Headley Gardens
    Great Shelford
    CB2 5JZ Cambridge
    BritishCompany Secretary13341990002
    WOODSFORD, Peter Alfred
    14 Chesterton Hall Crescent
    CB4 1AP Cambridge
    Diretor
    14 Chesterton Hall Crescent
    CB4 1AP Cambridge
    United KingdomBritishDirector13051350002

    YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage debenture
    Criado em 18/06/1998
    Entregue em 03/07/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 03/07/1998Registro de uma garantia (395)
    • 13/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 05/02/1991
    Entregue em 18/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 18/02/1991Registro de uma garantia
    • 19/02/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 05/08/1988
    Entregue em 20/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 650,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Breve descrição
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bolton House Investment PLC
    Transações
    • 20/08/1988Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 21/07/1988
    Entregue em 11/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 224,776,26 and all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 29/4/88
    Breve descrição
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bolton House Securities Limited.
    Transações
    • 11/08/1988Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 27/05/1988
    Entregue em 06/06/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/06/1988Registro de uma garantia
    • 13/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 06/08/1987
    Entregue em 25/08/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 6/8/87
    Breve descrição
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bolton House Securities Limited
    Transações
    • 25/08/1987Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 01/06/1987
    Entregue em 06/06/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 264,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 1/6/87 and this debenture
    Breve descrição
    Including trade fixtures.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bolton House Securities Limited
    • Bolton House Investments PLC
    Transações
    • 06/06/1987Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 01/06/1987
    Entregue em 06/06/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 250,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a second loan agreement dated 1/6/87 and this debenture
    Breve descrição
    Including trade fixtures.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bolton House Securities Limited
    Transações
    • 06/06/1987Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 01/06/1987
    Entregue em 06/06/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 250,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a first loan agreement dated 1/6/87 and this debenture
    Breve descrição
    Including trade fixtures.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bolton House Securities Limited
    Transações
    • 06/06/1987Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 08/08/1986
    Entregue em 19/08/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 200,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 8/8/86.
    Breve descrição
    Including trade fixtures.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • I.M. Herman
    • G. Frankel
    • M.R.P. Seib
    Transações
    • 19/08/1986Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 16/04/1986
    Entregue em 24/12/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 150,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 11/12/86.
    Breve descrição
    (Including trade fixture). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bolton House Investments PLC
    Transações
    • 24/12/1986Registro de uma garantia
    Guarantee & debenture
    Criado em 14/04/1982
    Entregue em 05/05/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company & and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. Uncalled capital. (See doc m 34).
    Pessoas com direito
    • Gerald Frankel.
    Transações
    • 05/05/1982Registro de uma garantia
    Mortgage debenture
    Criado em 23/12/1981
    Entregue em 12/01/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge or the company's f/h or l/h properties fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 12/01/1982Registro de uma garantia
    • 13/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/06/1981
    Entregue em 13/07/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H 170 honeypot lane stanmore middlesex title no ngl 294356 and l/h 168 honeypot lane stanmore middlesex title no ngl 323622. fixed & floating charge over the undertaking and all property and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • County Bank Limited
    Transações
    • 13/07/1981Registro de uma garantia

    YEOMAN (CAMBRIDGE) PLC possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/08/2014Data de dissolução
    20/08/2012Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profissional
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0