SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01216132 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 24 Old Queen Street SW1H 9HP London United Kingdom |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
E. SMITH & CO. (LOCKSMITHS) LIMITED | 16/06/1975 | 16/06/1975 |
Quais são as últimas contas de SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2021 |
Quais são as últimas submissões para SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Notificação de Securitas Technology Limited como pessoa com controlo significativo em 10/08/2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessação de Verifier Capital Limited como pessoa com controlo significativo em 10/08/2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Estado do capital em 19/07/2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
Término da nomeação de Rishabh Asit Adalja como diretor em 30/06/2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de C/O Stanley Uk Holding Limited 3 Europa Court Sheffield Business Park Sheffield South Yorkshire S9 1XE England para 24 Old Queen Street London SW1H 9HP | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado 24 Old Queen Street London SW1H 9HP | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 270 Bath Road Slough Berkshire SL1 4DX United Kingdom para 24 Old Queen Street London SW1H 9HP em 15/03/2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Goodwille Limited em 13/01/2023 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Nomeação de Mr Mark Andrew Coleman como diretor em 01/02/2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Shaun William Kennedy como diretor em 01/02/2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
A ação de exclusão obrigatória foi suspensa | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Steven John Costello como secretário em 22/07/2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Goodwille Limited como secretário em 22/07/2022 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Nomeação de Mr Rishabh Asit Adalja como diretor em 01/03/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Helen Teresa Wheeler como diretor em 01/03/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODWILLE LIMITED | Secretário | Red Lion St WC1R 4PS London 20 United Kingdom |
| 78363800011 | ||||||||||
COLEMAN, Mark Andrew | Diretor | Ortensia Drive Wavendon Business Park MK17 8LX Milton Keynes Cobra House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 305116950001 | ||||||||
KENNEDY, Shaun William | Diretor | Ortensia Drive Wavendon Business Park MK17 8LX Milton Keynes Cobra House United Kingdom | United Kingdom | British | Coo | 305117950001 | ||||||||
LORD, Andrew Stephen | Diretor | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 194669590001 | ||||||||
WHEELER, Helen Teresa | Diretor | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berks United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 75778800003 | ||||||||
BRYAN, Kenneth Norman | Secretário | 2 The Limes OX10 7LL Dorchester On Thames Oxfordshire | British | 92046350001 | ||||||||||
COSTELLO, Steven John | Secretário | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | 186116990001 | |||||||||||
HAYHURST, Fred | Secretário | Bramble Road SN2 8ER Swindon Stanley House Wilts United Kingdom | 158187180001 | |||||||||||
JONES, Trevor Robert | Secretário | 28 Rotherfield Way Caversham RG4 8PL Reading Berkshire | British | Company Director | 31534240001 | |||||||||
JONES, Trevor Robert | Secretário | 28 Rotherfield Way Caversham RG4 8PL Reading Berkshire | British | Company Director | 31534240001 | |||||||||
PUMPHREY, Hazel Louise | Secretário | 68 Meadow View Road Kennington OX1 5QX Oxford | British | 57920750003 | ||||||||||
STARKEY, Helen Margaret | Secretário | 6 Cintra Close RG2 7AL Reading Berkshire | British | 93865160002 | ||||||||||
RBS SECRETARY LIMITED | Secretário | 16 Beaufort Court Admirals Way Docklands E14 9XL London | 126701490001 | |||||||||||
SPEAFI LIMITED | Secretário | The Old Coroners Court No 1 London Street RG1 4QW Reading Berkshire | 83574040001 | |||||||||||
ADALJA, Rishabh, Mr. | Diretor | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | Indian | Finance Director | 268826930002 | ||||||||
ANTONOIU, Christopher | Diretor | Stanley Road RM12 4JW Hornchurch 114 Essex | British | Sales Director | 126701430002 | |||||||||
BRYAN, Kenneth Norman | Diretor | 2 The Limes OX10 7LL Dorchester On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 92046350001 | ||||||||
CLEMENTS, John | Diretor | 66 Shinfield Road RG2 7DA Reading | United Kingdom | British | Chief Executive | 45206050001 | ||||||||
COGZELL, Matthew James | Diretor | Bramble Road SN2 8ER Swindon Stanley House Wilts United Kingdom | England | British | Hr Director | 157755080001 | ||||||||
COWLEY, John Mitchell | Diretor | Bramble Road SN2 8ER Swindon Stanley House Wilts United Kingdom | England | British | Director | 153045530001 | ||||||||
GIBBONS, Jennifer Ann | Diretor | Oakleigh House Bere Court Road Pangbourne RG8 8JU Reading | England | British | Company Director | 62511290001 | ||||||||
GIBBONS, Paul | Diretor | Oakleigh House Bere Court Road RG8 8JU Pangbourne Berkshire | United Kingdom | British | Chairman | 8699020002 | ||||||||
GINNEVER, Bruce Quentin | Diretor | Bramble Road SN2 8ER Swindon Stanley House Wilts United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 19214470003 | ||||||||
GURDEN, Ramesh Babu | Diretor | 68 Whitehorns Way OX14 4LJ Drayton Oxford | British | Managing Director | 31534230002 | |||||||||
HELAS, John Peter | Diretor | Stanley House Bramble Road SN2 8ER Swindon, Wiltshire Stanley Security Solutions - Europe Limited England And Wales United Kingdom | England | British | General Manager | 217758150001 | ||||||||
JONES, Trevor Robert | Diretor | 28 Rotherfield Way Caversham RG4 8PL Reading Berkshire | British | Company Director | 31534240001 | |||||||||
LANE, Steven John | Diretor | Cutbush Close Lower Earley RG6 4XA Reading 26 Berkshire | United Kingdom | British | Security Consultant | 160316200001 | ||||||||
MADEJSKI, Robert John, Sir | Diretor | Northcourt Pangbourne RG8 8PT Reading Berkshire | England | British | Company Director | 42866240001 | ||||||||
MERRIFIELD, Stephanie Irene | Diretor | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | England | British | Hr Director | 219947100001 | ||||||||
ROGERS, Matthew | Diretor | Palm Drive Delray Beach 328 Florida 33483 U.S.A. | Usa | British | Finance | 128743670001 | ||||||||
SMILEY, Mark Richard | Diretor | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England England | United Kingdom | British | General Manager Uk & Roi | 194271890001 | ||||||||
SOOD, Amit Kumar | Diretor | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | England | British | Accountant | 153181250001 | ||||||||
STEPHENS, John Cecil Richard Lionel | Diretor | 164 Cumnor Hill Cumnor OX2 9PJ Oxford Oxfordshire | British | Company Director | 17874710001 | |||||||||
STUBBS, Susan | Diretor | Europa Court S9 1XE Sheffield 3 Sheffield Business Park England | United Kingdom | British | Hr Director | 169624400001 | ||||||||
UNDERWOOD, Stephen | Diretor | 48 Geoffreyson Road Caversham RG4 7HS Reading Berkshire | England | British | Director | 17874690001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Securitas Technology Limited | 10/08/2023 | Old Queen Street SW1H 9HP London 24 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Verifier Capital Limited | 06/04/2016 | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
SMITHS SECURITY SERVICES LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture | Criado em 25/06/2008 Entregue em 04/07/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 13/06/2000 Entregue em 17/06/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage debenture | Criado em 18/09/1995 Entregue em 21/09/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge over book debts. | Criado em 24/03/1994 Entregue em 05/04/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Specific charge over the benefit of all book debts and other debts as are now or may from time to time be due or owing to the company but so that the company but so that the comapny shall pay in to the company's account with national westminster bank PLC all moneys that it may receive in respect of such debts.please see doc for further details,. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A credit agreement | Criado em 25/08/1993 Entregue em 04/09/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £15550.40 due from the company to the chargee under the agreement | |
Breve descrição All right title and interes tunder the insurances. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Credit agreement | Criado em 19/07/1991 Entregue em 25/07/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £27,077.30 pursuant to the terms of the agreement | |
Breve descrição All of the company's right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance as detailed in the form 395 relevant to this charge. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 20/07/1989 Entregue em 03/08/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 58 briants avenue, eaversham, reading, berkshire title no bk 201193 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 05/04/1978 Entregue em 11/04/1978 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 84 london st, reading, berks. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0