INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaINDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01225706
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    NATIONWIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED01/04/199101/04/1991
    WESLEYSHIRE INDUSTRIAL SERVICES LIMITED20/12/198420/12/1984
    WESLEYSHIRE LIMITED09/09/197509/09/1975

    Quais são as últimas contas de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2019

    Quais são as últimas submissões para INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    9 páginasLIQ13

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de , Level 12 the Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, England para 30 Finsbury Square London EC2A 1AG em 08/01/2022

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    6 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 22/12/2021

    LRESSP

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Company business 03/12/2021
    RES13

    Estado do capital em 02/12/2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Memorando e estatutos

    12 páginasMA

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Detalhes do diretor alterados para Mr Jeremy Mark Williams em 19/07/2021

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 11/07/2021 com atualizações

    5 páginasCS01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 30/12/2020 para 31/03/2021

    1 páginasAA01

    Nomeação de Mr Jeremy Mark Williams como diretor em 07/04/2021

    2 páginasAP01

    Alteração dos detalhes de Maclellan Integrated Services Limited como pessoa com controlo significativo em 01/12/2020

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de , Capital Tower 91 Waterloo Road, London, SE1 8RT, England para 30 Finsbury Square London EC2A 1AG em 02/12/2020

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Richard John Butler como diretor em 30/11/2020

    1 páginasTM01

    Nomeação de Miss Katherine Woods como diretor em 30/11/2020

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mitie Company Secretarial Services Limited como secretário em 30/11/2020

    2 páginasAP04

    Término da nomeação de Stephanie Alison Pound como secretário em 30/11/2020

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Secretário
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro5228356
    148474450001
    POUND, Stephanie Alison
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Diretor
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritishCompany Secretary213930870002
    WILLIAMS, Jeremy Mark
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Diretor
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritishDirector280831530001
    WOODS, Katherine
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Diretor
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritishDirector237400250001
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Secretário
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    BritishCompany Secretary47884750003
    BUSH, Daniel
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Secretário
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    241575560001
    DAVIS, Hayden Keith
    1 Osborne
    B79 7SZ Tamworth
    Staffordshire
    Secretário
    1 Osborne
    B79 7SZ Tamworth
    Staffordshire
    BritishCompany Secretary88452860001
    GRUNDY, David
    12 Saint Peters Close
    Stonnall
    WS9 9EN Walsall
    West Midlands
    Secretário
    12 Saint Peters Close
    Stonnall
    WS9 9EN Walsall
    West Midlands
    British67582170002
    MCDONALD, Andrew John
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Secretário
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    247565100001
    MORROW, George Thomas Woodroofe
    Carrant Brook House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Glos
    Secretário
    Carrant Brook House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Glos
    British13876540001
    POUND, Stephanie Alison
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Secretário
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    250399460001
    SHIPLEY, Stephen Robert
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    Secretário
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    British16575040001
    BADCOCK, Benjamin Edward
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Diretor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant125575240001
    BIGGS, Malcolm John
    5 Dormston Close
    B91 3QW Solihull
    West Midlands
    Diretor
    5 Dormston Close
    B91 3QW Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director62229630001
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Diretor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Secretary47884750003
    BUSH, Daniel
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Diretor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor182845350001
    BUTLER, Richard John
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Diretor
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritishFinance Controller213849970003
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Diretor
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    BritishChartered Accountant49800090001
    CULLIFORD, John David
    7 Cheveridge Close
    B91 3TT Solihull
    West Midlands
    Diretor
    7 Cheveridge Close
    B91 3TT Solihull
    West Midlands
    BritishDirector30684700001
    DAVIS, Hayden Keith
    1 Osborne
    B79 7SZ Tamworth
    Staffordshire
    Diretor
    1 Osborne
    B79 7SZ Tamworth
    Staffordshire
    United KingdomBritishAccountant88452860001
    DAVIS, Paul Robert
    Honeyborne 25 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JF Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    Honeyborne 25 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JF Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Direcror3154980001
    ELLIS, John Leslie
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    Diretor
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector25380370003
    FELL, James Thomas
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Diretor
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritishGroup Financial Controller178128810002
    GRUNDY, David
    12 Saint Peters Close
    Stonnall
    WS9 9EN Walsall
    West Midlands
    Diretor
    12 Saint Peters Close
    Stonnall
    WS9 9EN Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishDirector67582170002
    HOWES, Peter Frederick Andrew
    23 Harvington Drive
    Shirley
    B90 4YN Solihull
    West Midlands
    Diretor
    23 Harvington Drive
    Shirley
    B90 4YN Solihull
    West Midlands
    BritishDirector30050860001
    KENNARD, Martin Robert
    Dingle Wood 8 Oak Grove
    DY10 3AL Kidderminster
    Worcestershire
    Diretor
    Dingle Wood 8 Oak Grove
    DY10 3AL Kidderminster
    Worcestershire
    BritishCommercial Director10060690002
    MCDONALD, Andrew John
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Diretor
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritishCompany Secretary164670820001
    MORROW, George Thomas Woodroofe
    Carrant Brook House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Glos
    Diretor
    Carrant Brook House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Glos
    EnglandBritishAccountant13876540001
    OVERTON, David Anthony
    Blackdown 66 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Diretor
    Blackdown 66 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director38536590002
    SENDUR, Metin
    31 Abberley Avenue
    DY13 0LZ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Diretor
    31 Abberley Avenue
    DY13 0LZ Stourport On Severn
    Worcestershire
    BritishDirector30050900001
    SHIPLEY, Stephen Robert
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    Diretor
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector16575040001
    STEVENTON, Brian George
    4 Littleton Croft
    B91 3XR Solihull
    West Midlands
    Diretor
    4 Littleton Croft
    B91 3XR Solihull
    West Midlands
    BritishDirector30050870001
    TAYLOR, Richard Ernest
    Briars Court
    Chapel Road
    RH8 0SX Oxted
    Surrey
    Diretor
    Briars Court
    Chapel Road
    RH8 0SX Oxted
    Surrey
    BritishDirector67170590001
    WELLER, Lyndon Frank
    37 Keswick Road
    B92 7PL Solihull
    West Midlands
    Diretor
    37 Keswick Road
    B92 7PL Solihull
    West Midlands
    BritishEngineering Director30050890001
    WRAGG, Peter Graham
    Ibstone Cottage Grays Lane
    Ibstone
    HP14 3XX High Wycombe
    Buckinghamshire
    Diretor
    Ibstone Cottage Grays Lane
    Ibstone
    HP14 3XX High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director37626480001

    Quem são as pessoas com controle significativo de INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Maclellan Integrated Services Limited
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    06/04/2016
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUk Company Law
    Local de registroEngland
    Número de registro02185674
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee & debenture
    Criado em 25/10/2000
    Entregue em 06/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 26/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 04/02/1991
    Entregue em 05/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Plot 8, aston fields industrial estate bromsgrove worcestershire t/no:- hw 15473SEE form 395 for details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 05/02/1991Registro de uma garantia
    • 02/03/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Collateral debenture
    Criado em 05/04/1988
    Entregue em 20/04/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the wesleyshire (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge:- l/h property k/a plot 8, aston fields industrial estate, bromsgrove, worcester t/no: hw 15473 fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts, uncalled capital. (For full details please see form 395).
    Pessoas com direito
    • Investors in Industry PLC
    Transações
    • 20/04/1988Registro de uma garantia
    Confirmatory charge supplemental to a mortgage debenture
    Criado em 05/04/1988
    Entregue em 19/04/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemenetal to a mortgage debenture d/d 2.2.83
    Breve descrição
    The property and assets of the company as charged by the said mortgage debenture.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 19/04/1988Registro de uma garantia
    • 02/03/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Confirmatory charge
    Criado em 11/05/1983
    Entregue em 19/05/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal mortgage d/d 15.3.79
    Breve descrição
    L/H property known as unit 8 aston fields industrial estate bromsgrove. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 19/05/1983Registro de uma garantia
    • 02/03/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 02/02/1983
    Entregue em 08/02/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds it sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and see overleaf. All property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/02/1983Registro de uma garantia
    • 02/03/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 15/03/1979
    Entregue em 30/03/1979
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 8, aston fields industrial estate, bromsgrove, hereford and worcster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 30/03/1979Registro de uma garantia
    • 02/03/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    22/12/2021Início da liquidação
    30/04/2023Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profissional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0