ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED

ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01315424
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Trafford House Chester Road
    Old Trafford
    M32 0RS Manchester
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    THOMAS BERMINGHAM CONTRACTORS LIMITED30/05/197730/05/1977

    Quais são as últimas contas de ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até28/12/2012

    Quais são as últimas submissões para ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    25 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/06/2019

    16 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/06/2018

    13 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de West Point Old Trafford Manchester M16 9HU para Trafford House Chester Road Old Trafford Manchester M32 0RS em 06/02/2018

    2 páginasAD01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/06/2017

    9 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/06/2016

    8 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/06/2015

    9 páginas4.68

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Endereço do domicílio registado alterado de Lancaster House Centurion Way Leyland Lancashire PR26 6TX para West Point Old Trafford Manchester M16 9HU em 18/07/2014

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 26/06/2014

    LRESSP

    Término da nomeação de Andrew Nelson como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 31/12/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/01/2014

    Estado do capital em 02/01/2014

    • Capital: GBP 105,600
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 28/12/2012

    7 páginasAA

    Satisfação total da garantia 6

    4 páginasMR04

    Nomeação de Sherard Secretariat Services Limited como secretário

    2 páginasAP04

    Término da nomeação de Paul Birch como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Andrew Latham Nelson como diretor

    2 páginasAP01

    legacy

    3 páginasMG02

    Declaração anual preparada até 31/12/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2011

    10 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/12/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Gordon House Sceptre Way Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 6AW United Kingdom* em 31/10/2011

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2010

    9 páginasAA

    Quem são os diretores de ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Secretário
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    Chester Road
    Old Trafford
    M32 0RS Manchester
    Trafford House
    Diretor
    Chester Road
    Old Trafford
    M32 0RS Manchester
    Trafford House
    EnglandBritishCompany Secretary76116640003
    EASTWOOD, Andrew Michael
    Chester Road
    Old Trafford
    M32 0RS Manchester
    Trafford House
    Diretor
    Chester Road
    Old Trafford
    M32 0RS Manchester
    Trafford House
    EnglandBritishGroup Financial Controller160883820001
    ANDREWS, Angela
    45 Wadsley Park Crescent
    S6 4BX Sheffield
    Yorkshire
    Secretário
    45 Wadsley Park Crescent
    S6 4BX Sheffield
    Yorkshire
    British54213650001
    BERMINGHAM, Jean
    Wadsley Lodge
    Laird Road
    S6 4BS Sheffield
    Secretário
    Wadsley Lodge
    Laird Road
    S6 4BS Sheffield
    British22459530001
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secretário
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Secretário
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    BritishSolicitor36153790001
    BERESFORD, Colin Max
    122 Sandygate Road
    S10 5RZ Sheffield
    Diretor
    122 Sandygate Road
    S10 5RZ Sheffield
    EnglandBritishCompany Director127316500001
    BERMINGHAM, Jean
    Wadsley Lodge
    Laird Road
    S6 4BS Sheffield
    Diretor
    Wadsley Lodge
    Laird Road
    S6 4BS Sheffield
    BritishCompany Director22459530001
    BERMINGHAM, Joy Marie
    1 Towngate Grove
    Worrall
    S35 0BE Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor
    1 Towngate Grove
    Worrall
    S35 0BE Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director61310840001
    BERMINGHAM, Thomas
    Wadsley Lodge
    Laird Road
    S6 4BS Sheffield
    Diretor
    Wadsley Lodge
    Laird Road
    S6 4BS Sheffield
    BritishCivil Engineer22459550001
    BOND, Constance Mary
    51 Colley Crescent
    S5 9FS Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor
    51 Colley Crescent
    S5 9FS Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director22459560001
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Diretor
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSolicitor36153790001
    GREENBURY, Lee
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Diretor
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor61478920003
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    Diretor
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director51438040006
    MALONEY, John Gerard
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Diretor
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    IrishChief Operating Officer96964980001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer96596920001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    Diretor
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Diretor
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector17129800004
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Diretor
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director17129800004
    NELSON, Andrew Latham
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Diretor
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    United KingdomBritishFinance Director36191090003
    WOOLGAR, David John Mitchell
    The Priory
    Church Street
    SY6 6DQ Church Stretton
    Salop
    Diretor
    The Priory
    Church Street
    SY6 6DQ Church Stretton
    Salop
    United KingdomBritishChartered Engineer71343240001

    ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 18/05/2007
    Entregue em 31/05/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transações
    • 31/05/2007Registro de uma garantia (395)
    • 02/07/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000
    Criado em 15/02/2001
    Entregue em 17/02/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents and/or on any other account whatsoever (all terms as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity Assecurity Trustee for the Beneficaries
    Transações
    • 17/02/2001Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/2002Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 14/03/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal mortgage
    Criado em 18/09/1997
    Entregue em 29/09/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a railway siding alongside elsecar railway station barnsley south yorkshire t/no.SYK233566. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/09/1997Registro de uma garantia (395)
    • 02/11/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 20/09/1985
    Entregue em 04/10/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land and buildings on the south east side of brightside lane, shefield, south yorkshire t/n ywe 48422 and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/10/1985Registro de uma garantia
    • 02/11/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 04/07/1983
    Entregue em 11/07/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. A fixed & floating charge over goodwill & bookdebts. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 11/07/1983Registro de uma garantia
    • 02/11/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security registered at the register of sasines 11/1/78
    Criado em 17/12/1977
    Entregue em 20/01/1978
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Dwellinghouse and ground at one hundred and ninty one arran rd. Dumfries.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank LTD
    Transações
    • 20/01/1978Registro de uma garantia
    • 17/02/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    26/06/2014Início da liquidação
    28/02/2021Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Beverley Ellice Budsworth
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Profissional
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0