HARGREAVES VENDING LIMITED

HARGREAVES VENDING LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHARGREAVES VENDING LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01322308
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HARGREAVES VENDING LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Mccoll's House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Essex
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até27/11/2016

    Quais são as últimas submissões para HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Término da nomeação de Bernadette Clare Young como secretário em 07/09/2018

    1 páginasTM02

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 28/03/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 27/11/2016

    4 páginasAA

    Nomeação de Mr Steven Green como diretor em 22/08/2017

    2 páginasAP01

    Nomeação de Bernadette Clare Young como secretário em 22/08/2017

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Simon Jonathan Miller como secretário em 22/08/2017

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 28/03/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 29/11/2015

    4 páginasAA

    Nomeação de Mr Simon Jeremy Ian Fuller como diretor em 26/04/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de James Lancaster como diretor em 26/04/2016

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 28/03/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital07/04/2016

    Estado do capital em 07/04/2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas anuais preparadas até 30/11/2014

    10 páginasAA

    Término da nomeação de Kingsley John Tedder como secretário em 12/08/2015

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 28/03/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital31/03/2015

    Estado do capital em 31/03/2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 24/11/2013

    4 páginasAA

    Término da nomeação de Martyn James Aguss como diretor em 30/07/2014

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 28/03/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/06/2014

    Estado do capital em 12/06/2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Martin Mccoll House Ashwells Road Pilgrims Hatch Brentwood Essex CM15 9ST* em 21/01/2014

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 25/11/2012

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 28/03/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 27/11/2011

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 28/03/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Quem são os diretores de HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Diretor
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritish181763320001
    GREEN, Steven
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Diretor
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritish209349290001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Diretor
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish88269280005
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Secretário
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Secretário
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British88269280005
    SNEYD, Ian Nicholas
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    Secretário
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    British31342250001
    TEDDER, Kingsley John
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Secretário
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British101631010002
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Secretário
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    237612690001
    AGUSS, Martyn James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Diretor
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish107991420002
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Diretor
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritish31500810002
    FOSTER, Brian
    24 Palm Street
    Droylsden
    M43 6WJ Manchester
    Lancashire
    Diretor
    24 Palm Street
    Droylsden
    M43 6WJ Manchester
    Lancashire
    British24323870001
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Diretor
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish147052660001
    MCFARLANE, Ian Douglas
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    Diretor
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    British130747750001
    POPE, Philip
    23 Croftacres
    Edenfield Ramsbottom
    BL0 0LX Bury
    Lancashire
    Diretor
    23 Croftacres
    Edenfield Ramsbottom
    BL0 0LX Bury
    Lancashire
    United KingdomBritish52431400001
    WILKINSON, Stephen William
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Pilgrims Hatch Brentwood
    Essex
    Diretor
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Pilgrims Hatch Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish101631100002

    Quem são as pessoas com controle significativo de HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    England
    06/04/2016
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalEngland
    Local de registroCompanies House
    Número de registro03462566
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    HARGREAVES VENDING LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee & debenture
    Criado em 28/11/1998
    Entregue em 08/12/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/12/1998Registro de uma garantia (395)
    • 14/06/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 24/07/1995
    Entregue em 31/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 31/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 03/05/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 26/07/1984
    Entregue em 01/08/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that f/h land with the buildings erected thereon situate at and known as 146 manchester road droylsden, tameside, greater manchester.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transações
    • 01/08/1984Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 04/08/1983
    Entregue em 13/08/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/Hold land on the north side of manchester road, droylsden, tameside, greater manchester title no. La 316784 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transações
    • 13/08/1983Registro de uma garantia
    • 01/04/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 04/08/1983
    Entregue em 13/08/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/Hold land and buildings on the south side of manor road, droylsden tameside, greater manchester. Title no p 178345 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transações
    • 13/08/1983Registro de uma garantia
    • 01/04/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed supplemental to a debenture
    Criado em 17/08/1981
    Entregue em 21/08/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 23.10.79
    Breve descrição
    Fixed charge on all bookdebts & other debts of the company both present & future.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transações
    • 21/08/1981Registro de uma garantia
    • 01/04/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 10/07/1981
    Entregue em 16/07/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land situate on the east side of hemmons road now known as unit 1 longden road longsight. Manchester greater manchester title no: gm 229537 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transações
    • 16/07/1981Registro de uma garantia
    • 20/07/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 23/10/1979
    Entregue em 01/11/1979
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge - undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. All fixtures, fittings fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank Limited.
    Transações
    • 01/11/1979Registro de uma garantia
    • 01/04/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 11/05/1979
    Entregue em 21/05/1979
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H known as 35 longshut lane west stockport greater manchester title number ch 70634 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyns Bank Limited
    Transações
    • 21/05/1979Registro de uma garantia
    • 20/07/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0