CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED

CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01346606
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    • Seguros de vida (65110) / Atividades financeiras e de seguros
    • Seguros não-vida (65120) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED31/12/197831/12/1978
    NEVRUS TWO LIMITED03/01/197803/01/1978

    Quais são as últimas contas de CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2020

    Quais são as últimas submissões para CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG para 30 Finsbury Square London EC2A 1AG em 21/10/2021

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 13/10/2021

    LRESSP

    Contas anuais preparadas até 31/12/2020

    12 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Mark Rankin Cummings em 19/03/2021

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 28/02/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2019

    12 páginasAA

    Término da nomeação de Paul Richard Bradbrook como diretor em 18/05/2020

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Mark Rankin Cummings como diretor em 18/05/2020

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 28/02/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    12 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/02/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Paul Andrew Jardine como diretor em 26/09/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen Ashwell como diretor em 26/09/2018

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Clynton Jacobus Luttig como diretor em 26/09/2018

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    12 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/02/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    11 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/02/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    11 páginasAA

    Declaração anual preparada até 28/02/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/03/2016

    Estado do capital em 04/03/2016

    • Capital: GBP 999,900
    SH01

    Término da nomeação de Robert Callan como diretor em 31/10/2015

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    REES, Marie Louise
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Secretário
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    201004180001
    ASHWELL, Stephen Michael
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Diretor
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish192559400001
    CUMMINGS, Mark Rankin
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Diretor
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish254912020002
    LUTTIG, Clynton Jacobus
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Diretor
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish218565170001
    BUSHER, Thomas George Story
    4a Drayton Court
    Drayton Gardens
    SW10 9RQ London
    Secretário
    4a Drayton Court
    Drayton Gardens
    SW10 9RQ London
    British6386010001
    DAVIES, Sarah Ann
    1 Holly Bush Lane
    Bendish
    SG4 8JB Hitchin
    Hertfordshire
    Secretário
    1 Holly Bush Lane
    Bendish
    SG4 8JB Hitchin
    Hertfordshire
    British66138540001
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Secretário
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GUYATT, Elizabeth Helen
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Secretário
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    British100201680002
    NOONE, Lisa Marie
    7 Woodstone Avenue
    IP1 3TE Ipswich
    Suffolk
    Secretário
    7 Woodstone Avenue
    IP1 3TE Ipswich
    Suffolk
    British72182310001
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Secretário
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    THOMAS, Heather Irene
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    Secretário
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    British105936240001
    TIMMINS, Eleanor Bharti Yvonne
    Flat 2 8 Eversfield Road
    Kew
    TW9 2AP Richmond
    Surrey
    Secretário
    Flat 2 8 Eversfield Road
    Kew
    TW9 2AP Richmond
    Surrey
    British42173620001
    AGNEW, Ian Charles
    23 Chalfont House
    19 Chesham Street
    SW1X 8NG London
    Diretor
    23 Chalfont House
    19 Chesham Street
    SW1X 8NG London
    British6418620003
    ALEXANDER, John Lindsay, Sir
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    Diretor
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    British6418630001
    AVERY, Julian Ralph
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    Diretor
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    United KingdomUk37578750001
    BARTON, Robert John Orr
    33 Rutland Court
    Rutland Gardens
    SW7 1BW London
    Diretor
    33 Rutland Court
    Rutland Gardens
    SW7 1BW London
    British7999080003
    BENHAM, Stephen
    Smythe Cottage
    Wenlock Lane
    CM4 0JG Blackmore
    Essex
    Diretor
    Smythe Cottage
    Wenlock Lane
    CM4 0JG Blackmore
    Essex
    British38793500002
    BRADBROOK, Paul Richard
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Diretor
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish148983260001
    BURROWS, Timothy William
    37 Northumberland Road
    New Barnet
    EN5 1EB Barnet
    Hertfordshire
    Diretor
    37 Northumberland Road
    New Barnet
    EN5 1EB Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish126815810002
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Diretor
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    CALLAN, Robert
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Diretor
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish130365420001
    CAPRON, Adam David
    Coach House
    The Green, Leckhampstead
    RG20 8QH Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Coach House
    The Green, Leckhampstead
    RG20 8QH Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish122237920001
    CHAPMAN, Neil Richard
    30 South Street
    SS4 1BQ Rochford
    Essex
    Diretor
    30 South Street
    SS4 1BQ Rochford
    Essex
    British73334580001
    COLEMAN, Barry
    Batchelors
    Barns Green
    RH13 7QG Horsham
    West Sussex
    Diretor
    Batchelors
    Barns Green
    RH13 7QG Horsham
    West Sussex
    British15199730001
    COOPER, Anthony Geoffrey
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    Diretor
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    British73654090001
    CUSACK, Julian Michael
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    Diretor
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    British84410430001
    DAVIES, Sarah Ann
    1 Holly Bush Lane
    Bendish
    SG4 8JB Hitchin
    Hertfordshire
    Diretor
    1 Holly Bush Lane
    Bendish
    SG4 8JB Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish66138540001
    DE HALDEVANG, Bernard Goetz Michael Imka
    44a Lavender Sweep
    SW11 1HD London
    Diretor
    44a Lavender Sweep
    SW11 1HD London
    British73476700001
    DUMAS, Henry Raymond
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    Diretor
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    British73016630001
    ENGESTROM, John
    Yardley Farm
    Chequers Lane
    LU7 9AG Pitstone
    Buckinghamshire
    Diretor
    Yardley Farm
    Chequers Lane
    LU7 9AG Pitstone
    Buckinghamshire
    Swedish67286160004
    EWBANK, Ronald Joseph
    23 Dean Close
    Pyrford
    GU22 8NX Woking
    Surrey
    Diretor
    23 Dean Close
    Pyrford
    GU22 8NX Woking
    Surrey
    British71972950001
    FOREMAN, David Peter
    Ringers Farm
    Russ Hill Road Charlwood
    RH6 0EW Horley
    Surrey
    Diretor
    Ringers Farm
    Russ Hill Road Charlwood
    RH6 0EW Horley
    Surrey
    EnglandBritish121083690001
    FRANKS, Howard Alistair Lionel
    96 Woodstock Road
    Chiswick
    W4 1EG London
    Diretor
    96 Woodstock Road
    Chiswick
    W4 1EG London
    British24301440002
    FREEMAN, Philip John
    114 Farmers Way
    SL6 3PU Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    114 Farmers Way
    SL6 3PU Maidenhead
    Berkshire
    British24301450001
    FRESHWATER, Neil Andrew, Mr.
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Diretor
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish125646370001

    Quem são as pessoas com controle significativo de CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    06/04/2016
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro1949119
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Charge over experience account
    Criado em 07/01/2005
    Entregue em 27/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the members of the lloyd's syndicates to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first fixed charge the deposit, the experience account, the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit and the experience account and by way of floating charge all entitlements to interest on the deposit being £18,346,448.67. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • First National Litigation Funding PLC
    Transações
    • 27/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 25/05/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 11/12/2003
    Entregue em 22/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transações
    • 22/12/2003Registro de uma garantia (395)
    • 02/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 24/08/1998
    Entregue em 27/08/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 27/08/1998Registro de uma garantia (395)
    • 10/09/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 28/01/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/07/1997
    Entregue em 29/07/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 29/07/1997Registro de uma garantia (395)
    • 10/09/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 21/11/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 03/11/1992
    Entregue em 21/11/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 21/11/1992Registro de uma garantia (395)
    • 10/09/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 21/11/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 08/08/1988
    Entregue em 18/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 18/08/1988Registro de uma garantia
    • 10/09/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 08/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 08/08/1988
    Entregue em 18/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 18/08/1988Registro de uma garantia
    • 02/03/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 30/12/1985
    Entregue em 13/01/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 13/01/1986Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 30/12/1985
    Entregue em 06/01/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from wellington underwriting limited to the chargee under terms of the charge
    Breve descrição
    Borrowers interest in the l/h properties etc and/or the proceeds of sale thereof specific charge over all other securities etc the goodwill & uncalled capital etc. floating charge undertaking and all property and assets present and future (see doc M34 for full details).
    Pessoas com direito
    • Baring Brothers & Co. Limited
    Transações
    • 06/01/1986Registro de uma garantia

    CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    13/10/2021Início da liquidação
    22/10/2022Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profissional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0