PRUDENTIAL (AN) LIMITED

PRUDENTIAL (AN) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPRUDENTIAL (AN) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01347088
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    • (6601) /

    Onde fica PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PRUDENTIAL HOLBORN PENSIONS LIMITED21/09/198721/09/1987
    VANBRUGH PENSIONS LIMITED09/01/197809/01/1978

    Quais são as últimas contas de PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2009

    Quais são as últimas submissões para PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    5 páginas4.71

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de 3 Sheldon Square London W2 6PR

    2 páginasAD02

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 30/06/2011

    LRESSP

    Endereço do domicílio registado alterado de Laurence Pountney Hill London EC4R 0HH em 08/07/2011

    2 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 13/06/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital22/06/2011

    Estado do capital em 22/06/2011

    • Capital: GBP 18,000,000
    SH01

    Nomeação de Mr Mark Geoffrey Morbey como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Finbar O'dwyer como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Belsham como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Kelvin Nunn como diretor

    1 páginasTM01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2010 para 30/06/2011

    1 páginasAA01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada

    2 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado

    2 páginasAD02

    Declaração anual preparada até 13/06/2010 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Nomeação de Mr Kelvin Nunn como diretor

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2009

    28 páginasAA

    Quem são os diretores de PRUDENTIAL (AN) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PRUDENTIAL GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Secretário
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    79384540001
    MORBEY, Mark Geoffrey
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Diretor
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    EnglandBritish94079860001
    RUPAREL, Vanessa Frances
    54 Clarendon Avenue
    CV32 4SA Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretário
    54 Clarendon Avenue
    CV32 4SA Leamington Spa
    Warwickshire
    British66822710002
    WALKER, Robert
    6 Albion Road
    RH2 7JY Reigate
    Surrey
    Secretário
    6 Albion Road
    RH2 7JY Reigate
    Surrey
    British61132230001
    WALKER, Robert
    6 Albion Road
    RH2 7JY Reigate
    Surrey
    Secretário
    6 Albion Road
    RH2 7JY Reigate
    Surrey
    British61132230001
    ALLEN, Anthony Simon Echalaz
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Diretor
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    British97055430001
    BEDELL PEARCE, Keith Leonard
    4 The Ridge
    CR8 3PE Purley
    Surrey
    Diretor
    4 The Ridge
    CR8 3PE Purley
    Surrey
    United KingdomBritish9522540001
    BELSHAM, David John
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Diretor
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    United KingdomBritish51945120001
    BERKETT, Neil Anthony
    Woodpeckers 31 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Diretor
    Woodpeckers 31 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    EnglandNew Zealander145735920001
    CASSONI, Maria Luisa
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    Diretor
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    EnglandBritish74583340001
    COOK, Alan Ronald
    Orchard Grange 28 Church End Road
    Shenley Brook End
    MK5 7AB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Diretor
    Orchard Grange 28 Church End Road
    Shenley Brook End
    MK5 7AB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish53705220002
    ELBOURNE, John Kenneth
    1 Lissoms Road
    CR5 3LE Chipstead
    Surrey
    Diretor
    1 Lissoms Road
    CR5 3LE Chipstead
    Surrey
    British4792320001
    EVERETT, Richard Charles
    23 Stanhope Way
    Riverhead
    TN13 2DZ Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    23 Stanhope Way
    Riverhead
    TN13 2DZ Sevenoaks
    Kent
    British91615080001
    HANBY, Peter Nicholas
    12 Battledown Close
    GL52 6RD Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    12 Battledown Close
    GL52 6RD Cheltenham
    Gloucestershire
    British1553180001
    HARDING, David Charles Ian
    2 Castle Grove
    CV8 1NF Kenilworth
    Warwickshire
    Diretor
    2 Castle Grove
    CV8 1NF Kenilworth
    Warwickshire
    British92569260001
    HARRIS, Rosemary
    The Mount
    GU2 4JB Guildford
    74
    Surrey
    Diretor
    The Mount
    GU2 4JB Guildford
    74
    Surrey
    EnglandBritish228468970001
    HURD, Brian Willian
    70 Stamford Road
    WA14 2JF Bowden
    Cheshire
    Diretor
    70 Stamford Road
    WA14 2JF Bowden
    Cheshire
    EnglandUnited Kingdom99461690001
    JACK, James White
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Diretor
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    EnglandBritish191658610001
    JACK, James White
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Diretor
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    EnglandBritish191658610001
    MITCHELL, James Charles
    4 Strachan Crescent
    FK14 7HL Dollar
    Clackmannanshire
    Diretor
    4 Strachan Crescent
    FK14 7HL Dollar
    Clackmannanshire
    British26179390001
    MOORES, Michael John
    94 The Avenue
    TW16 5EX Sunbury On Thames
    Middlesex
    Diretor
    94 The Avenue
    TW16 5EX Sunbury On Thames
    Middlesex
    United KingdomBritish17690270001
    NICOLSON, Roy Macdonald
    'Ardgarten'
    45 Doune Road
    FK15 9HR Dunblane
    Perthshire
    Diretor
    'Ardgarten'
    45 Doune Road
    FK15 9HR Dunblane
    Perthshire
    British238750001
    NUNN, Kelvin
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Diretor
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    United KingdomBritish109126660001
    O'DWYER, Finbar Anthony
    Tynebank Road
    EH41 4DW Haddington
    Tynebank House
    East Lothian
    Scotland
    Diretor
    Tynebank Road
    EH41 4DW Haddington
    Tynebank House
    East Lothian
    Scotland
    ScotlandIrish133418790001
    PULLEN, Trevor Keith
    Loxwood
    Grassy Lane
    TN13 1PL Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    Loxwood
    Grassy Lane
    TN13 1PL Sevenoaks
    Kent
    British80114850001
    ROBERTSON, Angus John
    48 Kilpatrick Gardens
    Clarkston
    G76 7RH Glasgow
    Diretor
    48 Kilpatrick Gardens
    Clarkston
    G76 7RH Glasgow
    British64974900001
    ROBERTSON, William John
    4 Cavendish Drive
    Newton Mearns
    G77 5NY Glasgow
    Diretor
    4 Cavendish Drive
    Newton Mearns
    G77 5NY Glasgow
    ScotlandBritish145428580001
    SHAUGHNESSY, Gary Paul John
    Wheathold Farm
    Wolverton
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    Diretor
    Wheathold Farm
    Wolverton
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    United KingdomBritish153315930001
    SHEPPARD, Morag Helen
    The Station House
    FK9 3JX Arnprior
    Stirlingshire
    Diretor
    The Station House
    FK9 3JX Arnprior
    Stirlingshire
    British118314860001
    STEWART, Gavin Macneill
    17 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    17 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish4844910002
    TOOKEY, Timothy James William
    28 Brabourne Rise
    BR3 6SG Beckenham
    Kent
    Diretor
    28 Brabourne Rise
    BR3 6SG Beckenham
    Kent
    British57236570002
    WOOD, Gregory Mark
    21 Sprimont Place
    SW3 3HT London
    Diretor
    21 Sprimont Place
    SW3 3HT London
    British51415410002

    PRUDENTIAL (AN) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of charge
    Criado em 30/06/2005
    Entregue em 21/07/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of floating charge all the chargor's right to and title and interest in the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transações
    • 21/07/2005Registro de uma garantia (395)
    • 20/01/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Third party legal charge
    Criado em 12/03/2003
    Entregue em 27/03/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the trustees from time to time of the prudential holborn 1990 personal pension scheme (the trust) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Units 1 & 2 phase 4 forde court forde road brunel industrial estate newton abbot devon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 27/03/2003Registro de uma garantia (395)
    • 19/01/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Criado em 06/12/1999
    Entregue em 16/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a 39 new hall lane heaton bolton greater manchester. Floating charge over equipment thereon comprising all unfixed plants and machinery and other chattels and equipment now or in future.
    Pessoas com direito
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transações
    • 16/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 19/01/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Criado em 06/12/1999
    Entregue em 16/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a 41 new hall lane heaton bolton greater manchester. Floating charge over equipment thereon comprising all unfixed plants and machinery and other chattels and equipment now or in future.
    Pessoas com direito
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transações
    • 16/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 19/01/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 25/08/1999
    Entregue em 28/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property known as charlton house, draytons passage, shrewsbury shropshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 20/01/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 25/08/1999
    Entregue em 28/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 9 sweetlake business village shrewsbury shropshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 19/01/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 27/03/1998
    Entregue em 16/04/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company as trustees of prudential (1990) personal pension scheme (a/c R.d edwards and D.J.lowe) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    14A the thoroughfare halesworth suffolk. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Pessoas com direito
    • Nationwide Building Society
    Transações
    • 16/04/1998Registro de uma garantia (395)
    • 12/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 24/06/1997
    Entregue em 02/07/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Breve descrição
    Suite 3, 26 church street bishops stortford herts ("the property") t/n-HD296149. Note: clause 43: notwithstanding any provision to the contary contained in this charge the bank shall only be entitled to recover any moneys due from the mortgagor under this charge from the proceeds of realisation of the property.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 02/07/1997Registro de uma garantia (395)
    • 20/01/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 16/06/1997
    Entregue em 20/06/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property at 19 birmingham street oldbury warley west midlands.t/no.wm 194784.note:by clause 13 of the deed the mortgage is placed on a "limited recourse" basis,excluding any fixed/floating charges over assets other than the property.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 20/06/1997Registro de uma garantia (395)
    • 12/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 19/07/1996
    Entregue em 31/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company k a lambert b trust w s michie and b a e maydell to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Property at units 17 & 18 the capstan centre thurrock park way tilbury essex with the benefit of all rights licences and guarantees and the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 31/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 12/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 12/05/1995
    Entregue em 23/05/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    73 high street southwold suffolk. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on the mortgaged prorerty and the goodwill carried on at the mortgaged property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Pessoas com direito
    • Nationwide Building Society
    Transações
    • 23/05/1995Registro de uma garantia (395)
    • 12/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security
    Criado em 28/04/1995
    Entregue em 10/05/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    The old toll garage, 128 and 128A main street overton wishaw scotland.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/05/1995Registro de uma garantia (395)
    • 02/03/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    PRUDENTIAL (AN) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    30/06/2011Início da liquidação
    26/09/2012Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profissional
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Alistair Steven Wood
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Profissional
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0