KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED

KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaKEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01356836
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    • fabricação de produtos de arame, correntes e molas (25930) / Indústrias transformadoras
    • fabricação de outros fios e cabos eletrônicos e elétricos (27320) / Indústrias transformadoras

    Onde fica KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    4 Stirling Court
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Herts
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PLESSEY WIRING SYSTEMS LIMITED31/12/197831/12/1978
    PLESSEY GROUP SERVICES LIMITED09/03/197809/03/1978

    Quais são as últimas contas de KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2011

    Quais são as últimas submissões para KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    19 páginasLIQ14

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 16/04/2016

    17 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de Brook Point 1412-1420 High Road Whetstone London N20 9BH para 4 Stirling Court Stirling Way Borehamwood Herts WD6 2BT em 19/10/2015

    1 páginasAD01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 16/04/2015

    19 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 16/04/2014

    19 páginas4.68

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 01/04/2014

    8 páginas1.3

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    8 páginas1.4

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação

    LRESEX

    Nomeação de um liquidador voluntário

    600

    Estado de situação patrimonial com formulário em anexo 4.19

    22 páginas4.20

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Endereço do domicílio registado alterado de * 5 Fleet Place London EC4M 7RD England* em 11/04/2013

    2 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Company place voluntary creditors liquidation/appoint liquidator 27/03/2013
    RES13

    legacy

    5 páginasMG01

    Declaração anual preparada até 01/01/2013 com lista completa de acionistas

    14 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/02/2013

    Estado do capital em 20/02/2013

    • Capital: GBP 2,718,215
    SH01

    Término da nomeação de William Gimson como diretor

    2 páginasTM01

    Alteração da data de encerramento do exercício contabilístico

    3 páginasAA01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2011

    23 páginasAA

    Aviso ao Registo Comercial do acordo voluntário de empresas que entra em vigor

    8 páginas1.1

    O processo de dissolução compulsória foi descontinuado

    1 páginasDISS40

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Término da nomeação de Richard Martin como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Andrew Mckerrow como diretor

    1 páginasTM01

    legacy

    6 páginasMG02

    Quem são os diretores de KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HALCO SECRETARIES LIMITED
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Secretário
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2503744
    146855460001
    GIMSON, John Peter
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    4 Stirling Court
    Herts
    Diretor
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    4 Stirling Court
    Herts
    EnglandBritish89639570001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Secretário
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    ELLARD, Sarah Louise
    3 Glenney Close
    PO13 8FD Lee On The Solent
    Hampshire
    Secretário
    3 Glenney Close
    PO13 8FD Lee On The Solent
    Hampshire
    British43855640009
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Secretário
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Secretário
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    WILLIFER, Mark Eamon
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Secretário
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    British33089100003
    AUSTIN, Brian Sergio, Mr.
    Innovis House
    108 High Street
    RH10 1AS Crawley
    West Sussex
    Diretor
    Innovis House
    108 High Street
    RH10 1AS Crawley
    West Sussex
    EnglandBritish83674480001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Diretor
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    British18247670001
    BOWEN, Malcolm Alvin
    29 Purn Road
    Bleadon
    BS24 9JQ Weston Super Mare
    Avon
    Diretor
    29 Purn Road
    Bleadon
    BS24 9JQ Weston Super Mare
    Avon
    British27471100001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Diretor
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British1525670001
    DAVIES, Arthur Thomas
    Charlecote 4 Stag Gates
    Blackfield
    SO45 1SR Southampton
    Hants
    Diretor
    Charlecote 4 Stag Gates
    Blackfield
    SO45 1SR Southampton
    Hants
    British24258700001
    EVANS, David Roger
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    Diretor
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    EnglandBritish4471420003
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Diretor
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    British85421380001
    GIMSON, William Peter Critchley
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United Kingdom British 162987980001
    HOLLAND, Richard Andrew
    Cedarcroft
    Twyning Green
    GL20 6DQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Diretor
    Cedarcroft
    Twyning Green
    GL20 6DQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish107177720001
    LYNN, John James
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    British69883500001
    MACDERMOTT, Philip
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    Diretor
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    British25679470001
    MARTIN, Richard
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritish27471110004
    MCKERROW, Andrew James
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritish83845420002
    MOLONY, Peter John
    Mill House
    Great Elm
    BA11 3NY Frome
    Somerset
    Diretor
    Mill House
    Great Elm
    BA11 3NY Frome
    Somerset
    British42803990001
    RAINBIRD, Graham Dennis
    23 Barcote Close
    Redhouse
    SN25 2BH Swindon
    Wiltshire
    Diretor
    23 Barcote Close
    Redhouse
    SN25 2BH Swindon
    Wiltshire
    British83845440002
    RAYNER, Paul Adrian
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    Diretor
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish45628680002
    RAYNER, Paul Adrian
    The Well House
    Collins Lane Hursley
    SO21 2JX Winchester
    Hampshire
    Diretor
    The Well House
    Collins Lane Hursley
    SO21 2JX Winchester
    Hampshire
    British45628680001
    SHORE, David Alan
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish116529450001
    STOPPS, Ian Robert, Mr.
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish154207190001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Diretor
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish42825970001
    WILLIFER, Mark Eamon
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish33089100003

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 05/03/2013
    Entregue em 06/03/2013
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the charge holder on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property including goodwill, debts, uncalled capital see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Champlain Cable Corporation
    Transações
    • 06/03/2013Registro de uma garantia (MG01)
    Full form debenture
    Criado em 04/07/2011
    Entregue em 19/07/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Leumi Abl Limited
    Transações
    • 19/07/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 24/03/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 13/08/2010
    Entregue em 25/08/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Leumi Abl Limited
    Transações
    • 25/08/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 24/03/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 27/09/2004
    Entregue em 05/10/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transações
    • 05/10/2004Registro de uma garantia (395)
    • 02/11/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 08/11/2003
    Entregue em 15/11/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Venture Finance PLC
    Transações
    • 15/11/2003Registro de uma garantia (395)
    • 14/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Criado em 05/02/2001
    Entregue em 14/02/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transações
    • 14/02/2001Registro de uma garantia (395)
    • 11/11/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over book debts
    Criado em 06/12/1994
    Entregue em 14/12/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific charge over all book debts and other debts as from time to time be due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/12/1994Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 29/04/1993
    Entregue em 06/05/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 18/12/89
    Breve descrição
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 06/05/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 29/09/1990
    Entregue em 09/10/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 09/10/1990Registro de uma garantia
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 18/12/1989
    Entregue em 02/01/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge on all book & other debts floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 02/01/1990Registro de uma garantia
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 15/07/1988
    Entregue em 21/07/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    First fixed charge as all book and otherdebts floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 21/07/1988Registro de uma garantia
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 10/08/1982
    Entregue em 20/08/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    First food charge over all book & other debts with 9 floating charge over (see doc 34). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 20/08/1982Registro de uma garantia

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    19/07/2012Data da reunião para aprovar o CVA
    01/04/2014Data de finalização ou terminação do CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Eric Walls
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    Profissional
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    2
    DataTipo
    17/04/2013Início da liquidação
    30/09/2017Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    John Stephen Kelmanson
    Brook Point 1412-1420 High Road
    N20 9BH London
    Profissional
    Brook Point 1412-1420 High Road
    N20 9BH London
    Alexander Kinninmonth
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Profissional
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0