SG LEASING (UTILITIES) LIMITED

SG LEASING (UTILITIES) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSG LEASING (UTILITIES) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01364426
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    • Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    C/O Interpath Ltd
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BMI (NO.3) LIMITED31/12/198031/12/1980
    DANNYWELANT LIMITED21/04/197821/04/1978

    Quais são as últimas contas de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 27/06/2022

    7 páginasLIQ03

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    7 páginasLIQ13

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    104 páginasLIQ10

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Endereço do domicílio registado alterado de 10 Fleet Place London EC4M 7QS para C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB em 04/07/2022

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de 15 Canada Square London E14 5GL para 10 Fleet Place London EC4M 7QS em 14/12/2021

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG England para 15 Canada Square London E14 5GL em 14/07/2021

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 28/06/2021

    LRESSP

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Término da nomeação de Lindsay Ginnette Sides como diretor em 04/06/2021

    1 páginasTM01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom para C/O Group Legal One Bank Street London E14 4SG

    1 páginasAD02

    Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/12/2019 para 30/06/2020

    1 páginasAA01

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG para One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG em 18/11/2019

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    30 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Paul Shields como diretor em 20/05/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stuart Donald Cook como diretor em 05/04/2019

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    27 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stephen Lethbridge Fowler em 20/09/2018

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr. Paul Shields como diretor em 19/03/2018

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Quem são os diretores de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BALINSKA-JUNDZILL, Catherine
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Secretário
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    191477830001
    DENT, Nicholas Michael
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Diretor
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    United KingdomBritish43922780002
    FOWLER, Stephen Lethbridge
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Diretor
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    EnglandBritish135237620002
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Secretário
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secretário
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secretário
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Diretor
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Diretor
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Diretor
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Diretor
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    COOK, Stuart Donald
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Diretor
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    United KingdomBritish191477240004
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Diretor
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Diretor
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HUCKLE, Jonathan Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish163223760001
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Diretor
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Diretor
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Diretor
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    NIMMO, Mark Alexander
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Diretor
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    EnglandBritish33420600001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Diretor
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SHIELDS, Paul
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Diretor
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    EnglandBritish244361960001
    SIDES, Lindsay Ginnette
    Canary Wharf
    E14 4SG London
    One Bank Street
    England
    Diretor
    Canary Wharf
    E14 4SG London
    One Bank Street
    England
    EnglandBritish212141970001
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Diretor
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish149333050001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Diretor
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Diretor
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001

    Quem são as pessoas com controle significativo de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Société Générale
    Boulevard Haussmann
    75009 Paris
    29
    France
    06/04/2016
    Boulevard Haussmann
    75009 Paris
    29
    France
    Não
    Forma jurídicaSociété Anonyme (French Public Limited Company)
    País de registroFrance
    Autoridade legalFrench Monetary And Financial Code And French Commercial Code
    Local de registroRegistre Du Commerce Et Des Sociétés - Greffe Du Tribunal De Commerce De Paris (Infogreffe - Les Greffes Des Tribunaux De Commerce)
    Número de registro552 120 222 00013 (Trade Register: 552 120 222 R.C.S. Paris)
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    SG LEASING (UTILITIES) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Secondary lease security assignment
    Criado em 30/12/1992
    Entregue em 14/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due from i/s scantrack and/or ole soeberg to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30.12.92
    Breve descrição
    All rights,title and interest in the agreements and all sums payable...............see form 395.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Sub-lessee security agreement
    Criado em 30/12/1992
    Entregue em 14/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease and the head lease both dated 24.11.92
    Breve descrição
    All rights,title and interest under the agreements......all proceeds receivable.....see form 395.
    Pessoas com direito
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transações
    • 14/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    First priority statutory mortgage
    Criado em 18/12/1986
    Entregue em 07/01/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement and a deed of covenant both dated 18.12.86
    Breve descrição
    64/64TH shares of and in the motor vessel "arco avon" registered in the name of the company at the port of southampton. Under official no 711642.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/01/1987Registro de uma garantia
    • 18/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of covenant
    Criado em 18/12/1986
    Entregue em 07/01/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £5,800,000 all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 18.12.86 and all other monies due or to become due under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement dated 18.12.86 and this deed
    Breve descrição
    The motor vessel "arco avon" registered at the port of southampton under official no 711642 including any share of interest therein and her engines machinery boats tackle outfit share gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board ar ashore (the "ship") all the companys joint on other interests in and all benefits of policies and contracts of insurance (please see doc for full details).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/01/1987Registro de uma garantia
    • 18/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Financial agreement
    Criado em 11/10/1985
    Entregue em 14/10/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £5,800,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a building contract dated 31 may '85 and novation agreement dated 11 oct 1985
    Breve descrição
    All the company's beneficial interest and all its rights and titles in the contract including the vessel and all moneys payable (see doc M37 for full details).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/10/1985Registro de uma garantia
    • 18/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Shipowners agreement
    Criado em 01/10/1985
    Entregue em 14/10/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a shipowners agreement
    Breve descrição
    Any moneys payable to the company in accordance with the terms of clause 9(b) or 15(b) of the financial agreement dated 11.10.85 (for full details see doc M36).
    Pessoas com direito
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transações
    • 14/10/1985Registro de uma garantia
    • 18/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of covenant
    Criado em 18/03/1985
    Entregue em 03/04/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee secured by a mortgage 18.3.85 under the terms of a guarantee facility agreement 18.3.85
    Breve descrição
    All the companys interest in M.v "itm installer" see doc for fuller details.
    Pessoas com direito
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transações
    • 03/04/1985Registro de uma garantia
    • 18/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    First priority statutory mortgage
    Criado em 18/03/1985
    Entregue em 03/04/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant 18.3.85 and pursuant to a guarantee facility agreement 18.3.85
    Breve descrição
    64/64TH shares in M.V. "itm installer" registered number 703418 together with her boats and appurtenances.
    Pessoas com direito
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transações
    • 03/04/1985Registro de uma garantia
    • 18/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Assignment
    Criado em 28/02/1985
    Entregue em 12/03/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on behalf of the banks under clause 3.01 of the interim boeing counter indemnity agreement dated 28 february 1985
    Breve descrição
    All the company's right title, interest and benefits in and to all moneys that may be or become payable by the boeing company to the company under articles 2.1(d) and 5.4 of part b of the purchase agreement dated 28.2.85 between the boeing company, british airways PLC and the company.
    Pessoas com direito
    • Chemical Bank.
    Transações
    • 12/03/1985Registro de uma garantia
    • 18/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)

    SG LEASING (UTILITIES) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    28/06/2021Início da liquidação
    21/10/2022Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profissional
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0