SG LEASING (UTILITIES) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SG LEASING (UTILITIES) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01364426 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
- Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| BMI (NO.3) LIMITED | 31/12/1980 | 31/12/1980 |
| DANNYWELANT LIMITED | 21/04/1978 | 21/04/1978 |
Quais são as últimas contas de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2018 |
Quais são as últimas submissões para SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 27/06/2022 | 7 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Remoção do liquidatário por ordem judicial | 104 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 10 Fleet Place London EC4M 7QS para C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB em 04/07/2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 15 Canada Square London E14 5GL para 10 Fleet Place London EC4M 7QS em 14/12/2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG England para 15 Canada Square London E14 5GL em 14/07/2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de solvência | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Término da nomeação de Lindsay Ginnette Sides como diretor em 04/06/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom para C/O Group Legal One Bank Street London E14 4SG | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/12/2019 para 30/06/2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG para One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG em 18/11/2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2018 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Paul Shields como diretor em 20/05/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Stuart Donald Cook como diretor em 05/04/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Stephen Lethbridge Fowler em 20/09/2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nomeação de Mr. Paul Shields como diretor em 19/03/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Quem são os diretores de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALINSKA-JUNDZILL, Catherine | Secretário | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | 191477830001 | |||||||
| DENT, Nicholas Michael | Diretor | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | United Kingdom | British | 43922780002 | |||||
| FOWLER, Stephen Lethbridge | Diretor | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | England | British | 135237620002 | |||||
| RUFFELL, Lara Catherine | Secretário | 23 Meadowlands Chineham RG24 8XL Basingstoke Hampshire | British | 69140140002 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Secretário | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Secretário | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| AKRAM, Mohammed | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 169142800001 | |||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Diretor | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOX, Sarah | Diretor | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Diretor | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| CLARK, Thomas Martin | Diretor | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| COOK, Stuart Donald | Diretor | c/o C/O Group Legal House 41 Tower Hill EC3N 4SG London Sg United Kingdom | United Kingdom | British | 191477240004 | |||||
| DOWDING, Eric Robert | Diretor | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| ELLIS, David James | Diretor | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| EVANS, Christopher Hewitt | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 121774150001 | ||||||
| HARE, Darren Mark | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 127470250001 | |||||
| HUCKLE, Jonathan Mark | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 163223760001 | |||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 69140360004 | |||||
| LEWIS, Barry Randall | Diretor | 37 Main Road Littleton SO22 6QJ Winchester Hampshire | England | British | 145163830001 | |||||
| MACINTOSH, Gordon Paterson | Diretor | 7 Paddock Field Chilbolton SO20 6AU Stockbridge Hampshire | British | 25737780001 | ||||||
| MCMILLAN, Richard John | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 68601920003 | ||||||
| MILES, Martin Graham | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 108439150001 | |||||
| MILLINER, Craig | Diretor | 21 Smithson Close Talbot Village BH12 5EY Poole Dorset | British | 144700710001 | ||||||
| NIMMO, Mark Alexander | Diretor | c/o C/O Group Legal House 41 Tower Hill EC3N 4SG London Sg United Kingdom | England | British | 33420600001 | |||||
| RIDOUT, Thomas Geoffrey | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 155056490001 | |||||
| ROSE, Stephen George | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 143870380001 | ||||||
| ROWAN, Charles Paul | Diretor | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| ROWBERRY, Duncan John | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 49237880004 | |||||
| SHIELDS, Paul | Diretor | c/o C/O Group Legal House 41 Tower Hill EC3N 4SG London Sg | England | British | 244361960001 | |||||
| SIDES, Lindsay Ginnette | Diretor | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | England | British | 212141970001 | |||||
| SILCOCK, Frank Avis | Diretor | Charleston 74 Wellhouse Road Beech GU34 4AG Alton Hampshire | British | 32895910001 | ||||||
| SIMPSON, Gavin John | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 149333050001 | |||||
| WATSON, Hazel Anne Marie | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | Irish | 122291210001 | |||||
| WEAL, Barry | Diretor | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Diretor | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société Générale | 06/04/2016 | Boulevard Haussmann 75009 Paris 29 France | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
SG LEASING (UTILITIES) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Secondary lease security assignment | Criado em 30/12/1992 Entregue em 14/01/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due from i/s scantrack and/or ole soeberg to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30.12.92 | |
Breve descrição All rights,title and interest in the agreements and all sums payable...............see form 395. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Sub-lessee security agreement | Criado em 30/12/1992 Entregue em 14/01/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido The performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease and the head lease both dated 24.11.92 | |
Breve descrição All rights,title and interest under the agreements......all proceeds receivable.....see form 395. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| First priority statutory mortgage | Criado em 18/12/1986 Entregue em 07/01/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement and a deed of covenant both dated 18.12.86 | |
Breve descrição 64/64TH shares of and in the motor vessel "arco avon" registered in the name of the company at the port of southampton. Under official no 711642. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of covenant | Criado em 18/12/1986 Entregue em 07/01/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £5,800,000 all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 18.12.86 and all other monies due or to become due under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement dated 18.12.86 and this deed | |
Breve descrição The motor vessel "arco avon" registered at the port of southampton under official no 711642 including any share of interest therein and her engines machinery boats tackle outfit share gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board ar ashore (the "ship") all the companys joint on other interests in and all benefits of policies and contracts of insurance (please see doc for full details). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Financial agreement | Criado em 11/10/1985 Entregue em 14/10/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £5,800,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a building contract dated 31 may '85 and novation agreement dated 11 oct 1985 | |
Breve descrição All the company's beneficial interest and all its rights and titles in the contract including the vessel and all moneys payable (see doc M37 for full details). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Shipowners agreement | Criado em 01/10/1985 Entregue em 14/10/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a shipowners agreement | |
Breve descrição Any moneys payable to the company in accordance with the terms of clause 9(b) or 15(b) of the financial agreement dated 11.10.85 (for full details see doc M36). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of covenant | Criado em 18/03/1985 Entregue em 03/04/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee secured by a mortgage 18.3.85 under the terms of a guarantee facility agreement 18.3.85 | |
Breve descrição All the companys interest in M.v "itm installer" see doc for fuller details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| First priority statutory mortgage | Criado em 18/03/1985 Entregue em 03/04/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant 18.3.85 and pursuant to a guarantee facility agreement 18.3.85 | |
Breve descrição 64/64TH shares in M.V. "itm installer" registered number 703418 together with her boats and appurtenances. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Assignment | Criado em 28/02/1985 Entregue em 12/03/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on behalf of the banks under clause 3.01 of the interim boeing counter indemnity agreement dated 28 february 1985 | |
Breve descrição All the company's right title, interest and benefits in and to all moneys that may be or become payable by the boeing company to the company under articles 2.1(d) and 5.4 of part b of the purchase agreement dated 28.2.85 between the boeing company, british airways PLC and the company. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
SG LEASING (UTILITIES) LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0