ANKER SYSTEMS

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaANKER SYSTEMS
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada de responsabilidade ilimitada
    Número da empresa 01365105
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ANKER SYSTEMS?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica ANKER SYSTEMS?

    Endereço do escritório registrado
    Oracle Parkway
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Berkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ANKER SYSTEMS?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ANKER SYSTEMS LIMITED31/03/200031/03/2000
    RIVA SYSTEMS LIMITED26/09/198826/09/1988
    RIVA TURNKEY COMPUTER SYSTEMS LIMITED31/12/197831/12/1978
    BENCHWORLD LIMITED25/04/197825/04/1978

    Quais são as últimas contas de ANKER SYSTEMS?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2016

    Quais são as últimas submissões para ANKER SYSTEMS?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas de isenção total preparadas até 30/06/2016

    11 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Re-registration 22/12/2016
    RES13

    Certificado de re-registo de sociedade limitada para sociedade em nome colectivo

    1 páginasCERT3

    Aprovação de re-registo

    1 páginasFOA-RR

    Re-registo do memorando e estatutos

    38 páginasMAR

    Re-registo de uma sociedade de responsabilidade limitada para uma sociedade privada de responsabilidade ilimitada

    1 páginasRR05

    Declaração de confirmação apresentada em 05/12/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2015

    22 páginasAA

    Declaração anual preparada até 05/12/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital07/12/2015

    Estado do capital em 07/12/2015

    • Capital: GBP 500,001
    SH01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2014

    25 páginasAA

    Declaração anual preparada até 05/12/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/01/2015

    Estado do capital em 02/01/2015

    • Capital: GBP 500,001
    SH01

    Término da nomeação de Stephen Walder como diretor em 26/11/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Cynthia Russo como diretor em 26/11/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Frank Peter Ward como diretor em 26/11/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stephen Walder como secretário em 26/11/2014

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Kaweh Niroomand como diretor em 26/11/2014

    1 páginasTM01

    Nomeação de Oracle Corporation Nominees Limited como diretor em 26/11/2014

    2 páginasAP02

    Nomeação de Mr David James Hudson como diretor em 26/11/2014

    2 páginasAP01

    Endereço do domicílio registado alterado de 6-8 the Grove Slough Berkshire SL1 1QP para Oracle Parkway Thames Valley Park Reading Berkshire RG6 1RA em 01/12/2014

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2013

    25 páginasAA

    Declaração anual preparada até 05/12/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/01/2014

    Estado do capital em 02/01/2014

    • Capital: GBP 500,001
    SH01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2012

    25 páginasAA

    Quem são os diretores de ANKER SYSTEMS?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HUDSON, David James
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Diretor
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    EnglandBritish100987010002
    ORACLE CORPORATION NOMINEES LIMITED
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Diretor
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro03062158
    118326710001
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    Secretário
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    British3699700001
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    Secretário
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New Zealander126903810001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Secretário
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Secretário
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Other123425810001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Secretário
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Other123425810001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Secretário
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    Secretário
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    British39173700002
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    Secretário
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    British115960470001
    WALDER, Stephen
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    Secretário
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    British169959800001
    ABDO, Ashley
    63 West Ranch Trail
    CO80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    Diretor
    63 West Ranch Trail
    CO80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    American90157130001
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    Diretor
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    British3699700001
    APPLETON, Colin Arthur
    15 The Coppice
    Cuddington
    CW8 2XF Northwich
    Cheshire
    Diretor
    15 The Coppice
    Cuddington
    CW8 2XF Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish19964370001
    BAILEY, James R
    1000 Rock Ridge Lane
    Loveland
    Colorado
    80537
    Usa
    Diretor
    1000 Rock Ridge Lane
    Loveland
    Colorado
    80537
    Usa
    American69700010001
    BAKER, Jeremy David
    16 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    16 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    British51244270001
    BUTCHER, Steve John
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    Diretor
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish203318870001
    CALLAGHAN, Stephen James
    The Grove
    SL1 1QP Slough
    6-8
    Berkshire
    Diretor
    The Grove
    SL1 1QP Slough
    6-8
    Berkshire
    EnglandBritish87418990003
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    Diretor
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New Zealander126903810001
    COOKSLEY, Graeme
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    Diretor
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    New Zealander122786180001
    DOBIE, Timothy Arthur Ross
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    Diretor
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish97704830001
    DOBSON, Melvyn John
    42 Ravens Wood
    Chorley New Road Heaton
    BL1 5TL Bolton
    Diretor
    42 Ravens Wood
    Chorley New Road Heaton
    BL1 5TL Bolton
    British45852970001
    DURKIN, Ivan Paul
    11 Stapleford Close
    BL8 2UG Bury
    Lancashire
    Diretor
    11 Stapleford Close
    BL8 2UG Bury
    Lancashire
    British51244360001
    EARHART, Stephen
    Brittens Lane
    Salford
    MK17 8BE Milton Keynes
    1
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Diretor
    Brittens Lane
    Salford
    MK17 8BE Milton Keynes
    1
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United States133153450001
    FOULKES, John Harold
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    Diretor
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    British1657980007
    GILDART, Steven
    12 Ennerdale Road
    Astley Tyldesley
    M29 7AR Manchester
    Diretor
    12 Ennerdale Road
    Astley Tyldesley
    M29 7AR Manchester
    British51244420001
    GILES, Peter Hardwick
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish35521860001
    GRADDEN, Amanda Jane
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    Diretor
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    EnglandBritish77425910003
    GREENOUGH, Michael
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Diretor
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Canadian123427350001
    HAYES, Laurence
    15 Heald Cottages
    Judith Street Lowerfold
    OL12 7HS Rochdale
    Lancashire
    Diretor
    15 Heald Cottages
    Judith Street Lowerfold
    OL12 7HS Rochdale
    Lancashire
    British51244430001
    HIRANO, Michael
    139 Eagle Canyon Circle
    PO BOX 1925
    CO80540 Lyons
    Colorado
    Usa
    Diretor
    139 Eagle Canyon Circle
    PO BOX 1925
    CO80540 Lyons
    Colorado
    Usa
    American90157180001
    HOLLENBECK, David Arthur
    5166 Buckingham Road
    CO80301 Boulder
    Colorado
    Usa
    Diretor
    5166 Buckingham Road
    CO80301 Boulder
    Colorado
    Usa
    American90157320001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Diretor
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Diretor
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    UsaOther123425810001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    Diretor
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish39173700002

    Quem são as pessoas com controle significativo de ANKER SYSTEMS?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    06/04/2016
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom (England And Wales)
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro6273940
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    ANKER SYSTEMS possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 21/10/2009
    Entregue em 02/11/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Burdale Financial Limited
    Transações
    • 02/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 12/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture (the "agreement")
    Criado em 28/01/2000
    Entregue em 09/02/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents (including the agreement)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Commerzbank Ag London Branchas Trustee for the Beneficiaries (As Defined Inschedule 1)
    Transações
    • 09/02/2000Registro de uma garantia (395)
    • 08/03/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 18/08/1999
    Entregue em 24/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transações
    • 24/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 08/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of adherence
    Criado em 12/05/1992
    Entregue em 14/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13TH april 1992 the composite debenture dated 26TH april 1990 and any other security documents (as defined)
    Breve descrição
    The charged assets as defined in the original charge see form 395 ref M563C.
    Pessoas com direito
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transações
    • 14/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 06/01/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Second supplemental deed
    Criado em 12/05/1992
    Entregue em 14/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13 april 1992 the composite debenture dated 26 april 1990 or any other security document (as defined)
    Breve descrição
    The charges and assignments contained inclause 2 of the original debenture DATED26 april 1990.
    Pessoas com direito
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transações
    • 14/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 06/01/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed
    Criado em 13/04/1992
    Entregue em 30/04/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from theriva group PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the finance documents as defined
    Breve descrição
    See form 395 ref M90. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Co-Operative Bank Plcmilneas Agent and Trustee for Itself the Banks and Mr
    Transações
    • 30/04/1992Registro de uma garantia (395)
    • 08/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed
    Criado em 12/08/1991
    Entregue em 20/08/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility to the dated 23RD april 1990 and any other security document (as defined)
    Breve descrição
    (See form 395- ref M135 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Fbg Holdings (U.K.) Limited
    Transações
    • 20/08/1991Registro de uma garantia
    • 06/01/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental debenture
    Criado em 13/05/1991
    Entregue em 29/05/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from riva group PLC to the chargee under each of the finance documents as defined
    Breve descrição
    (See doc M148 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Co-Operative Bank PLC.
    Transações
    • 29/05/1991Registro de uma garantia
    • 08/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantees & mortgage debenture
    Criado em 26/04/1990
    Entregue em 08/05/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this charge and any other security document
    Breve descrição
    (See doc M228 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transações
    • 08/05/1990Registro de uma garantia
    • 06/01/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 09/11/1989
    Entregue em 30/11/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from hugin sweda group (as defined) under the terms of each of the finance documents and/or the swedish loan agreements as defined to the chargee.
    Breve descrição
    All dividends paid or payable after the date of the debenture and all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, money or property. (See form m 395 ref m 849C for full details).
    Pessoas com direito
    • The Co-Operative Bank Plcined)(As Agent for and on Behalf of the Banks, as Def
    Transações
    • 30/11/1989Registro de uma garantia
    • 08/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 11/09/1987
    Entregue em 22/09/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £133,000.00 and all other monies due or to become due from the and alistair scott petrie and barbara ann petrie company to the chargee
    Breve descrição
    1, the farthings, marcham abingdon, oxfordshire. T/n:- on 60470. and all fixtures thereon and additions thereto.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 22/09/1987Registro de uma garantia
    • 25/08/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 28/01/1982
    Entregue em 04/02/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed amd floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 04/02/1982Registro de uma garantia
    • 25/08/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 20/06/1980
    Entregue em 24/06/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. And all fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 24/06/1980Registro de uma garantia
    • 25/08/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0