HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED

HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED
    Estado da empresaConvertida/Fechada
    Forma jurídicaConvertida ou extinta
    Número da empresa 01377801
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HOUSE OF TRAVEL (WALES) LIMITED19/06/199219/06/1992
    C T C TOURS (WALES) LTD31/12/198131/12/1981
    COLLEGE TRANSPORT (GWENT) LIMITED10/07/197810/07/1978

    Quais são as últimas contas de HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até11/01/2015

    Qual é o status da última declaração anual para HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diversos

    Forms b & z convert to rs
    2 páginasMISC

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Convert to rs 28/07/2016
    RES13

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed house of travel (wales) LIMITED\certificate issued on 22/07/16
    2 páginasCERTNM
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 08/06/2016

    • Capital: GBP 319,564
    3 páginasSH01

    Satisfação total da garantia 4

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 7

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 6

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 8

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 9

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    1 páginasMR04

    Declaração anual preparada até 01/09/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/09/2015

    Estado do capital em 02/09/2015

    • Capital: GBP 319,562
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 11/01/2015

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/09/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/09/2014

    Estado do capital em 02/09/2014

    • Capital: GBP 319,562
    SH01

    Término da nomeação de Patrick Moynihan como diretor em 30/06/2014

    1 páginasTM01

    Nomeação de Andrew Paul Lang como diretor em 30/06/2014

    2 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 11/01/2014

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/09/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/09/2013

    Estado do capital em 04/09/2013

    • Capital: GBP 319,562
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Patrick Moynihan em 01/09/2013

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Cws (No.1) Limited em 01/09/2013

    2 páginasCH02

    Detalhes do secretário alterados para Mrs Caroline Jane Sellers em 01/09/2013

    2 páginasCH03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 11/01/2013

    3 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de * New Century House Manchester M60 4ES* em 03/12/2012

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 01/09/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 11/01/2012

    3 páginasAA

    Quem são os diretores de HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Secretário
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    British45801060004
    LANG, Andrew Paul
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish170146830001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Diretor
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro1925625
    130695310001
    BELL LANGFORD, Diana Beverley
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Secretário
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British38495160002
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Secretário
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    WHITTAKER, Katherine Alison
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    Secretário
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    British29899300001
    WRIGHT, Wiliam Thomas
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Secretário
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British26223750001
    BELL LANGFORD, David James
    1 Cae Pen Y Graig
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Diretor
    1 Cae Pen Y Graig
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British67740010001
    BELL LANGFORD, Diana Beverley
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Diretor
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British38495160002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Diretor
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    COOMBS, Clive
    19 Ely Street
    CF40 1BY Tonypandy
    Mid Glamorgan
    Diretor
    19 Ely Street
    CF40 1BY Tonypandy
    Mid Glamorgan
    British24868440001
    GREENACRE, Michael David
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    Diretor
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    EnglandBritish74808750001
    HEMINGWAY, Paul Andrew
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    Diretor
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    United KingdomBritish188221460001
    MCPHERSON, Kenneth
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Diretor
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish224051820001
    MELLING, Christopher Eric
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    Diretor
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish58695390001
    MOYNIHAN, Patrick
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Diretor
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    United KingdomBritish87719730001
    PERRIN, Nicholas John
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    Diretor
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    British80173660001
    RANKIN, Yvonne Rose
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    Diretor
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    British107621540001
    SCOTT, Maurice
    39 Woodland Park
    OL2 5UY Royton
    Lancashire
    Diretor
    39 Woodland Park
    OL2 5UY Royton
    Lancashire
    EnglandBritish107500770001
    WILLIAMS, Amanda Jane
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    Diretor
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    British87240350002
    WRIGHT, Wiliam Thomas
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Diretor
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British26223750001

    HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal charge
    Criado em 13/12/2000
    Entregue em 20/12/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    197 high street treorchy rhondda cynon taf t/n WA712653.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/12/2000Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 13/12/2000
    Entregue em 20/12/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    53 hannah st,porth,rhondda cynon taf; t/no WA135149.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/12/2000Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 12/05/1998
    Entregue em 22/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    21 oxford street mountain ash mid glamorgan.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 22/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 10/11/1997
    Entregue em 13/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    25 beaufort street brynmawr gwent t/no.WA502437.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 28/08/1996
    Entregue em 03/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    121A dunraven street tonypandy rhondda cynon taff t/n WA793892.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/09/1996Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 02/10/1995
    Entregue em 10/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 10/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Mortgage
    Criado em 29/03/1994
    Entregue em 15/04/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £16,000 due from the company to the chargee
    Breve descrição
    F/H property at 197 high street treorchy mid glamorgan.
    Pessoas com direito
    • Alan Roderick Hawkins
    Transações
    • 15/04/1994Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 21/12/1988
    Entregue em 29/12/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/12/1988Registro de uma garantia
    • 12/11/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/11/1985
    Entregue em 02/12/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 02/12/1985Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0