AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED

AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaAZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01395758
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    54 Portland Place
    W1B 1DY London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    AEGIS INFORMATION SERVICES LIMITED30/01/201030/01/2010
    CARAT GLOBAL MANAGEMENT LIMITED14/09/200614/09/2006
    CARAT INTERNATIONAL LIMITED01/01/199501/01/1995
    MJP CARAT INTERNATIONAL LTD08/11/199008/11/1990
    MICHAEL JARVIS & PARTNERS LIMITED31/12/197931/12/1979
    COOPERSGATE LIMITED25/10/197825/10/1978

    Quais são as últimas contas de AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2021

    Quais são as últimas submissões para AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    2 páginasDS01

    Término da nomeação de Daniel Tullin Finke como diretor em 31/12/2022

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 21/10/2022 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas consolidadas preparadas até 31/12/2021

    51 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Estado do capital em 22/08/2022

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Prevent a director decision-making disapplied 19/08/2022
    RES13

    Endereço do domicílio registado alterado de Maxis 1 Western Road Bracknell RG12 1RT England para 54 Portland Place London W1B 1DY em 26/05/2022

    1 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de 54 Portland Place London W1B 1DY England para Maxis 1 Western Road Bracknell RG12 1RT em 23/05/2022

    1 páginasAD01

    Contas consolidadas preparadas até 31/12/2020

    51 páginasAA

    Nomeação de Mr Luigi Sacchetti como diretor em 26/04/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Anna Christina Torres Gomez como diretor em 25/04/2022

    1 páginasTM01

    Nomeação de Anna Christina Torres Gomez como diretor em 01/11/2021

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 21/10/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Gavin John Thistlethwaite em 07/10/2021

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Gavin John Thistlethwaite em 07/10/2021

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr. Daniel Tullin Finke em 07/10/2021

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Brian William Coderre como diretor em 31/07/2021

    1 páginasTM01

    Estado do capital em 30/06/2021

    • Capital: GBP 2,122
    5 páginasSH19

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    23/06/2021
    RES13

    Quem são os diretores de AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BROUGHTON SECRETARIES LIMITED
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    Secretário
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro04569914
    86181860001
    BENNETT, Susan Elizabeth
    Suite 1500
    Chicago, Il 60601
    203 North Lasalle Street
    United States
    Diretor
    Suite 1500
    Chicago, Il 60601
    203 North Lasalle Street
    United States
    United StatesAmericanAttorney240483090001
    JOHNS, Kenneth Russell
    Suite 1500
    Chicago, Il 60601
    203 North Lasalle Street
    United States
    Diretor
    Suite 1500
    Chicago, Il 60601
    203 North Lasalle Street
    United States
    United StatesAmericanSvp Tax181344050001
    SACCHETTI, Luigi
    Western Road
    RG12 1RF Bracknell
    Maxis 1
    England
    Diretor
    Western Road
    RG12 1RF Bracknell
    Maxis 1
    England
    EnglandBritish,ItalianChief Financial Officer294735580001
    THISTLETHWAITE, Gavin John
    Western Road
    RG12 1RT Bracknell
    Maxis 1
    Berkshire
    England
    Diretor
    Western Road
    RG12 1RT Bracknell
    Maxis 1
    Berkshire
    England
    EnglandBritishFinance Director240467330001
    FROGLEY, Susan Clare
    4 Dulwich Oaks Place
    College Road
    SE21 7NA London
    Secretário
    4 Dulwich Oaks Place
    College Road
    SE21 7NA London
    British20441790003
    FROGLEY, Susan Clare
    89 Briarwood Road
    Clapham
    SW4 9PJ London
    Secretário
    89 Briarwood Road
    Clapham
    SW4 9PJ London
    BritishCfo20441790002
    LATTER, Stephen John
    1 Green Grove
    BN27 3NZ Hailsham
    East Sussex
    Secretário
    1 Green Grove
    BN27 3NZ Hailsham
    East Sussex
    BritishAccountant31332040001
    MOBERLY, Andrew John
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Secretário
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    153841880001
    POWLEY, Roger Peter
    9 Alleyn Park
    Dulwich
    SE21 8AU London
    Secretário
    9 Alleyn Park
    Dulwich
    SE21 8AU London
    British9781820001
    PRICE, Paul Leslie
    110 Swan Lane
    N20 0PP London
    Secretário
    110 Swan Lane
    N20 0PP London
    BritishChartered Accountant32968340001
    ROSS, John Howard
    9 Skinners Street
    CM23 4GS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secretário
    9 Skinners Street
    CM23 4GS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary2826100002
    ROSS, John Howard
    16 Sandle Road
    CM23 5HY Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secretário
    16 Sandle Road
    CM23 5HY Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary2826100001
    THOMAS, Caroline Emma Roberts
    Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    5
    United Kingdom
    Secretário
    Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    5
    United Kingdom
    146789590001
    AKINLA, Bernard Akinwale
    1 Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    C/O Information Resources (Uk) Ltd
    Berkshire
    England
    Diretor
    1 Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    C/O Information Resources (Uk) Ltd
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishDirector246900250001
    BROWN, Graham Alan
    Second Floor Flat
    18 Upper Addison Gardens
    W14 8AP London
    Diretor
    Second Floor Flat
    18 Upper Addison Gardens
    W14 8AP London
    BritishDirector57086780001
    BUHLMANN, Jeremy Martin
    Shrubbs Farm
    Ford Road, Chobham
    GU24 8SS Woking
    Surrey
    Diretor
    Shrubbs Farm
    Ford Road, Chobham
    GU24 8SS Woking
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director68106880003
    CODERRE, Brian William
    Suite 1500
    Chicago, Il 60601
    203 North Lasalle Street
    United States
    Diretor
    Suite 1500
    Chicago, Il 60601
    203 North Lasalle Street
    United States
    United StatesAmericanDirector257977620001
    DAVIS, Crispen Henry, Sir
    Hills End
    Titlarks Hill
    SL5 0JD Sunningdale
    Berkshire
    Diretor
    Hills End
    Titlarks Hill
    SL5 0JD Sunningdale
    Berkshire
    BritishChief Executive Officer141954150001
    DRANCOURT, Eric
    101 Av D La Bourdmannais
    Paris
    FOREIGN France
    75007
    Diretor
    101 Av D La Bourdmannais
    Paris
    FOREIGN France
    75007
    FrenchCompany Director44776890002
    DUFFEY, Michael Stephen
    Arlington Square
    RG12 1WA Bracknell
    1
    Berks
    Diretor
    Arlington Square
    RG12 1WA Bracknell
    1
    Berks
    UsaAmericanCfo131167030001
    FINKE, Daniel Tullin, Mr.
    Western Road
    RG12 1RT Bracknell
    Maxis 1
    Berkshire
    England
    Diretor
    Western Road
    RG12 1RT Bracknell
    Maxis 1
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishManaging Director189003760001
    FINNEGAN, Anthony Paul
    75 Cecil Park
    HA5 5HL Pinner
    Middlesex
    Diretor
    75 Cecil Park
    HA5 5HL Pinner
    Middlesex
    BritishCompany Director31332080001
    FLYNN, Douglas Ronald
    7 Alleyn Park
    SE21 8AU London
    Diretor
    7 Alleyn Park
    SE21 8AU London
    AustralianCompany Director68122700001
    FROGLEY, Susan Clare
    4 Dulwich Oaks Place
    College Road
    SE21 7NA London
    Diretor
    4 Dulwich Oaks Place
    College Road
    SE21 7NA London
    United KingdomBritishDirector20441790003
    FROGLEY, Susan Clare
    4 Dulwich Oaks Place
    College Road
    SE21 7NA London
    Diretor
    4 Dulwich Oaks Place
    College Road
    SE21 7NA London
    United KingdomBritishCfo20441790003
    GOMEZ, Anna Christina Torres
    Suite 1500
    60601 Chicago
    203 North Lasalle Street
    Il
    United States
    Diretor
    Suite 1500
    60601 Chicago
    203 North Lasalle Street
    Il
    United States
    United StatesAmericanDirector290781880001
    HICKEY, Georgina Anne
    Flat 1
    9a St Johns Wood High Street
    NW8 London
    Diretor
    Flat 1
    9a St Johns Wood High Street
    NW8 London
    BritishCompany Director48426530001
    JACOBS, Brian David Lewis
    4 Holroyd Road
    SW15 6LN London
    Diretor
    4 Holroyd Road
    SW15 6LN London
    EnglandBritishCompany Director89959450001
    JARVIS, Michael Ernest
    16 Ashlone Road
    Putney
    SW15 1LR London
    Diretor
    16 Ashlone Road
    Putney
    SW15 1LR London
    BritishCompany Director21472240001
    JONES, Simon Glyndon
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Diretor
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director134832320001
    KELLY, Raymond Frank
    Cairngorm Cavendish Road
    St Georges Hill
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    Diretor
    Cairngorm Cavendish Road
    St Georges Hill
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector9781790001
    LATTER, Stephen John
    Glendene
    North Street
    BN27 4DR Horsebridge
    East Sussex
    Diretor
    Glendene
    North Street
    BN27 4DR Horsebridge
    East Sussex
    United KingdomBritishCfo88491570001
    LATTER, Stephen John
    1 Green Grove
    BN27 3NZ Hailsham
    East Sussex
    Diretor
    1 Green Grove
    BN27 3NZ Hailsham
    East Sussex
    BritishAccountant31332040001
    NAPIER, John Alan
    Church Road
    Fingringhoe
    CO5 7BN Colchester
    The Mill
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    Church Road
    Fingringhoe
    CO5 7BN Colchester
    The Mill
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector179102060002

    Quem são as pessoas com controle significativo de AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    03/06/2019
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    Sim
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro08665262
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    06/04/2016
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    Sim
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro8665515
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    03/08/2020A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.
    01/06/201701/02/2018A empresa ainda não concluiu as medidas razoáveis para determinar se existe alguma pessoa que seja uma pessoa registável ou uma entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    AZTEC INFORMATION SERVICES HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Supplemental composite guarantee and charge
    Criado em 23/06/1995
    Entregue em 30/06/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Societe Generaleas Trustee and Agent for the Banks
    Transações
    • 30/06/1995Registro de uma garantia (395)
    • 15/10/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental composite guarantee and charge
    Criado em 23/06/1995
    Entregue em 29/06/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the "charges" (as defined in the charge)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Trustee and Agent for the Banks
    Transações
    • 29/06/1995Registro de uma garantia (395)
    • 12/06/2010Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 14/07/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite guarantee and charge
    Criado em 17/11/1993
    Entregue em 24/11/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement dated 10TH november 1993 and this charge
    Breve descrição
    All stocks shares and/or other securities of the companies specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Societe Generale
    Transações
    • 24/11/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/10/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental composite guarantee & charge
    Criado em 12/11/1993
    Entregue em 25/11/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the "facilities" (as defined) and this charge
    Breve descrição
    All of the company's stocks shares and/or other obligations as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co.Limitedas Agent and Trustee for the Banks
    Transações
    • 25/11/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/10/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and charge
    Criado em 14/09/1992
    Entregue em 25/09/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the composite guaranteeand charge and the facility agreement dated 7TH may 1991
    Breve descrição
    First floating charge over undertaking and all other property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future including stock in trade the deposit in relation to the charged property see form 395 ref M101.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Trustee and Agent for the Banks
    Transações
    • 25/09/1992Registro de uma garantia (395)
    • 15/10/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 28/11/1987
    Entregue em 16/12/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/12/1987Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 04/06/1987
    Entregue em 23/06/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £353,466 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the debts agreement of even date this debenture or otherwise.
    Breve descrição
    First legal charge on all f/h & l/h property first fixed charge on goodwill & incalled capital. First floating charges on book debts, bank accounts stock, work in progress, cash & all other undertakings & assets of the company present & futher.
    Pessoas com direito
    • A P a Ventures Ii Limited
    Transações
    • 23/06/1987Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0