NCN 9 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaNCN 9 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01399139
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de NCN 9 LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica NCN 9 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    2 Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    Cheshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de NCN 9 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    WORLD CLASS LEARNING LIMITED07/10/199707/10/1997
    NOVARA LIMITED31/12/198131/12/1981

    Quais são as últimas contas de NCN 9 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até29/03/2013

    Qual é o status da última declaração anual para NCN 9 LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para NCN 9 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Detalhes do diretor alterados para Mr Timothy John Kowalski em 02/09/2014

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 18/08/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/09/2014

    Estado do capital em 03/09/2014

    • Capital: GBP 193,100
    SH01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 29/03/2013

    1 páginasAA

    Declaração anual preparada até 18/08/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital19/08/2013

    Estado do capital em 19/08/2013

    • Capital: GBP 193,100
    SH01

    Término da nomeação de Ivan Bolton como diretor

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/03/2012

    1 páginasAA

    Declaração anual preparada até 18/08/2012 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed world class learning LIMITED\certificate issued on 08/08/12
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name08/08/2012

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15
    change-of-name08/08/2012

    Alteração do nome" por resolução

    NM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Timothy John Kowalski em 27/07/2012

    2 páginasCH01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Agreement 27/06/2012
    RES13

    Nomeação de Mark Ashcroft como secretário

    2 páginasAP03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 01/04/2011

    1 páginasAA

    Término da nomeação de Ivan Bolton como secretário

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 18/08/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Credit agreement 08/02/2011
    RES13

    Endereço do domicílio registado alterado de * Church Bridge House Henry Street Church Accrington Lancashire BB5 4EH* em 21/01/2011

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 02/04/2010

    1 páginasAA

    Declaração anual preparada até 18/08/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Término da nomeação de um diretor

    1 páginasTM01

    Detalhes do secretário alterados para Dr Ivan Joseph Bolton em 18/08/2010

    1 páginasCH03

    Término da nomeação de Christopher Hinton como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Timothy John Kowalski como diretor

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de NCN 9 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretário
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    165369240001
    KOWALSKI, Timothy John
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Diretor
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    UkBritish153335190003
    MAUDSLEY, Philip Binns
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Diretor
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish15967010001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Secretário
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    British14333000007
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Secretário
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    British78151560001
    PIGGOTT, Richard Courtney
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretário
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    British112085820001
    TAYLOR, Frank Brownrigg
    Arden Lodge Station Lane
    Lapworth
    B94 6LT Solihull
    West Midlands
    Secretário
    Arden Lodge Station Lane
    Lapworth
    B94 6LT Solihull
    West Midlands
    British57228790001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Diretor
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish14333000007
    CHAPMAN, Keith
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish143093130001
    CHAPMAN, Richard Jonathan Edward
    Fir Trees Elloughton Dale
    Elloughton
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    Diretor
    Fir Trees Elloughton Dale
    Elloughton
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    British14871980001
    CHERRY, Anthony Peter
    285 Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0RR Beverley
    North Humberside
    Diretor
    285 Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0RR Beverley
    North Humberside
    British27289350001
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Diretor
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritish78151560001
    FORGHAM, John Anthony
    15 Main Street
    Cranswick
    YO25 9QR Driffield
    North Humberside
    Diretor
    15 Main Street
    Cranswick
    YO25 9QR Driffield
    North Humberside
    British33338170001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    Diretor
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritish68474940001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    Diretor
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritish68474940001
    JOHNSON, David Anthony
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    Diretor
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    United KingdomBritish157156750001
    JOLLY, Patrick Edmund
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    Diretor
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    EnglandBritish75327660001
    MACEY, David Charles
    Apartment Number 9 Bishops House
    42 Four Oaks Road
    B74 2UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    Apartment Number 9 Bishops House
    42 Four Oaks Road
    B74 2UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish91745430001
    STOYEL, Rodney
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    Diretor
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    British81630780001
    WOOD, Nicholas
    27 Asher Street
    Felling
    NE10 0AY Gateshead
    Tyne & Wear
    Diretor
    27 Asher Street
    Felling
    NE10 0AY Gateshead
    Tyne & Wear
    British15885680001
    WOOD, Stephen
    The Willows Oldmixon Road Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    Diretor
    The Willows Oldmixon Road Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    British33636730001

    NCN 9 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Supplemental security agreement
    Criado em 28/07/2010
    Entregue em 06/08/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Assigns an agreement being any of the existing facility agreement the new super senior credit agreement the revolving credit agreement and the ancillary facility agreements see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/08/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Deed of accession to the security agreement
    Criado em 16/07/2010
    Entregue em 29/07/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, shares, credit balances, insurances, other contracts see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transações
    • 29/07/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Single debenture
    Criado em 15/11/1990
    Entregue em 03/12/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 03/12/1990Registro de uma garantia
    • 11/02/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattel mortgage
    Criado em 17/08/1989
    Entregue em 24/08/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    FR60 injection moulding machine number 117816 FR60 injection moulding machine number 117723 FR60 injection moulding machine number 117813 KM60 injection moulding machine number 60077 MS120 injection moulding machine number 70741.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/08/1989Registro de uma garantia
    Corporate mortgage
    Criado em 23/03/1989
    Entregue em 03/04/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 3.2.87
    Breve descrição
    F.R. 60 injection moulding machine serial no 117805 two injection moulding tools for 9CM petri dishes manufactures by exfaleoha as per orrembley jrawing number 1.899/900-10-86.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/04/1989Registro de uma garantia
    Corporate mortgage
    Criado em 02/11/1988
    Entregue em 10/11/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 4TH jan 1988
    Breve descrição
    Bekum blow moulding machine bae - 1 serial no. 27712689 (see form 395-ref: M218- for details).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 10/11/1988Registro de uma garantia
    Corporate mortgage
    Criado em 15/12/1983
    Entregue em 30/12/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 16 sept. 1982
    Breve descrição
    One blav moulding machine type UK 1-0,7. one piovan chiller model rcn 120/10 serial no 01300 (see M17 for details).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 30/12/1983Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 19/10/1982
    Entregue em 28/10/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    The goods (herinafter descreibed) the benefit of all contracts, conditionswarranties and agreements all logbooks maintenance records record books and other documents relating to the goods any moneys payable to the company for orin connection with a sale or proposed sale of of any of the goods. 1-Off model s-12 injection bion moulding machine 1-off chiller, 1-off product conveyor(lessana supplied) as described in contract no b 600305 dated 14/09/82.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/10/1982Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 25/09/1981
    Entregue em 05/10/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £30,000 and other monies due under the terms of the charge
    Breve descrição
    Plant & machhinery at unit 9 phase 111 algernon industrial estate shiremoor tyne & wear. Floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill.
    Pessoas com direito
    • Tyne and Wear County Council
    Transações
    • 05/10/1981Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 22/01/1981
    Entregue em 29/01/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capitals all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 29/01/1981Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0