JARVIS TS LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | JARVIS TS LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01412202 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de JARVIS TS LIMITED?
- fabricação de outros equipamentos elétricos (27900) / Indústrias transformadoras
Onde fica JARVIS TS LIMITED?
Endereço do escritório registrado | c/o SECRETARIAT SERVICES LIMITED 17 MONKS BROOK INDUSTRIAL ESTATE School Close Chandlers Ford SO53 4RA Eastleigh |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de JARVIS TS LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
TECHSPAN SYSTEMS LIMITED | 11/02/1993 | 11/02/1993 |
CARTNER ENGINEERING LIMITED | 28/06/1990 | 28/06/1990 |
TECHSPAN ELECTRONICS LIMITED | 12/11/1982 | 12/11/1982 |
VELWARD ELECTRONICS LIMITED | 29/01/1979 | 29/01/1979 |
Quais são as últimas contas de JARVIS TS LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/03/2013 |
Qual é o status da última declaração anual para JARVIS TS LIMITED?
Declaração anual |
|
---|
Quais são as últimas submissões para JARVIS TS LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/07/2013 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/07/2012 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2011 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/07/2011 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Secretariat Services Limited em 12/07/2011 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mark Adeyemi Asagba Akinlade em 12/07/2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Secretariat Services Limited em 16/05/2011 | 3 páginas | CH04 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * Meridian House the Crescent York North Yorkshire YO24 1AW* em 27/05/2011 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2010 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/07/2010 com lista completa de acionistas | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2009 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2008 | 13 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2007 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Renúncia do auditor | 2 páginas | AUD | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b |
Quem são os diretores de JARVIS TS LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretário | c/o Directorate Services Limited Monks Brook Industrial Estate School Close Chandlers Ford SO53 4RA Eastleigh 17 England |
| 70053320013 | ||||||||||
AKINLADE, Mark Adeyemi Asagba | Diretor | The Haven Woodview Close KT21 1HA Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 116740230002 | ||||||||
LAIRD, Stuart Wilson | Diretor | Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane Horton Heath SO50 7DF Eastleigh Hampshire | England | British | Business Advisor | 60742240002 | ||||||||
NOLAN, Richard | Secretário | 17 St Davids Road TN4 9JQ Tunbridge Wells Kent | Irish | 105084670001 | ||||||||||
NYE, Ann Mary | Secretário | Beech Cottage Gorelands Lane HP8 4HQ Chalfont St Giles Bucks | British | 17357120001 | ||||||||||
MINCING LANE CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretário | Pickfords Wharf Clink Street SE1 9DG London | 32940220004 | |||||||||||
BURTON, Ernest Walter | Diretor | 15 Prince Consort Drive BR7 5SB Chislehurst Kent | British | Company Director | 11389700001 | |||||||||
CHARRIER, Claude | Diretor | 2 Bis Rue Joseph Thierry 37230 Luynes France | French | Company Director | 42774510001 | |||||||||
DOYLE, Robert John | Diretor | The Limes 112 Hewarth Green York North Yorkshire | British | Chartered Civil Engineer | 79420210002 | |||||||||
DUNN, John Nigel | Diretor | 46 The Island Wraysbury Bucks | British | Computer Engineer | 23865780001 | |||||||||
DUPONT, Denis | Diretor | 16 Rue Civiale 92380 Garches France | French | Company Director | 98982530001 | |||||||||
GALLAGHER, Daniel Joseph | Diretor | 9 Cavendish Meads Sunninghill SL5 9TB Ascot Berkshire | British And Irish | Director | 49885010001 | |||||||||
GAY, Andrew | Diretor | Bircham Dyson Bell 50 Broadway SW1H 0BL London | United Kingdom | British | Director | 73774260004 | ||||||||
GORDON, Ray | Diretor | 29 Carrs Meadow Escrick YO19 6JZ York North Yorkshire | British | Chartered Quantity Surveyor | 102379260001 | |||||||||
JOHNSON, Robert Nigel | Diretor | 16 Kirkwell Bishopthorpe YO23 2RZ York Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 57954340003 | ||||||||
KENDALL, Robert William | Diretor | 44 Moreland Drive SL9 8BD Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Chartered Accountant | 20374510001 | ||||||||
MASON, Geoffrey Keith Howard | Diretor | Downing House Lower Road SG8 0EG Croydon Royston Cambridgeshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 37404250003 | ||||||||
NYE, Ann Mary | Diretor | Beech Cottage Gorelands Lane HP8 4HQ Chalfont St Giles Bucks | British | Married Woman | 17357120001 | |||||||||
NYE, Richard Alfred | Diretor | Beech Cottage Gorelands Lane HP8 4HQ Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | Computer Consultant | 22791180001 | ||||||||
PIRRET, Gordon Maxwell, Mr. | Diretor | Bradwell Hall CM0 7HX Bradwell On Sea Essex | England | British | Company Director | 30161610003 | ||||||||
PLUMLEY, Xavier Alexander | Diretor | Holly Cottage Hill Farm Road SL6 0HA Taplow Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 51554040001 | |||||||||
RAFIN, Francois | Diretor | L Aitre Des Gauthier 37210 Vernou S Brenne France | French | Company Director | 42789710001 | |||||||||
SIMPSON, Terence Colin Frank | Diretor | Homer Cottage Ipsden OX10 6QS Wallingford Oxfordshire | British | Company Director | 34093540001 | |||||||||
TERRIS, Edward Ambrose | Diretor | Twychelles Brindle Lane Forty Green HP9 1XT Beaconsfield Bucks | American | Company Director | 20867310001 | |||||||||
WESTBROOK, Bernard Leslie | Diretor | 4 Quantock Close Barton Seagrave NN15 6RR Kettering Northamptonshire | England | British | Group Human Resources | 51336870001 | ||||||||
WILLIAMSON, Clive James Murray | Diretor | 19 Padstow Drive Bramhall SK7 2HU Stockport Cheshire | British | Chartered Civil Engineer | 36771760001 | |||||||||
WORTHINGTON, Geoffrey John | Diretor | Tudor House Blackwood Hill Farm Blackwood Hill ST9 9AH Endon Staffordshire | British | Chartered Engineer | 85844580001 |
JARVIS TS LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Criado em 01/02/1995 Entregue em 09/02/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 08/11/1994 Entregue em 22/11/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease dated 30 june 1994 and the deed of variation | |
Breve descrição Rental deposit of £35,000. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 25/07/1989 Entregue em 04/08/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 25/07/1989 Entregue em 04/08/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Hayder house, churchfield road, chalfornt-st-peter bucks. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0