JARVIS TS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaJARVIS TS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01412202
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de JARVIS TS LIMITED?

    • fabricação de outros equipamentos elétricos (27900) / Indústrias transformadoras

    Onde fica JARVIS TS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o SECRETARIAT SERVICES LIMITED 17 MONKS BROOK INDUSTRIAL ESTATE
    School Close
    Chandlers Ford
    SO53 4RA Eastleigh
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de JARVIS TS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    TECHSPAN SYSTEMS LIMITED11/02/199311/02/1993
    CARTNER ENGINEERING LIMITED28/06/199028/06/1990
    TECHSPAN ELECTRONICS LIMITED12/11/198212/11/1982
    VELWARD ELECTRONICS LIMITED29/01/197929/01/1979

    Quais são as últimas contas de JARVIS TS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2013

    Qual é o status da última declaração anual para JARVIS TS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para JARVIS TS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2013

    3 páginasAA

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 12/07/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital09/08/2013

    Estado do capital em 09/08/2013

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2012

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 12/07/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2011

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 12/07/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do secretário alterados para Secretariat Services Limited em 12/07/2011

    2 páginasCH04

    Detalhes do diretor alterados para Mark Adeyemi Asagba Akinlade em 12/07/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Secretariat Services Limited em 16/05/2011

    3 páginasCH04

    Endereço do domicílio registado alterado de * Meridian House the Crescent York North Yorkshire YO24 1AW* em 27/05/2011

    2 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2010

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 12/07/2010 com lista completa de acionistas

    14 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2009

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    Contas anuais preparadas até 31/03/2008

    13 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    Contas anuais preparadas até 31/03/2007

    14 páginasAA

    Renúncia do auditor

    2 páginasAUD

    legacy

    1 páginas288b

    Quem são os diretores de JARVIS TS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    c/o Directorate Services Limited
    Monks Brook Industrial Estate
    School Close Chandlers Ford
    SO53 4RA Eastleigh
    17
    England
    Secretário
    c/o Directorate Services Limited
    Monks Brook Industrial Estate
    School Close Chandlers Ford
    SO53 4RA Eastleigh
    17
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro03623281
    70053320013
    AKINLADE, Mark Adeyemi Asagba
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    Diretor
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor116740230002
    LAIRD, Stuart Wilson
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    Diretor
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritishBusiness Advisor60742240002
    NOLAN, Richard
    17 St Davids Road
    TN4 9JQ Tunbridge Wells
    Kent
    Secretário
    17 St Davids Road
    TN4 9JQ Tunbridge Wells
    Kent
    Irish105084670001
    NYE, Ann Mary
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Bucks
    Secretário
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Bucks
    British17357120001
    MINCING LANE CORPORATE SERVICES LIMITED
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    Secretário
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    32940220004
    BURTON, Ernest Walter
    15 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    Diretor
    15 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    BritishCompany Director11389700001
    CHARRIER, Claude
    2 Bis Rue Joseph Thierry
    37230 Luynes
    France
    Diretor
    2 Bis Rue Joseph Thierry
    37230 Luynes
    France
    FrenchCompany Director42774510001
    DOYLE, Robert John
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    Diretor
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    BritishChartered Civil Engineer79420210002
    DUNN, John Nigel
    46 The Island
    Wraysbury
    Bucks
    Diretor
    46 The Island
    Wraysbury
    Bucks
    BritishComputer Engineer23865780001
    DUPONT, Denis
    16 Rue Civiale
    92380 Garches
    France
    Diretor
    16 Rue Civiale
    92380 Garches
    France
    FrenchCompany Director98982530001
    GALLAGHER, Daniel Joseph
    9 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Diretor
    9 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    British And IrishDirector49885010001
    GAY, Andrew
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Diretor
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    United KingdomBritishDirector73774260004
    GORDON, Ray
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    Diretor
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    BritishChartered Quantity Surveyor102379260001
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Diretor
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector57954340003
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant20374510001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Diretor
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishChartered Secretary37404250003
    NYE, Ann Mary
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Bucks
    Diretor
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Bucks
    BritishMarried Woman17357120001
    NYE, Richard Alfred
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Diretor
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishComputer Consultant22791180001
    PIRRET, Gordon Maxwell, Mr.
    Bradwell Hall
    CM0 7HX Bradwell On Sea
    Essex
    Diretor
    Bradwell Hall
    CM0 7HX Bradwell On Sea
    Essex
    EnglandBritishCompany Director30161610003
    PLUMLEY, Xavier Alexander
    Holly Cottage
    Hill Farm Road
    SL6 0HA Taplow
    Buckinghamshire
    Diretor
    Holly Cottage
    Hill Farm Road
    SL6 0HA Taplow
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant51554040001
    RAFIN, Francois
    L Aitre Des Gauthier
    37210 Vernou S Brenne
    France
    Diretor
    L Aitre Des Gauthier
    37210 Vernou S Brenne
    France
    FrenchCompany Director42789710001
    SIMPSON, Terence Colin Frank
    Homer Cottage
    Ipsden
    OX10 6QS Wallingford
    Oxfordshire
    Diretor
    Homer Cottage
    Ipsden
    OX10 6QS Wallingford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director34093540001
    TERRIS, Edward Ambrose
    Twychelles Brindle Lane
    Forty Green
    HP9 1XT Beaconsfield
    Bucks
    Diretor
    Twychelles Brindle Lane
    Forty Green
    HP9 1XT Beaconsfield
    Bucks
    AmericanCompany Director20867310001
    WESTBROOK, Bernard Leslie
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    Diretor
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritishGroup Human Resources51336870001
    WILLIAMSON, Clive James Murray
    19 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    Diretor
    19 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Civil Engineer36771760001
    WORTHINGTON, Geoffrey John
    Tudor House Blackwood Hill Farm
    Blackwood Hill
    ST9 9AH Endon
    Staffordshire
    Diretor
    Tudor House Blackwood Hill Farm
    Blackwood Hill
    ST9 9AH Endon
    Staffordshire
    BritishChartered Engineer85844580001

    JARVIS TS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage debenture
    Criado em 01/02/1995
    Entregue em 09/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/02/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 08/11/1994
    Entregue em 22/11/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease dated 30 june 1994 and the deed of variation
    Breve descrição
    Rental deposit of £35,000.
    Pessoas com direito
    • Anne Mary Nye
    • Richard Alfred Nye
    • And Clive Percy Brooks
    • As Trustees of the Techspan Executive Small Self Administered Pension Scheme
    Transações
    • 22/11/1994Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 25/07/1989
    Entregue em 04/08/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transações
    • 04/08/1989Registro de uma garantia
    • 30/06/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 25/07/1989
    Entregue em 04/08/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Hayder house, churchfield road, chalfornt-st-peter bucks. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transações
    • 04/08/1989Registro de uma garantia
    • 30/06/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0