SHIELDTECH PLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSHIELDTECH PLC
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa 01423125
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SHIELDTECH PLC?

    • (7415) /

    Onde fica SHIELDTECH PLC?

    Endereço do escritório registrado
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SHIELDTECH PLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BASE GROUP PLC27/06/200227/06/2002
    DIGITAL SPORT PLC29/11/200029/11/2000
    FERRUM HOLDINGS PLC24/11/198924/11/1989
    FLOYD ENERGY PLC16/05/198816/05/1988
    FLOYD OIL PARTICIPATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY25/05/197925/05/1979

    Quais são as últimas contas de SHIELDTECH PLC?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2009

    Quais são as últimas submissões para SHIELDTECH PLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Relatório de progresso do administrador até 20/04/2011

    18 páginas2.24B

    Aviso de mudança da administração para dissolução em 20/04/2011

    17 páginas2.35B

    Término da nomeação de Pommy Sarwal como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Paul Grundy como secretário

    2 páginasTM02

    Término da nomeação de Paul Grundy como diretor

    2 páginasTM01

    Declaração de negócios com formulário 2.15B/2.14B

    9 páginas2.16B

    Aviso da aprovação presumida das propostas

    2 páginasF2.18

    Declaração de proposta do administrador

    42 páginas2.17B

    Endereço do domicílio registado alterado de Unit 5 Chesford Grange Woolston Warrington WA1 4RQ United Kingdom em 04/11/2010

    2 páginasAD01

    Nomeação de um administrador

    1 páginas2.12B

    Declaração anual preparada até 28/04/2010 com lista global de acionistas

    18 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital09/08/2010

    Estado do capital em 09/08/2010

    • Capital: GBP 9,009,694
    SH01

    Término da nomeação de Robert Denton como diretor

    1 páginasTM01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Contas consolidadas preparadas até 30/06/2009

    46 páginasAA

    Término da nomeação de Robert Denton como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Paul Grundy como secretário

    1 páginasAP03

    Nomeação de Mr Paul Grundy como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Robert Denton como secretário

    1 páginasTM02

    legacy

    1 páginas288a

    Resoluções

    Resolutions
    68 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Appointing as a director/investment the circular 22/06/2009
    RES13
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    capital

    Resolução de supressão dos direitos de preferência

    RES11
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    legacy

    7 páginas395

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas395

    Quem são os diretores de SHIELDTECH PLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    O`NEILL, Anthony Arthur
    12 Aran Heights
    HP8 4DZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Diretor
    12 Aran Heights
    HP8 4DZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British58776190001
    POVEY, Keith, Sir
    Rufford House
    5 High Street
    LN5 0QX Brant Broughton
    Lincolnshire
    Diretor
    Rufford House
    5 High Street
    LN5 0QX Brant Broughton
    Lincolnshire
    British123375790001
    WIGHTMAN, Timothy Redmayne
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Diretor
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish8610650001
    DENTON, Robert William
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    Secretário
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    British250279270001
    GRUNDY, Paul
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    Secretário
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    145996590001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Secretário
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    British128648070001
    KITTOE, Stephen Maurice
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Secretário
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British692590009
    CITY GROUP PLC
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    Secretário
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    35794270001
    AITKEN, Robin Douglas
    Uphill
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    Diretor
    Uphill
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    British62740310002
    AKERS, John Michael Anthony
    White Walls Farley Lane
    Romsley
    B62 0LG Halesowen
    West Midlands
    Diretor
    White Walls Farley Lane
    Romsley
    B62 0LG Halesowen
    West Midlands
    United KingdomBritish17792380001
    ANGEL, Leon
    2 Laurimel Close
    HA7 2SU Stanmore
    Middlesex
    Diretor
    2 Laurimel Close
    HA7 2SU Stanmore
    Middlesex
    British14283520001
    BAARTMANS, Kees-Jan
    Brasschaatselei 10
    FOREIGN 2950 Kapellen
    Belgium
    Diretor
    Brasschaatselei 10
    FOREIGN 2950 Kapellen
    Belgium
    Dutch28166930001
    BARKER, Crispin Jonathan
    Socknersh Manor Fontridge Lane
    TN19 7DE Etchingham
    East Sussex
    Diretor
    Socknersh Manor Fontridge Lane
    TN19 7DE Etchingham
    East Sussex
    British23728980001
    BRADSHAW, Adrian Effland
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    Diretor
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish74991310001
    BRIDGE, Peter John
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    Diretor
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    United KingdomBritish54098960002
    CARTER, John Henry
    The Chantry 51 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Diretor
    The Chantry 51 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    British15186400001
    COOK, Peter George
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    Diretor
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    British36768870001
    DENTON, Robert William
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    Diretor
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish250279270001
    FRIER, Gavin Austin
    Ceadr Grove House
    Dirleton
    EH39 5DR North Berwick
    East Lothian
    Diretor
    Ceadr Grove House
    Dirleton
    EH39 5DR North Berwick
    East Lothian
    British692610004
    GARNER, Marshall Kenneth
    3 Woodside Drive
    Barnt Green
    B45 8XT Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    3 Woodside Drive
    Barnt Green
    B45 8XT Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish52313820002
    GOURLAY, John Malcolm
    Great Gables
    Bosbury
    HR8 1QA Ledbury
    Herefordshire
    Diretor
    Great Gables
    Bosbury
    HR8 1QA Ledbury
    Herefordshire
    British574590001
    GRUNDY, Paul
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    Diretor
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    EnglandBritish17333220001
    HATTON, John Leonard
    7 Merricks Close
    DY12 2PF Bewdley
    Worcestershire
    Diretor
    7 Merricks Close
    DY12 2PF Bewdley
    Worcestershire
    British17792410001
    HOPKINSON, Glenn
    10 Walnut Grove
    SO22 5HR Winchester
    Hampshire
    Diretor
    10 Walnut Grove
    SO22 5HR Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish76865910002
    HORNER, Rupert Howard Milton
    Home Farm House 33 High Street
    Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    Home Farm House 33 High Street
    Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish42919770001
    HUME, James Douglas Howden
    Drimard 22 East Lennox Drive
    G84 9JD Helensburgh
    Dunbartonshire
    Diretor
    Drimard 22 East Lennox Drive
    G84 9JD Helensburgh
    Dunbartonshire
    British738610001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Diretor
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    United KingdomBritish128648070001
    KENNEDY, Simon Mark
    106 Warwick Road Alkrington
    Middleton
    M24 1HL Manchester
    Diretor
    106 Warwick Road Alkrington
    Middleton
    M24 1HL Manchester
    British60141130001
    KITTOE, Stephen Maurice
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Diretor
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British692590009
    LENSEN, John
    Basaltdyk 51
    4706DR Roosendaal
    The Netherlands
    Diretor
    Basaltdyk 51
    4706DR Roosendaal
    The Netherlands
    Dutch38326960001
    MCCAUGHEY, Paul Trevor
    Flat 14 Tiffany Heights
    59 Standen Road
    SW18 5TF London
    Diretor
    Flat 14 Tiffany Heights
    59 Standen Road
    SW18 5TF London
    British76385200002
    MILLER, Simon Edward Callum
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    Diretor
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    ScotlandBritish176036600001
    ROUND, Richard Calvin
    5 Craigowmill
    Milnathort
    KY13 0RT Kinross Perth
    Diretor
    5 Craigowmill
    Milnathort
    KY13 0RT Kinross Perth
    British108158250001
    SARWAL, Pommy Prodaman Kumar
    28 Atwood Avenue
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    Diretor
    28 Atwood Avenue
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    EnglandBritish103609350001
    SMITH, Gary
    10 Farquhar Road
    Edgbaston
    B15 3RB Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    10 Farquhar Road
    Edgbaston
    B15 3RB Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish94244890001

    SHIELDTECH PLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 24/06/2009
    Entregue em 01/07/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bruce Gordan Stephen Jenkins and Derek James
    Transações
    • 01/07/2009Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 24/06/2009
    Entregue em 25/06/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 25/06/2009Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 21/12/2007
    Entregue em 08/01/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 08/01/2008Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 25/07/1997
    Entregue em 13/08/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The freehold property known as mech tool housemains works whessoe road darlington county durham title number DU14506 and DU18947. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 13/08/1997Registro de uma garantia (395)
    • 14/06/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 25/07/1997
    Entregue em 07/08/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The freehold property as fabrication shop situate at riverview industrial estate off dodsworth street darlington durham title numbers DU160790 DU160904 DU181997 and DU126993. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/08/1997Registro de uma garantia (395)
    • 14/06/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 25/07/1997
    Entregue em 06/08/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 06/08/1997Registro de uma garantia (395)
    • 21/11/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security
    Criado em 24/12/1993
    Entregue em 08/01/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/12/93 and a mortgage debenture dated 3/12/93 as amended
    Breve descrição
    The tenants interest uder a lease between london & edinburgh trust (scotland) limited and the cmpany dated 13/3/and 29/4/92. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/01/1994Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security
    Criado em 24/12/1993
    Entregue em 08/01/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/12/93 and a mortgage debenture dated 3/12/93 as may be amended
    Breve descrição
    The tenants interest in a lease between the city of aberdeen district council and offshore drilling supplies. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/01/1994Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 03/12/1993
    Entregue em 09/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a land and buildings on the east side of hoylake road bottesford humberside glanford t/no HS185215 with the assigns the goodwill of the business to the bank the full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/12/1993
    Entregue em 09/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a west side of rotherham road rotherham south yorkshire t/no syk 251481 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/12/1993
    Entregue em 09/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of park lane basford nottingham nottinghamshire t/nos NT285394 and NT211704 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank the full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 03/12/1993
    Entregue em 09/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/12/1993
    Entregue em 09/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of whessoe road darlington durham t/no DU14506 DU18947 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business the full benefitof all licences and together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/12/1993
    Entregue em 09/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a river view industrial estate dodsworth street darlington durham t/no's du 181997 DU160904 DU160790 DU126993 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank full benefit f all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security
    Criado em 30/11/1993
    Entregue em 13/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 30/11/93
    Breve descrição
    All and whole that area of ground lying to the north west of melville street edinburgh county of midlothian together with the buildings and other erections thereon k/a 57 melville street. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 13/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security
    Criado em 30/11/1993
    Entregue em 13/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under theterms of a guarantee and debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 30/11/93
    Breve descrição
    All and whole that area of ground lying to the north west of melville street edinburgh county of midlothian. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 13/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security
    Criado em 24/11/1993
    Entregue em 09/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1/7/93 as amended from time to time in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/11/93
    Breve descrição
    All and whole the area of ground lying on the south east side of greenbank crescent east tullos industrial aberdeen in the city of aberdeen extending to 3.45 acres or thereby.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 09/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 18/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 27/05/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security
    Criado em 24/11/1993
    Entregue em 09/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/11/93
    Breve descrição
    All and whole the area of ground lying on the south east side of greenbank crescnt east tullos industrial estate aberdeen in the city of aberdeen and county foresaid extending to 3.45 acres or thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 09/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 18/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 27/06/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 06/08/1993
    Entregue em 17/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property on north east side of dodsworth street darlington durham part of riverview industrial estate t/nsdu 160790,du 160904,du 181997.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 17/08/1993Registro de uma garantia (395)
    • 29/09/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 29/07/1993
    Entregue em 10/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 01/07/93
    Breve descrição
    F/H land on west of park lane new basford nottingham part t/n nt 285394.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 10/08/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 29/07/1993
    Entregue em 10/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 01/07/93
    Breve descrição
    F/H land on north east of dodsworth street darlington durham part of riverview industrial estate t/nsdu 160790,du 160904,du 181997.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 10/08/1993Registro de uma garantia (395)
    • 29/09/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 01/07/1993
    Entregue em 15/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 15/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 13/01/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 28/09/1995Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 29/09/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 01/07/1993
    Entregue em 15/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 15/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 13/01/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 28/09/1995Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 29/09/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    SHIELDTECH PLC possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/10/2010Início da administração
    20/04/2011Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Paul Ellison
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Profissional
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Gareth Wyn Roberts
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Profissional
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0