INPOST DISTRIBUTION LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | INPOST DISTRIBUTION LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01430241 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
- Comércio por grosso de outros produtos intermédios (46760) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Onde fica INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Moray House 23-35 Great Titchfield Street W1W 7PA London England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| MENZIES DISTRIBUTION LIMITED | 06/08/2001 | 06/08/2001 |
| JOHN MENZIES DISTRIBUTION LIMITED | 28/01/1998 | 28/01/1998 |
| NEWSRIDERS LIMITED | 29/07/1985 | 29/07/1985 |
| GOLDEN ACORN PUBLISHING COMPANY LIMITED(THE) | 15/06/1979 | 15/06/1979 |
Quais são as últimas contas de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2025 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 28/12/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 19/05/2026 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 02/06/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 19/05/2025 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomeação de Mr Michael Brian Rouse como diretor em 27/11/2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Neil Oliver Kuschel como diretor em 26/11/2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 28/12/2024 | 66 páginas | AA | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Moray House, 23-25 Great Titchfield Street London W1W 7PA England para Moray House 23-35 Great Titchfield Street London W1W 7PA em 25/06/2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Certificado de mudança de nome Company name changed menzies distribution LIMITED\certificate issued on 25/06/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Unit E, Twelvetrees Business Park Twelvetrees Crescent London E3 3JG England para Moray House, 23-25 Great Titchfield Street London W1W 7PA em 25/06/2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/05/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Neil Kuschel como diretor em 15/10/2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Gregory John Michael como diretor em 15/10/2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/12/2023 | 48 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/05/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Satisfação total da garantia 014302410013 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2022 | 62 páginas | AA | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Gregory John Michael em 07/09/2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/05/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Registo da garantia 014302410013, criada em 01/08/2022 | 26 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorando e estatutos | 18 páginas | MA | ||||||||||||||
Registo da garantia 014302410012, criada em 22/07/2022 | 72 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 01/01/2022 | 60 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/05/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 014302410011 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 014302410008 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 014302410008 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Satisfação total da garantia 014302410004 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Quem são os diretores de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCOURT, Paul Raymond Patrick | Diretor | Great Titchfield Street W1W 7PA London Moray House 23-35 England | Scotland | British | 183278190001 | |||||
| ROUSE, Michael Brian | Diretor | Great Titchfield Street W1W 7PA London Moray House 23-35 England | England | British | 343342430001 | |||||
| ANDERSON, Charles Adair | Secretário | Ravensheugh TD7 5LS Selkirk | British | 44142970001 | ||||||
| GEDDES, John Francis Alexander | Secretário | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | British | 103057020004 | ||||||
| KIRKWOOD, George | Secretário | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | British | 107652330001 | ||||||
| MULHOLLAND, Eric | Secretário | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | 152434850001 | |||||||
| MULHOLLAND, Eric | Secretário | 81 Auchingane EH10 7HU Edinburgh | British | 984680001 | ||||||
| TURNBULL, David Alistair | Secretário | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | 166629600001 | |||||||
| ANDERSON, Charles Adair | Diretor | Ravensheugh TD7 5LS Selkirk | United Kingdom | British | 44142970001 | |||||
| BELL, Paula | Diretor | Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh 2 Scotland | Scotland | British | 116712890002 | |||||
| BENNETT, James Douglas Scott | Diretor | The Well House 3 Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh | British | 365550003 | ||||||
| BLACK, Forsyth Rutherford | Diretor | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 188546240002 | |||||
| BLAND, Catherine Mary | Diretor | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 153744340002 | |||||
| BOYLE, Thomas | Diretor | 26 Dreghorn Loan EH13 0DE Edinburgh | Irish | 107652260002 | ||||||
| CALLAGHAN, Iain Mills | Diretor | 10 Kings Cramond Gamekeepers Road EH4 6RL Edinburgh Midlothian | British | 145895140001 | ||||||
| CASSIE, Mark Stephen | Diretor | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | Scotland | British | 161586010001 | |||||
| COOKE, David Michael | Diretor | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | England | British | 146398580001 | |||||
| COYLE, Francis John | Diretor | 1 Struan Place KY11 1NF Inverkeithing Fife | Scotland | British | 54147130001 | |||||
| DOLLMAN, Paul Bernard | Diretor | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 1230000002 | |||||
| DOLLMAN, Paul Bernard | Diretor | 36 Garscube Terrace EH12 6BN Edinburgh | Scotland | British | 1230000002 | |||||
| DYSON, Jane Allison | Diretor | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | United Kingdom | British | 103858670002 | |||||
| JENKINSON, Dermot Julian | Diretor | Mersington House Greenlaw TD10 6UL Duns Berwickshire | Scotland | British | 681840002 | |||||
| KIRKWOOD, George | Diretor | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | British | 107652330001 | ||||||
| KUSCHEL, Neil Oliver | Diretor | Great Titchfield Street W1W 7PA London Moray House 23-35 England | England | British | 328820160001 | |||||
| MACDONALD, Patrick James | Diretor | 30 Royal Terrace EH7 5AH Edinburgh | Scotland | British | 90055380002 | |||||
| MACKAY, David James | Diretor | 4 East Harbour Road KY11 3EA Charlestown Fife | Scotland | British | 681850002 | |||||
| MCINTOSH, David Dennis | Diretor | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 85826730002 | |||||
| MELLON, Christina | Diretor | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | Scotland | British | 139986280001 | |||||
| MICHAEL, Gregory John | Diretor | 2 Redheughs Rigg South Gyle EH12 9DQ Edinburgh Verdant Scotland | England | British | 221854770002 | |||||
| MITCHELL, Alexander | Diretor | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | United Kingdom | British | 139998290001 | |||||
| MORTON, David Emerson | Diretor | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 13180890002 | |||||
| NOEL-PATON, Frederick Ranald, The Hon | Diretor | Easter Dunbarnie Bridge Of Earn PH2 9ED Perth Perthshire | British | 21482560001 | ||||||
| SMITH, Martyn Robert | Diretor | 12/2 Mcdonald Road EH7 4LZ Edinburgh | British | 65137160006 | ||||||
| SPEIRS, David William Ogden | Diretor | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | Scottish | 129856460001 | |||||
| WARD, John | Diretor | 9a Mossgreen KY4 8BU Crossgates Fife | British | 84407440002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menzies Distribution Holdings Limited | 04/09/2018 | Whitehall Quay LS1 4BF Leeds 3 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| John Menzies Plc | 06/04/2016 | Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh 2 Scotland Scotland | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Menzies Group Holdings Limited | 06/04/2016 | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0