OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED

OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaOXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01431111
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o CK CHARTERED ACCOUNTANTS
    Castle Court 2
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    West Midlands
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CABLE AND WIRELESS (COMPUTER SYSTEMS) LIMITED08/08/199408/08/1994
    CABLE AND WIRELESS (PENSION SERVICES) LIMITED19/04/199419/04/1994
    SPACE-TIME SYSTEMS (HOLDINGS) LIMITED01/10/198501/10/1985

    Quais são as últimas contas de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2012

    Qual é o status da última declaração anual para OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 20/03/2014 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital27/03/2014

    Estado do capital em 27/03/2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Contas preparadas até 31/12/2012

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 20/03/2013 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Declaração anual preparada até 20/03/2012 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2011

    4 páginasAA

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2010

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 20/03/2011 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Susan Lesley Harris em 23/02/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Matthew Harris em 23/02/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Michael John Harris em 23/02/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Dr Claire Louise Brown em 23/02/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Susan Lesley Harris em 23/02/2011

    1 páginasCH03

    Endereço do domicílio registado alterado de Appleford Meadows School Lane Appleford Abingdon Oxfordshire OX14 4NY em 21/02/2011

    1 páginasAD01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2009

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 20/03/2010 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Susan Lesley Harris em 01/03/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Michael John Harris em 01/03/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Matthew Harris em 01/03/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Susan Lesley Harris em 01/03/2010

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Dr Claire Louise Brown em 01/03/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Susan Lesley Harris em 01/10/2009

    3 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Michael John Harris em 01/10/2009

    3 páginasCH01

    Quem são os diretores de OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HARRIS, Susan Lesley
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Secretário
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    British77295200001
    BROWN, Claire Louise, Dr
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish114831110001
    HARRIS, Matthew David
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish114732130001
    HARRIS, Michael John
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish174529110001
    HARRIS, Susan Lesley
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Ck Chartered Accountants
    Castlegate Way
    DY1 4RH Dudley
    Castle Court 2
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish77295200001
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Secretário
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    LOWE, Hilary Anne
    40 Mill Lane
    Cheshunt
    EN8 0JH Hertfordshire
    Secretário
    40 Mill Lane
    Cheshunt
    EN8 0JH Hertfordshire
    British95034760001
    RADCLIFFE, Peter Howard
    Carlton House
    Gildingwells
    S81 8AU Worksop
    Notts
    Secretário
    Carlton House
    Gildingwells
    S81 8AU Worksop
    Notts
    British4790650001
    WELLARD, Tracey Lee
    21 Davenport Road
    Albany Park
    DA14 4PN Sidcup
    Kent
    Secretário
    21 Davenport Road
    Albany Park
    DA14 4PN Sidcup
    Kent
    British11445390001
    WINDRIDGE, Susan Doreen
    The Ferns
    157 Southwood Lane
    N6 5TA London
    Secretário
    The Ferns
    157 Southwood Lane
    N6 5TA London
    British6617760002
    CARTWRIGHT, Stacey Lee
    34 Roedean Crescent
    SW15 5JU London
    Diretor
    34 Roedean Crescent
    SW15 5JU London
    United KingdomBritish150700660001
    CASSONI, Maria Luisa
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    Diretor
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    EnglandBritish74583340001
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Diretor
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    COLEMAN, Kieran Mark
    13 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RN London
    Diretor
    13 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RN London
    Irish111282900001
    COPPOCK, Kenneth Francis
    Oving House Loudhams Wood Lane
    HP8 4AP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Diretor
    Oving House Loudhams Wood Lane
    HP8 4AP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British78528960001
    COUNCELL, Derek John
    11 Gainsborough Gardens
    NW3 1BJ London
    Diretor
    11 Gainsborough Gardens
    NW3 1BJ London
    United KingdomBritish34891830003
    DOYLE, David Colin
    19 Belsize Park Gardens
    NW3 4JG London
    Diretor
    19 Belsize Park Gardens
    NW3 4JG London
    Australian70583800002
    GILLESPIE, Joseph Norman, Dr
    11 Claremont Road
    TN1 1SY Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    11 Claremont Road
    TN1 1SY Tunbridge Wells
    Kent
    British29694610001
    GRATTON, Paul Robert
    The Hall
    Somersal Herbert
    DE6 5PD Ashbourne
    Derbyshire
    Diretor
    The Hall
    Somersal Herbert
    DE6 5PD Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritish47117090003
    JACK, James White
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Diretor
    Azalea Cottage
    Alderton Drive
    HP4 1NA Little Gaddesden
    Hertfordshire
    EnglandBritish191658610001
    KIBBEY, Jane Celia
    54 Beltran Road
    SW6 3AJ London
    Diretor
    54 Beltran Road
    SW6 3AJ London
    British10924800001
    MAYNARD, Peter Martin
    The Old Rectory, Rectory Road
    Woodham Walter
    CM9 6RD Maldon
    Essex
    Diretor
    The Old Rectory, Rectory Road
    Woodham Walter
    CM9 6RD Maldon
    Essex
    United KingdomBritish153259670001
    MYERS, Andrew Colin
    70 Reddown Road
    CR5 1AL Coulsdon
    Surrey
    Diretor
    70 Reddown Road
    CR5 1AL Coulsdon
    Surrey
    British11837680001
    NANCARROW, Mark James St John
    Tetley House
    Marchington
    ST14 8LG Uttoxeter
    Staffordshire
    Diretor
    Tetley House
    Marchington
    ST14 8LG Uttoxeter
    Staffordshire
    British105319950001
    O BRIEN, Conor John Anthony
    Midgham Park Farm
    Midgham
    RG7 5UG Reading
    Berkshire
    Diretor
    Midgham Park Farm
    Midgham
    RG7 5UG Reading
    Berkshire
    British72690550001
    OLSEN, Rodney James
    Hawthorne House
    1 Upper Terrace Hampstead
    NW3 6RH London
    Diretor
    Hawthorne House
    1 Upper Terrace Hampstead
    NW3 6RH London
    New Zealander13009620005
    PAKENHAM-WALSH, Patrick Douglas
    Orchard Cottage Lythe Hill Park
    GU27 3BD Haslemere
    Surrey
    Diretor
    Orchard Cottage Lythe Hill Park
    GU27 3BD Haslemere
    Surrey
    British1703230001
    PATE, Thomas
    19 Canford Road
    SW11 6PA London
    Diretor
    19 Canford Road
    SW11 6PA London
    British21537620001
    SUTCLIFFE, James Harry
    Sans Souci South View Road
    HA5 3YD Pinner
    Middlesex
    Diretor
    Sans Souci South View Road
    HA5 3YD Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish57721650001
    SYDOW, Karl Gordon
    17 Lonsdale Place
    N1 1EL London
    Diretor
    17 Lonsdale Place
    N1 1EL London
    Usa8553020001

    OXFORD EXECUTIVE CONSULTING LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee and debenture
    Criado em 05/12/1991
    Entregue em 18/12/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    See form 395 ref M621C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 18/12/1991Registro de uma garantia (395)
    • 18/03/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 29/04/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 14/10/1991
    Entregue em 01/11/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 11/10/91
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Rober Fleming & Co. Limited
    Transações
    • 01/11/1991Registro de uma garantia (395)
    • 29/04/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 01/05/1991
    Entregue em 17/05/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Robert Fleming & Co Limited
    Transações
    • 17/05/1991Registro de uma garantia (395)
    • 29/04/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Series of debentures
    Criado em 02/07/1987
    Entregue em 06/07/1987
    Totalmente satisfeita
    Transações
    • 06/07/1987Registro de uma garantia
    Series of debentures
    Criado em 02/07/1986
    Entregue em 02/07/1986
    Totalmente satisfeita
    Transações
    • 02/07/1986Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 01/04/1982
    Entregue em 08/04/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital with all fixtures (incl trade fixtures) & fittings, plant machinery.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transações
    • 08/04/1982Registro de uma garantia
    • 29/04/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 22/10/1981
    Entregue em 23/10/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums that the chargees may be called upon to pay in connection with a lease dated 25TH february, 1981, or pursuant to an undertaking in a letter dated 22ND october 1981
    Breve descrição
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • (3) the Cardinal Investment Trust Limited
    • (4) Alliance Investment Company Limited
    • (1) the Foreign & Colonial Investment Trust Company Limited
    • (2) General Investors and Trustees Limited
    Transações
    • 23/10/1981Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0