BEPCO AGRI LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaBEPCO AGRI LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01440643
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de BEPCO AGRI LIMITED?

    • Comércio grossista de máquinas, equipamentos e materiais agrícolas (46610) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

    Onde fica BEPCO AGRI LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de BEPCO AGRI LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BEPCO (UK) LIMITED05/04/199105/04/1991
    MIFFLIN TRADING LIMITED30/07/197930/07/1979

    Quais são as últimas contas de BEPCO AGRI LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2013

    Qual é o status da última declaração anual para BEPCO AGRI LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para BEPCO AGRI LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 17/12/2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração anual preparada até 20/06/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/07/2014

    Estado do capital em 16/07/2014

    • Capital: GBP 301,000
    SH01

    Contas preparadas até 30/09/2013

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 20/06/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital27/06/2013

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 27/06/2013

    SH01

    Contas preparadas até 30/09/2012

    17 páginasAA

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed bepco (uk) LIMITED\certificate issued on 01/02/13
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name01/02/2013

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Término da nomeação de Keith Palmer como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Amanda Wood como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de Keith Palmer como secretário

    1 páginasTM02

    legacy

    3 páginasMG02

    Exercício contabilístico atual encurtado de 31/12/2012 para 30/09/2012

    1 páginasAA01

    Término da nomeação de Edward Salter como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 20/06/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Término da nomeação de Salvo Mazzotta como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Giorgio Fioranelli como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Pascal Vanhalst como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Bernard De Meester como diretor

    2 páginasAP01

    Contas preparadas até 31/12/2011

    16 páginasAA

    Quem são os diretores de BEPCO AGRI LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WOOD, Amanda
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Secretário
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    174129600001
    DE MEESTER, Bernard Stephan
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Diretor
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    BelgiumBelgian168959600001
    VANHALST, Pascal
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Diretor
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    BelgiumBelgian168959780001
    BAINTON, Adrian Richard
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    Secretário
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    British14830800001
    FRY, Wendy Kristina
    14 Comfrey Close
    RG40 5YN Wokingham
    Berkshire
    Secretário
    14 Comfrey Close
    RG40 5YN Wokingham
    Berkshire
    British51725180001
    HOW, David Alfred George
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    Secretário
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    British36176510001
    MIFFLIN, Marion Geraldine
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    Secretário
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    British14318020001
    PALMER, Keith
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    Secretário
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    British79386550001
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Secretário
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    British49339260001
    ANGEL, Jeremy
    50 Meole Rise
    SY3 9JF Shrewsbury
    Salop
    Diretor
    50 Meole Rise
    SY3 9JF Shrewsbury
    Salop
    British71195330001
    ASKHAM, Francis Guy Lewis
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    Diretor
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritish15237500001
    BAINTON, Adrian Richard
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    Diretor
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    EnglandBritish14830800001
    BENCE, John Albert
    25 Oakdene
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Diretor
    25 Oakdene
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish69524150001
    BLACK, Stephen
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    Diretor
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    British73554610001
    BRENTNALL, Trevor Alan
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    Diretor
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    British39686000001
    BRETT, Jamie
    Cwmma Green Cottage
    Brilley
    HR3 6JP Whitney On Wye
    Herefordshire
    Diretor
    Cwmma Green Cottage
    Brilley
    HR3 6JP Whitney On Wye
    Herefordshire
    British77234080001
    BREWIN, Peter Ronald
    Nutwood House
    The Street
    TN15 0QE Plaxtol
    Sevenoaks Kent
    Diretor
    Nutwood House
    The Street
    TN15 0QE Plaxtol
    Sevenoaks Kent
    British45850380001
    BROWN, Robert Martin
    81 Browning Road
    Grantley Park Church Crookham
    GU52 0YY Fleet
    Hampshire
    Diretor
    81 Browning Road
    Grantley Park Church Crookham
    GU52 0YY Fleet
    Hampshire
    British75375360001
    FIORANELLI, Giorgio
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Diretor
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    ItalyItalian163032950001
    GIORDANO, Amanda Jayne
    Maesmellan
    New Radnor
    LD8 2TN Presteigne
    Powys
    Diretor
    Maesmellan
    New Radnor
    LD8 2TN Presteigne
    Powys
    British14318030001
    HEYNEKER, Gerardus James
    24 Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    24 Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish16423710001
    HOW, David Alfred George, Mr.
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    Diretor
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish21860001
    HOWAT, James Anthony
    Lea Farmhouse
    Bishops Offley
    ST21 6EU Stafford
    Diretor
    Lea Farmhouse
    Bishops Offley
    ST21 6EU Stafford
    UkBritish41852290001
    LITWINOWICZ, Leszek Richard
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish70815770002
    MAZZOTTA, Salvo
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Diretor
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    UsaItalian163043060001
    MIDDLETON, Trevor
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    Diretor
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    EnglandBritish221486370001
    MIFFLIN, Marion Geraldine
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    Diretor
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    British14318020001
    MIFFLIN, Philip George Thomas
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    Diretor
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    British14318070001
    PALMER, Keith
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    Diretor
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    EnglandBritish79386550001
    SALTER, Edward John
    Devon Road
    WV1 4BE Wolverhampton
    14
    West Midlands
    United Kingdom
    Diretor
    Devon Road
    WV1 4BE Wolverhampton
    14
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish87426020002
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Diretor
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    British49339260001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Diretor
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001

    BEPCO AGRI LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 19/02/2007
    Entregue em 22/02/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Kbc Bank Nv
    Transações
    • 22/02/2007Registro de uma garantia (395)
    • 19/09/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 17/10/2002
    Entregue em 29/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The f/h property k/a or being unit 2 hatton gardens industrial estate kington herefordshire HR5 3RB. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 29/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 22/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 17/10/2002
    Entregue em 29/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 29/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 22/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trust debenture
    Criado em 17/10/2002
    Entregue em 23/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company as an obligor to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Close Investment Partners Limited
    Transações
    • 23/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 22/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 12/01/1998
    Entregue em 27/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to midland bank PLC including all monies, obligations and liabilities, due owing or incurred under or pursuant to the secured documents (as defined) and irrevocably and unconditionally guarantees the due performance by each other company of all it's obligations under or pursuant to the secured documents to which it is a party
    Breve descrição
    For full details of all charged assets please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 27/01/1998Registro de uma garantia (395)
    • 29/10/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 05/04/1991
    Entregue em 09/04/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding uncalled capital. Those mentioned above).
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 09/04/1991Registro de uma garantia
    • 02/02/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 26/01/1989
    Entregue em 03/02/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 03/02/1989Registro de uma garantia
    • 21/08/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge on book debts
    Criado em 21/08/1986
    Entregue em 28/08/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 28/08/1986Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 27/09/1984
    Entregue em 05/10/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a facility letter dated 9/7/84 and the guarantee dated 17/8/84
    Breve descrição
    F/H land comprising of 0.59 an acre (0.238 hectares) or thereabouts together with the premises erected thereon unit 2,hatton garden industrial estate, kington in the county of hereford & worcester.
    Pessoas com direito
    • English Industrial Estates Corporation.
    Transações
    • 05/10/1984Registro de uma garantia
    • 21/12/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0