DBS MANAGEMENT LIMITED

DBS MANAGEMENT LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaDBS MANAGEMENT LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01451043
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de DBS MANAGEMENT LIMITED?

    • Atividades de sociedades holding de serviços financeiros (64205) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DBS MANAGEMENT PLC02/08/199502/08/1995
    DBS MANAGEMENT PUBLIC LIMITED COMPANY27/09/197927/09/1979

    Quais são as últimas contas de DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2017

    Quais são as últimas submissões para DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA para 30 Finsbury Square London EC2P 2YU em 05/10/2018

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 18/09/2018

    LRESSP

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    19 páginasAA

    Término da nomeação de John Cowan como diretor em 12/09/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Rowley Rose como diretor em 12/09/2018

    2 páginasAP01

    Notificação de London and Manchester Group Limited como pessoa com controlo significativo em 10/04/2018

    2 páginasPSC02

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2018 com atualizações

    5 páginasCS01

    Cessação de Sesame Bankhall Group Limited como pessoa com controlo significativo em 10/04/2018

    1 páginasPSC07

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    20 páginasAA

    Término da nomeação de David John Burlison como diretor em 27/07/2017

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2017 com atualizações

    6 páginasCS01

    Nomeação de Aviva Company Secretarial Services Limited como secretário em 17/03/2017

    2 páginasAP04

    Término da nomeação de Friends Life Secretarial Services Limited como secretário em 17/03/2017

    1 páginasTM02

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 15/02/2017

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    24 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/05/2016 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/05/2016

    Estado do capital em 12/05/2016

    • Capital: GBP 495,416.45
    SH01

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Quem são os diretores de DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Secretário
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2084205
    1278390004
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Diretor
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector89567200001
    CARTWRIGHT, Ceilo Bicol
    3 Becketts Park Road
    Headingley
    LS6 3PG Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    3 Becketts Park Road
    Headingley
    LS6 3PG Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant74876530001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Secretário
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    BritishDirector86129050001
    ELLIS, Robert Gordon
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    Secretário
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    BritishSolicitor33165610001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretário
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    GREENWOOD, Martin James
    Stonecroft
    Daisy Lea Lane
    HD3 3LL Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretário
    Stonecroft
    Daisy Lea Lane
    HD3 3LL Huddersfield
    West Yorkshire
    British66171900001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretário
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    MONGER, Diana
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Secretário
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    148089070001
    STEWART, David
    Beverley House
    23 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretário
    Beverley House
    23 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant38667100004
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretário
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    FRIENDS LIFE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro7350629
    169080040001
    ANDREW, Kenneth, Doctor
    16 Portsea Place
    W2 2BL London
    Diretor
    16 Portsea Place
    W2 2BL London
    BritishCompany Director78357920003
    BATTERHAM, Christopher Michael
    Vale Farm House
    Hawridge Vale
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    Diretor
    Vale Farm House
    Hawridge Vale
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director48567920002
    BUDGE, Kevin John
    The Old Nursery The Dash
    Kings Lane Longcot
    SN7 7SS Faringdon
    Oxfordshire
    Diretor
    The Old Nursery The Dash
    Kings Lane Longcot
    SN7 7SS Faringdon
    Oxfordshire
    BritishChartered Accountant97406200001
    BURLISON, David John
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Diretor
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    United KingdomBritishCompany Director202289710001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Diretor
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritishFinance Director86129050001
    CORDLE, Paul Howard
    2 Quemerford Farm Cottages
    SN11 8UA Calne
    Wiltshire
    Diretor
    2 Quemerford Farm Cottages
    SN11 8UA Calne
    Wiltshire
    BritishDirector19082070002
    COUZENS, Michael Alastair
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    Diretor
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    United KingdomBritishCompany Director75553130006
    COWAN, John
    Montagu Square
    Westminster
    W1H 2LW London
    47
    United Kingdom
    Diretor
    Montagu Square
    Westminster
    W1H 2LW London
    47
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director109138540001
    DAVY, Kenneth Ernest
    Holly Mount 3 Paget Crescent
    Birkby
    HD2 2BZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    Holly Mount 3 Paget Crescent
    Birkby
    HD2 2BZ Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishInvestment Consultant6078230001
    DRURY, Peter Stanley
    30 Timbercliffe
    Summit
    OL15 9QL Littleborough
    Lancs
    Diretor
    30 Timbercliffe
    Summit
    OL15 9QL Littleborough
    Lancs
    BritishInvestment Consultant33205780001
    GALE, Patrick Nigel Christopher
    Mallams
    62 High Street
    OX14 4EJ Milton
    Oxfordshire
    Diretor
    Mallams
    62 High Street
    OX14 4EJ Milton
    Oxfordshire
    EnglandBritishChief Executive Officer149359970001
    GREENWOOD, Martin James
    Stonecroft
    Daisy Lea Lane
    HD3 3LL Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    Stonecroft
    Daisy Lea Lane
    HD3 3LL Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant66171900001
    HIDDLESTON, David James
    4 Grovewood Close
    WD3 5PU Chorleywood
    Hertfordshire
    Diretor
    4 Grovewood Close
    WD3 5PU Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGeneral Manager Financial Services74642230001
    HIGGINSON, George
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Diretor
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Northern IrelandBritishChief Operating Officer74690950003
    HOOPER, Paul
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    Diretor
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director152500600001
    JILLINGS, Godfrey Frank
    47 Hurlingham Square
    Peterborough Road
    SW6 3DZ London
    Diretor
    47 Hurlingham Square
    Peterborough Road
    SW6 3DZ London
    United KingdomBritishConsultant54331060001
    KEMPSTER, William Anthony
    Tulligee Ranelagh Drive
    RG12 9DA Bracknell
    Berkshire
    Diretor
    Tulligee Ranelagh Drive
    RG12 9DA Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director50190310001
    MANSELL, Edgar John
    1 Levens Close
    Killinghall
    HG3 2BN Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    1 Levens Close
    Killinghall
    HG3 2BN Harrogate
    North Yorkshire
    BritishInvestment Consultant63598410001
    MARTIN, Ivan
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    Diretor
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    EnglandBritishExecutive Chairman123233030001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Diretor
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritishDirector123233030001
    NEWMAN, James Allen
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Diretor
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    United KingdomBritishCompany Director184671850003
    STEWART, David
    Beverley House
    23 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    Beverley House
    23 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant38667100004
    TAYLOR, Christopher
    Yorton House
    Yorton
    SY4 3EU Shrewsbury
    Shropshire
    Diretor
    Yorton House
    Yorton
    SY4 3EU Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director94869820001

    Quem são as pessoas com controle significativo de DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    10/04/2018
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro1594941
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    06/04/2016
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    Sim
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro3573352
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    DBS MANAGEMENT LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Criado em 19/12/2006
    Entregue em 29/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 29/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Criado em 17/09/2003
    Entregue em 01/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling 95.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Share charge
    Criado em 21/06/2001
    Entregue em 04/07/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    As a continuing security for the payment to the bank of the indebtedness the company hereby charges with full title guarantee in favour of the bank by way of first fixed charge all the securities (as defined) belonging to the company or in which the company has as interest together with distribution rights (as defined).
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/07/2001Registro de uma garantia (395)
    • 10/05/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 21/06/2001
    Entregue em 04/07/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/07/2001Registro de uma garantia (395)
    • 17/12/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 16/04/1996
    Entregue em 17/04/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land situate at and k/a independence house holly bank road huddersfied west yorkshire WYK477019 and the proceeds of sale thereof goodwill of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 17/04/1996Registro de uma garantia (395)
    • 13/04/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 18/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 16/04/1996
    Entregue em 17/04/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land adjacent to independence house holly bank road huddersfiel west yorkshire WYK506481 and the proceeds of sale thereon all goodwill of the company at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 17/04/1996Registro de uma garantia (395)
    • 04/04/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 13/04/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 18/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 14/09/1992
    Entregue em 25/09/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    First by way of legal mortgage all the property described in the schedule hereto including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the same the schedule above reffered to land adjacent to independence house,holly bank road,lindley,huddersfield,west yorkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 25/09/1992Registro de uma garantia (395)
    • 10/03/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 14/09/1992
    Entregue em 25/09/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of legal mortgage all the property described in the schedule hereto including all fixtures and fittings(other than trade fixtures and fittings) plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the same the schedule above referred to acre house,64 acxre street,lindley,huddersfield west yorkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 25/09/1992Registro de uma garantia (395)
    • 27/04/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 07/08/1990
    Entregue em 24/08/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on the south side of hollybank road lindley huddersfield west yorkshire (see 395 ref M65 and contd sheets for full details).
    Pessoas com direito
    • Skandia Financial Services Limited.
    Transações
    • 24/08/1990Registro de uma garantia
    • 09/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Floating charge.
    Criado em 07/08/1990
    Entregue em 24/08/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of floating charge all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Skandia Financial Services Limited
    Transações
    • 24/08/1990Registro de uma garantia
    • 09/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    DBS MANAGEMENT LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    18/09/2018Início da liquidação
    23/04/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profissional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0