CHIEFTAIN GROUP LIMITED

CHIEFTAIN GROUP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCHIEFTAIN GROUP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01455149
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    • fabricação de outros produtos fabricados em metal n.e.c. (25990) / Indústrias transformadoras
    • Outras instalações de construção (43290) / Construção
    • Outras atividades de construção especializadas n.e. (43999) / Construção

    Onde fica CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o C/O REDHALL GROUP PLC
    Unit 3 Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    West Yorkshire
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CHIEFTAIN GROUP P.L.C.11/08/198711/08/1987
    CHIEFTAIN INSULATION LIMITED18/10/197918/10/1979

    Quais são as últimas contas de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2017

    Quais são as últimas submissões para CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 30/09/2018 para 31/03/2019

    1 páginasAA01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/04/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Registo da garantia 014551490013, criada em 24/01/2019

    46 páginasMR01

    Registo da garantia 014551490012, criada em 24/01/2019

    45 páginasMR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Russell David Haworth em 10/01/2019

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Wayne Pearson como diretor em 03/11/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Russell David Haworth como diretor em 03/11/2018

    2 páginasAP01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Philip Comer em 09/08/2018

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Christopher John Kelly como secretário em 01/07/2018

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Simon Philip Comer como secretário em 02/07/2018

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Christopher John Kelly como diretor em 29/06/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Simon Philip Comer como diretor em 02/07/2018

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/04/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Philip Brierley como diretor em 31/03/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Wayne Pearson como diretor em 19/03/2018

    2 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2017

    8 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2016

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 25/04/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN para C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA em 05/08/2016

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2015

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 25/04/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital29/04/2016

    Estado do capital em 29/04/2016

    • Capital: GBP 450,925
    SH01

    Quem são os diretores de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Secretário
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    248241940001
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish206088760003
    HAWORTH, Russell David
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish201533400002
    ELLIOTT, Stanley, Fcma
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretário
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British7203790001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Secretário
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    187596050001
    LEWIS-JONES, Christopher
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    Secretário
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    British134974090001
    ADAMS, Laurence George
    15 Rolley Way
    Castlefields
    NE42 5FH Prudhoe
    Northumberland
    Diretor
    15 Rolley Way
    Castlefields
    NE42 5FH Prudhoe
    Northumberland
    EnglandBritish87979230002
    BRIERLEY, Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish54808010002
    CORBISHLEY, Michael
    Overidge Farm Beckside
    Cartmel
    LA11 7SP Grange-Over-Sands
    Cumbria
    Diretor
    Overidge Farm Beckside
    Cartmel
    LA11 7SP Grange-Over-Sands
    Cumbria
    EnglandBritish101553180002
    COULSON, William Andrew
    40 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Diretor
    40 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish36723860001
    CUTCHIE, Anthony William
    68 Davison Avenue
    NE26 3SU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Diretor
    68 Davison Avenue
    NE26 3SU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish45955990001
    DAWSON, John Frederic
    Park Dale
    LS29 6LW Menston
    1
    West Yorkshire
    Diretor
    Park Dale
    LS29 6LW Menston
    1
    West Yorkshire
    British8366360002
    ELLIOTT, Stanley, Fcma
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Diretor
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British7203790001
    FLEETWOOD, Christopher John
    4 The Meadows
    DL10 7DU Richmond
    North Yorkshire
    Diretor
    4 The Meadows
    DL10 7DU Richmond
    North Yorkshire
    United KingdomBritish1718030001
    FOSTER, Robert Simon
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford
    Devon
    Diretor
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford
    Devon
    EnglandBritish134973970001
    GOODENOUGH, Anthony
    Bakery Drive
    Grange Park
    TS19 0SN Stockton-On-Tees
    1
    Cleveland
    Diretor
    Bakery Drive
    Grange Park
    TS19 0SN Stockton-On-Tees
    1
    Cleveland
    EnglandBritish139196050001
    IREDALE, George Henry Cecil
    Redmays
    14 North Lodge Lambton Park
    DH3 4AZ Chester Le Street
    County Durham
    Diretor
    Redmays
    14 North Lodge Lambton Park
    DH3 4AZ Chester Le Street
    County Durham
    British141871680001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish62867720010
    JESTER, Tony
    6 Cranbourne Drive
    TS10 2SP Redcar
    Cleveland
    Diretor
    6 Cranbourne Drive
    TS10 2SP Redcar
    Cleveland
    EnglandBritish107694130001
    JOHNSON, Raymond
    1 Colville Court
    DH9 6UW East Stanley
    County Durham
    Diretor
    1 Colville Court
    DH9 6UW East Stanley
    County Durham
    EnglandBritish266049760001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish188444350001
    LEWIS-JONES, Christopher
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    Diretor
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    EnglandBritish134974090001
    MARTINDALE, Stephen Richard
    Am Waldeck 14
    FOREIGN 34537 Bad Wildungen
    Germany
    Diretor
    Am Waldeck 14
    FOREIGN 34537 Bad Wildungen
    Germany
    GermanyBritish77194110002
    O'KANE, John Peter
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    Diretor
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    United KingdomIrish106172200001
    OLIVER, Malcolm William
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    Diretor
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    EnglandBritish143300760001
    PEARSON, Wayne
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish212154420001
    PENDLETON, Alan George
    12 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    12 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    British30248370001
    PRICE, Anthony Hall
    Irton
    CA19 1UZ Holmrook
    Mecklin
    Cumbria
    Diretor
    Irton
    CA19 1UZ Holmrook
    Mecklin
    Cumbria
    EnglandBritish134973860001
    SHIPPEN, Kenneth
    14 Rectory Park
    NE61 2SZ Morpeth
    Northumberland
    Diretor
    14 Rectory Park
    NE61 2SZ Morpeth
    Northumberland
    British67917400001
    SHUTTLEWORTH, Richard Peter
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish58727820002
    TAYLOR, William Platt
    Ryton House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    Diretor
    Ryton House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    British7203810001
    WARDLE, Peter
    14 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4RR Newcastle Upon Tyne
    Diretor
    14 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4RR Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish73518260002

    Quem são as pessoas com controle significativo de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Redhall Group Plc
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    06/04/2016
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    Não
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroEngland And Wales
    Número de registro263995
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    CHIEFTAIN GROUP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 24/01/2019
    Entregue em 29/01/2019
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Downing LLP (As Security Trustee)
    Transações
    • 29/01/2019Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 24/01/2019
    Entregue em 29/01/2019
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • (1) 1798 Volantis Fund Limited and (2) 1798 Volantis Catalyst Fund Limited
    Transações
    • 29/01/2019Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 24/12/2015
    Entregue em 02/01/2016
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Alphagen Volantis Catalyst Fund Limited
    • Alphagen Volantis Fund Limited
    Transações
    • 02/01/2016Registro de uma garantia (MR01)
    Debenture
    Criado em 21/01/2011
    Entregue em 28/01/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 28/01/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Debenture
    Criado em 30/04/2009
    Entregue em 09/05/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 09/05/2009Registro de uma garantia (395)
    • 11/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Criado em 28/05/2004
    Entregue em 17/06/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 17/06/2004Registro de uma garantia (395)
    • 20/08/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattel mortgage
    Criado em 09/09/1996
    Entregue em 12/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Dean smith & grace model 20SB surfacing and boring lathe 29IN swing serial no 28803 richards model PR2N horizontal facing and boring machine serial no 28803 atlas copco model GA708 packaged rotary screw air compressor serial no 753329 and 753330 for further details please see form 395.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 12/09/1996Registro de uma garantia (395)
    • 11/07/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 01/08/1996
    Entregue em 13/08/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Premises at bath street walker newcastle upon tyne tyne and wear t/no:- ty 7137. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/08/1996Registro de uma garantia (395)
    • 20/08/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 02/11/1994
    Entregue em 11/11/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 11/11/1994Registro de uma garantia (395)
    • 20/08/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 26/08/1992
    Entregue em 09/09/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    See doc ref M593C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 09/09/1992Registro de uma garantia (395)
    • 20/08/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 20/01/1988
    Entregue em 05/02/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 05/02/1988Registro de uma garantia
    • 20/08/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 03/06/1985
    Entregue em 11/06/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that land at arrow close, killingwood north tyneside, tyne & wear with the factory premises t/n ty 157748.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 11/06/1985Registro de uma garantia
    • 20/08/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 21/09/1984
    Entregue em 28/09/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or sheaffer fabrications limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/09/1984Registro de uma garantia
    • 20/08/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0