CHIEFTAIN GROUP LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CHIEFTAIN GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01455149 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
- fabricação de outros produtos fabricados em metal n.e.c. (25990) / Indústrias transformadoras
- Outras instalações de construção (43290) / Construção
- Outras atividades de construção especializadas n.e. (43999) / Construção
Onde fica CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | c/o C/O REDHALL GROUP PLC Unit 3 Calder Close WF4 3BA Wakefield West Yorkshire England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| CHIEFTAIN GROUP P.L.C. | 11/08/1987 | 11/08/1987 |
| CHIEFTAIN INSULATION LIMITED | 18/10/1979 | 18/10/1979 |
Quais são as últimas contas de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/09/2017 |
Quais são as últimas submissões para CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Exercício contabilístico anterior prorrogado de 30/09/2018 para 31/03/2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/04/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Registo da garantia 014551490013, criada em 24/01/2019 | 46 páginas | MR01 | ||||||||||
Registo da garantia 014551490012, criada em 24/01/2019 | 45 páginas | MR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Russell David Haworth em 10/01/2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Término da nomeação de Wayne Pearson como diretor em 03/11/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Russell David Haworth como diretor em 03/11/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Philip Comer em 09/08/2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Término da nomeação de Christopher John Kelly como secretário em 01/07/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Mr Simon Philip Comer como secretário em 02/07/2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Christopher John Kelly como diretor em 29/06/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Simon Philip Comer como diretor em 02/07/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/04/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Philip Brierley como diretor em 31/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Wayne Pearson como diretor em 19/03/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/04/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN para C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA em 05/08/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2015 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 25/04/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Quem são os diretores de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMER, Simon Philip | Secretário | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 248241940001 | |||||||
| COMER, Simon Philip | Diretor | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | United Kingdom | British | 206088760003 | |||||
| HAWORTH, Russell David | Diretor | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 201533400002 | |||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Secretário | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| KELLY, Christopher John | Secretário | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 187596050001 | |||||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Secretário | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | British | 134974090001 | ||||||
| ADAMS, Laurence George | Diretor | 15 Rolley Way Castlefields NE42 5FH Prudhoe Northumberland | England | British | 87979230002 | |||||
| BRIERLEY, Philip | Diretor | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 54808010002 | |||||
| CORBISHLEY, Michael | Diretor | Overidge Farm Beckside Cartmel LA11 7SP Grange-Over-Sands Cumbria | England | British | 101553180002 | |||||
| COULSON, William Andrew | Diretor | 40 Holly Avenue Jesmond NE2 2PY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 36723860001 | |||||
| CUTCHIE, Anthony William | Diretor | 68 Davison Avenue NE26 3SU Whitley Bay Tyne & Wear | United Kingdom | British | 45955990001 | |||||
| DAWSON, John Frederic | Diretor | Park Dale LS29 6LW Menston 1 West Yorkshire | British | 8366360002 | ||||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Diretor | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| FLEETWOOD, Christopher John | Diretor | 4 The Meadows DL10 7DU Richmond North Yorkshire | United Kingdom | British | 1718030001 | |||||
| FOSTER, Robert Simon | Diretor | Aish TQ10 9JG South Brent Stamford Devon | England | British | 134973970001 | |||||
| GOODENOUGH, Anthony | Diretor | Bakery Drive Grange Park TS19 0SN Stockton-On-Tees 1 Cleveland | England | British | 139196050001 | |||||
| IREDALE, George Henry Cecil | Diretor | Redmays 14 North Lodge Lambton Park DH3 4AZ Chester Le Street County Durham | British | 141871680001 | ||||||
| JACKSON, David James | Diretor | 10 Stone Rings Close HG2 9HZ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 62867720010 | |||||
| JESTER, Tony | Diretor | 6 Cranbourne Drive TS10 2SP Redcar Cleveland | England | British | 107694130001 | |||||
| JOHNSON, Raymond | Diretor | 1 Colville Court DH9 6UW East Stanley County Durham | England | British | 266049760001 | |||||
| KELLY, Christopher John | Diretor | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 188444350001 | |||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Diretor | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | England | British | 134974090001 | |||||
| MARTINDALE, Stephen Richard | Diretor | Am Waldeck 14 FOREIGN 34537 Bad Wildungen Germany | Germany | British | 77194110002 | |||||
| O'KANE, John Peter | Diretor | Station Lane Burton Leonard HG3 3RU Harrogate Holly Cottage North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 106172200001 | |||||
| OLIVER, Malcolm William | Diretor | 12c Burtree Lane DL3 0XQ Darlington County Durham | England | British | 143300760001 | |||||
| PEARSON, Wayne | Diretor | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 212154420001 | |||||
| PENDLETON, Alan George | Diretor | 12 Harrop Road Hale WA15 9BX Altrincham Cheshire | British | 30248370001 | ||||||
| PRICE, Anthony Hall | Diretor | Irton CA19 1UZ Holmrook Mecklin Cumbria | England | British | 134973860001 | |||||
| SHIPPEN, Kenneth | Diretor | 14 Rectory Park NE61 2SZ Morpeth Northumberland | British | 67917400001 | ||||||
| SHUTTLEWORTH, Richard Peter | Diretor | c/o C/O Redhall Group Plc Red Hall Court WF1 2UN Wakefield 1 West Yorkshire England | England | British | 58727820002 | |||||
| TAYLOR, William Platt | Diretor | Ryton House Mainsforth DL17 9AA Ferryhill County Durham | British | 7203810001 | ||||||
| WARDLE, Peter | Diretor | 14 Brandling Park Jesmond NE2 4RR Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 73518260002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redhall Group Plc | 06/04/2016 | Calder Close Durkar WF4 3BA Wakefield Unit 3 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
CHIEFTAIN GROUP LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 24/01/2019 Entregue em 29/01/2019 | Pendente | ||
A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 24/01/2019 Entregue em 29/01/2019 | Pendente | ||
A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 24/12/2015 Entregue em 02/01/2016 | Pendente | ||
Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 21/01/2011 Entregue em 28/01/2011 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 30/04/2009 Entregue em 09/05/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee & debenture | Criado em 28/05/2004 Entregue em 17/06/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Chattel mortgage | Criado em 09/09/1996 Entregue em 12/09/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Dean smith & grace model 20SB surfacing and boring lathe 29IN swing serial no 28803 richards model PR2N horizontal facing and boring machine serial no 28803 atlas copco model GA708 packaged rotary screw air compressor serial no 753329 and 753330 for further details please see form 395. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 01/08/1996 Entregue em 13/08/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Premises at bath street walker newcastle upon tyne tyne and wear t/no:- ty 7137. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee and debenture | Criado em 02/11/1994 Entregue em 11/11/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee and debenture | Criado em 26/08/1992 Entregue em 09/09/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição See doc ref M593C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee & debenture | Criado em 20/01/1988 Entregue em 05/02/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 03/06/1985 Entregue em 11/06/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All that land at arrow close, killingwood north tyneside, tyne & wear with the factory premises t/n ty 157748. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee & debenture | Criado em 21/09/1984 Entregue em 28/09/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or sheaffer fabrications limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0