PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01458009 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
- desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção
Onde fica PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| CHARTWELL LAND INVESTMENTS LIMITED | 09/08/1988 | 09/08/1988 |
| CHARTWELL INVESTMENT LIMITED | 18/04/1988 | 18/04/1988 |
| WOOLWORTH PROPERTIES (GROUP INVESTMENT) LIMITED | 30/01/1987 | 30/01/1987 |
| COMPSTONE LIMITED | 31/10/1979 | 31/10/1979 |
Quais são as últimas contas de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2022 |
Quais são as últimas submissões para PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado do capital em 07/12/2022
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Virginia Warr como diretor em 03/11/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Gavin Bergin como diretor em 03/11/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jonathan Charles Mcnuff como diretor em 03/11/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2022 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Charles John Middleton como diretor em 31/03/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Ms Virginia Warr como diretor em 18/03/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Bruce Michael James como diretor em 31/12/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2021 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Gavin Bergin como diretor em 29/03/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Nick Taunt como diretor em 05/10/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Tom Robson como diretor em 11/09/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2020 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Josephine Hayman como diretor em 31/01/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Tom Robson como diretor em 31/01/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretário | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| HAYMAN, Josephine | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 266797860001 | |||||||||
| TAUNT, Nicholas Henry | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 275050860001 | |||||||||
| CLIFTON, Sally Jane | Secretário | Braeside Old Micheldever Road SP11 7AF Longparish Hampshire | British | 77925190001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secretário | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| ENOCH, Simon Jocelyn | Secretário | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | British | 61314280001 | ||||||||||
| LAWLEY, Anne Katharine | Secretário | 25 Parkside 17 Hamilton Road Ealing W5 2EG London | British | 39298940001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretário | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Secretário | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||||||
| STOKES, Martin Howard | Secretário | 1 Hazel Grove SO22 4PQ Winchester Hampshire | British | 7345750001 | ||||||||||
| AYRE, Timothy Andrew | Diretor | 14 Ridgmont Road AL1 3AF St Albans Hertfordshire | British | 1440830002 | ||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Diretor | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Diretor | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BERGIN, Gavin Joseph | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 251327820001 | |||||||||
| BLUNDELL, Roger Frederick Crawford | Diretor | Vineyard Hill Road SW19 7JL London 61 | England | British | 56525730002 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Diretor | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BURGESS, Richard John | Diretor | 54 Manor Road SM2 7AG Cheam Surrey | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | 35427700001 | |||||||||
| CARTER, Colin James | Diretor | 6 Hawthorn Close Firtree Road SM7 1ND Banstead Surrey | British | 39118310002 | ||||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Diretor | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Diretor | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| COLEMAN, David Michael | Diretor | Downings 18 Uplands Way Riverhead TN13 3BW Sevenoaks Kent | British | 2305220001 | ||||||||||
| CREEDY, Mark Peter | Diretor | 18 The Broadwalk HA6 2XD Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11841300002 | |||||||||
| CUTT, Michael Caslake | Diretor | Cedar House Coombe Lane Sunninghill SL5 7AT Ascot Berkshire | British | 72423090001 | ||||||||||
| ELLIOTT, Mark Steven | Diretor | 1 Elmwood AL8 6LD Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | 59140240001 | |||||||||
| FLEMING, Keith | Diretor | Dairy Cottage, Church Barns Church Bank Road, East Stratton SO21 3XA Winchester Hampshire | British | 96487450002 | ||||||||||
| GARDEN, Ian Graham | Diretor | 10 Prairie Street SW8 3PU London | British | 64361460001 | ||||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HARTWELL, Terrance | Diretor | Brambledene 231 Winchester Road SO53 2DX Chandlers Ford Hampshire | United Kingdom | British | 147043140001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Diretor | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| JONES, Alan Arnold | Diretor | Laurel Cottages Pump Meadow HP16 9EW Great Missenden Buckinghamshire | British | 1440820003 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Diretor | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LIGHT, Arthur Nicolas | Diretor | 88 Peperharow Road GU7 2PN Godalming Surrey | British | 851100001 | ||||||||||
| LINDSAY, Niall Gordon Brock | Diretor | Flat 4 8 Edge Hill SW19 4LP London | British | 62950250002 | ||||||||||
| MARSH, John Charles | Diretor | 25 Cambridge Street TN2 4SJ Tunbridge Wells Kent | British | 59140360001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Sunrise Limited | 06/04/2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Não | ||||
| |||||||
Natureza do controle
| |||||||
PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Security deposit deed | Criado em 24/07/1998 Entregue em 31/07/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement dated 7 july 1995 | |
Breve descrição £174,526.03. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Fixed legal charge | Criado em 20/06/1994 Entregue em 21/06/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of the principal agreement and under the terms of the legal charge | |
Breve descrição F/H-17, 18 and 19 northbrook street newbury berkshire t/n-BK55827. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 23/12/1988 Entregue em 11/01/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Sterling pounds 2000000 and all monies due or to be come due from the company and/or portswood developments limited to the chargee under the terms of an option agreement dated 23.12.88 | |
Breve descrição Land and buildings on the south side of bridge street dover kent title no k 621901 (part) title no k 476373 (whole). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 23/12/1988 Entregue em 11/01/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Sterling pounds 1500000 and all other monies due or to be come due from the company to the chargee under the terms of an option agreement dated 23.12.88 | |
Breve descrição Land and buildings on the south side of bridge street dover kent title no k 621901. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 14/11/1986 Entregue em 25/11/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descrição Various subjects shown on the form 395 refer for details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0