ALLVOTEC LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | ALLVOTEC LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01466217 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ALLVOTEC LIMITED?
- Outras atividades de telecomunicações (61900) / Informação e comunicação
- Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação
Onde fica ALLVOTEC LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Lindred House, 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de ALLVOTEC LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| DAISY IT SERVICES LIMITED | 01/12/2015 | 01/12/2015 |
| PHOENIX IT SERVICES LIMITED | 03/12/1998 | 03/12/1998 |
| PHOENIX COMPUTERS LIMITED | 20/03/1987 | 20/03/1987 |
| PHOENIX DIGITAL COMPUTERS LIMITED | 31/12/1980 | 31/12/1980 |
| FUTEX COMPUTERS LIMITED | 11/12/1979 | 11/12/1979 |
Quais são as últimas contas de ALLVOTEC LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2022 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para ALLVOTEC LIMITED?
| Última declaração de confirmação | |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 23/08/2023 |
Quais são as últimas submissões para ALLVOTEC LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Satisfação total da garantia 014662170016 | 1 páginas | MR04 | ||
Satisfação total da garantia 014662170015 | 1 páginas | MR04 | ||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 23/08/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Parte do bem ou empresa foi libertada da garantia 014662170016 | 1 páginas | MR05 | ||
Parte do bem ou empresa foi libertada da garantia 014662170015 | 1 páginas | MR05 | ||
Término da nomeação de Paul John Worthington como diretor em 31/03/2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Kristian Brian Lee como diretor em 31/03/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de David Gardner como diretor em 28/02/2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Contas anuais preparadas até 31/03/2022 | 53 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Liam Matthew Duncalf como diretor em 30/09/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr David Gardner em 30/09/2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Término da nomeação de Mark John Ames como diretor em 30/09/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de David Lewis Mcglennon como diretor em 30/09/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Nigel Smith como diretor em 30/09/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Matthew Robinson Riley como diretor em 30/09/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Stephen Alan Smith como diretor em 30/09/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Mr Paul John Worthington como diretor em 30/09/2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 23/08/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 páginas | AD03 | ||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 páginas | AD02 | ||
Contas anuais preparadas até 31/03/2021 | 54 páginas | AA | ||
Quem são os diretores de ALLVOTEC LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE, Kristian Brian | Diretor | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House, | England | British | 305579540001 | |||||
| BOLLAND, Martin Keith | Secretário | Flat 18 45 Marlborough Place St Johns Wood NW8 0PX London | British | 54898960001 | ||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Secretário | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||
| JONES, Philip | Secretário | 8 Hibiscus Close Billing Road East NN3 3QA Northampton Northamptonshire | British | 14317690002 | ||||||
| MARTIN, William Thomas | Secretário | Weavers Wainhill OX39 4AB Chinnor Oxfordshire | British | 57302660001 | ||||||
| MCGLENNON, David Lewis | Secretário | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | 199438760001 | |||||||
| ROBINSON, Paul | Secretário | 5 Overdale Close LE16 8FD Market Harborough Leicestershire | British | 53003280001 | ||||||
| SIMPSON, David Alan | Secretário | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | British | 80817560001 | ||||||
| STOKES, Reeta | Secretário | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | 173995430001 | |||||||
| TAYLOR, David | Secretário | The Old Rectory Bishampton Road, Flyford Flavell WR7 4BT Worcester Worcestershire | British | 1439590004 | ||||||
| TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes | Secretário | The Lakes Bedford Road NN4 7HD Northampton Lakeside House Northamptonshire England | 179703660001 | |||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Diretor | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||
| AMES, Mark John | Diretor | Crabtree Office Village Eversley Way TW20 8RY Egham Ashmead House England | United Kingdom | British | 209904560001 | |||||
| BASSFORD, David Maurice | Diretor | Eastcott Farm Porlock TA24 8JJ Minehead Somerset | British | 14317700002 | ||||||
| BERTRAM, Peter Michael | Diretor | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | England | British | 52852920002 | |||||
| BOLLAND, Martin Keith | Diretor | Flat 18 45 Marlborough Place St Johns Wood NW8 0PX London | British | 54898960001 | ||||||
| CLUTTON, Steven | Diretor | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 158222570001 | |||||
| COURTLEY, David John | Diretor | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 141213480001 | |||||
| CRAIG, John Bolton | Diretor | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire England | England | British | 186404470001 | |||||
| DUNCALF, Liam Matthew | Diretor | Crabtree Office Village Eversley Way TW20 8RY Egham Ashmead House England | United Kingdom | British | 257070630001 | |||||
| GARDNER, David | Diretor | Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | England | British | 277805290001 | |||||
| GRIGGS, Gavin Peter | Diretor | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | England | British | 154536120001 | |||||
| JONES, Andrew | Diretor | Fern House 5 The Green Great Houghton NN4 7AL Northampton | British | 56576390001 | ||||||
| JONES, Paul Edward | Diretor | Old Dairy Farm Water Stratford Road, Tingewick MK18 4NU Buckingham Buckinghamshire | British | 73670250002 | ||||||
| JONES, Philip | Diretor | 8 Hibiscus Close Billing Road East NN3 3QA Northampton Northamptonshire | British | 14317690002 | ||||||
| MACKENZIE, Thomas Alexander | Diretor | 27 King Henrys Road NW3 3QP London | United Kingdom | British | 60680850001 | |||||
| MARKE, Nathan Richard | Diretor | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 194292450001 | |||||
| MCGLENNON, David Lewis | Diretor | Crabtree Office Village Eversley Way TW20 8RY Egham Ashmead House England | United Kingdom | British | 181536600001 | |||||
| MCGLENNON, David Lewis | Diretor | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | 181536600001 | |||||
| MOULTON, Jonathan Paul | Diretor | Sequoia 57 Kippington Road TN13 2LL Sevenoaks Kent | British | 14450900001 | ||||||
| MULLER, Neil Keith | Diretor | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | England | British | 252490400001 | |||||
| NEVILLE, Stephen Anthony | Diretor | The Barn Blacksmiths Lane Aston Le Walls NN11 6UN Daventry Northamptonshire | England | British | 58293200001 | |||||
| PARRISH, Paul Rowland | Diretor | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 155461760001 | |||||
| RANDALL, Martin Alfred | Diretor | 6 Silver Glade West Chiltington RH20 2RQ Pulborough West Sussex | British | 32132310001 | ||||||
| RILEY, Matthew Robinson | Diretor | Crabtree Office Village Eversley Way TW20 8RY Egham Ashmead House England | United Kingdom | British | 283066870001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de ALLVOTEC LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allvotec Holdings Limited | 12/07/2019 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House Lancashire England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Daisy It Group Limited | 06/04/2016 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0