DOEFLEX LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaDOEFLEX LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01468914
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de DOEFLEX LIMITED?

    • Outro arrendamento e exploração de imóveis próprios ou arrendados (68209) / Atividades imobiliárias

    Onde fica DOEFLEX LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o JAMES COWPER KRESTON
    White Building 1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    Hampshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de DOEFLEX LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    KENSINGEAR LIMITED27/12/197927/12/1979

    Quais são as últimas contas de DOEFLEX LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Quais são as últimas submissões para DOEFLEX LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginas4.71

    Endereço do domicílio registado alterado de Latimer House 5 Cumberland Place Southampton SO15 2BH para C/O James Cowper Kreston White Building 1-4 Cumberland Place Southampton Hampshire SO15 2NP em 07/04/2016

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de 18 Rectory Close Guildford Surrey GU4 7AR England para Latimer House 5 Cumberland Place Southampton SO15 2BH em 05/02/2016

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 26/01/2016

    LRESSP

    Endereço do domicílio registado alterado de Units 1-4 Newcombe Drive Hawksworth Trading Estate Swindon SN2 1DX para 18 Rectory Close Guildford Surrey GU4 7AR em 27/10/2015

    1 páginasAD01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2014

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 23/04/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital11/05/2015

    Estado do capital em 11/05/2015

    • Capital: GBP 746,703.25
    SH01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2013

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 23/04/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital29/04/2014

    Estado do capital em 29/04/2014

    • Capital: GBP 746,703.25
    SH01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2012

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 23/04/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2011

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 23/04/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Término da nomeação de Glynn Berry como diretor

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de * New Kings Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 3LG* em 01/03/2012

    1 páginasAD01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2010

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 23/04/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Nomeação de Mr William Anthony Trendell como diretor

    3 páginasAP01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Times Place 45 Pall Mall London SW1Y 5JG* em 16/02/2011

    2 páginasAD01

    Nomeação de Mr Glynn Donovan Kirkby Berry como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Vita Industrial (Uk) Limited como secretário

    3 páginasTM02
    Anotações
    DataAnotação
    25/02/2011The document is a duplicate of TM02 registered on 15/02/2011 for Vita Industrial (UK) Limited.

    Término da nomeação de Michael Davies como diretor

    2 páginasTM01

    Quem são os diretores de DOEFLEX LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TRENDELL, William Anthony
    c/o James Cowper Kreston
    Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    White Building 1-4
    Hampshire
    Diretor
    c/o James Cowper Kreston
    Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    White Building 1-4
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director12317760001
    DENT, John
    Hazeldene Station Approach East
    Earlswood
    RH1 6JH Redhill
    Surrey
    Secretário
    Hazeldene Station Approach East
    Earlswood
    RH1 6JH Redhill
    Surrey
    British12774290001
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Secretário
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    British78366970002
    TEAGUE, Alan Richard
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    Secretário
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    British290650004
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Secretário
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    BritishAccountant12317760001
    VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    England
    Secretário
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro01468914
    109599980003
    BERRY, Glynn Donovan Kirkby
    Newcombe Drive
    Hawksworth Trading Estate
    SN2 1DX Swindon
    Units 1-4
    United Kingdom
    Diretor
    Newcombe Drive
    Hawksworth Trading Estate
    SN2 1DX Swindon
    Units 1-4
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director44533330003
    BICKERTON, Richard Henry Cheetham
    Send Grove
    Church Lane, Send
    GU23 7JL Woking
    Surrey
    Diretor
    Send Grove
    Church Lane, Send
    GU23 7JL Woking
    Surrey
    EnglandBritishAccountant12360020001
    BURLEY, Nicholas James
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Diretor
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritishAccountant / Chief Financial Officer122799590001
    DAVIES, Michael Gomer
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Diretor
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    UkBritishGeneral Manager154115450001
    DAVIES, Michael Gomer
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Diretor
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    UkBritishGeneral Manager154115450001
    DOBSON, Roy
    248 Compstall Road
    Romiley
    SK6 4JG Stockport
    Cheshire
    Diretor
    248 Compstall Road
    Romiley
    SK6 4JG Stockport
    Cheshire
    BritishDirector6930380002
    DURKIN, Thomas Frederick
    An Cala
    5 Dover Road, Branksome Park
    BH13 6DZ Poole
    Diretor
    An Cala
    5 Dover Road, Branksome Park
    BH13 6DZ Poole
    EnglandBritishManager83598360002
    ECCLES, Colin
    21 Ashe House
    Clevedon Road
    TW1 2TT Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    21 Ashe House
    Clevedon Road
    TW1 2TT Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishPlastics Technologist12360030002
    FRANCIS, Jeremy John Francis
    The White House Aston Hill
    Lewknor
    OX9 5SG Watlington
    Oxfordshire
    Diretor
    The White House Aston Hill
    Lewknor
    OX9 5SG Watlington
    Oxfordshire
    BritishDirector14024320001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    Diretor
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    EnglandBritishAccountant105961550001
    HARRIS, Howard Elliott
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    Diretor
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    BritishCompany Director93378750001
    HAY, Nigel Bruce
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Diretor
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritishDivisional Chief Executive Officer124316170001
    JOHNSON, David John
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Diretor
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritishGeneral Manager150755940001
    MAUNDRELL, Graham Lloyd
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Diretor
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritishHr Manager56093930002
    MERCER, Jim
    Kilnstones
    Longsleddale
    LA8 9BB Kendal
    Cumbria
    Diretor
    Kilnstones
    Longsleddale
    LA8 9BB Kendal
    Cumbria
    BritishCompany Director6753530002
    O'CONNOR, Calvin James John
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector16253240001
    PALMER, Peter Jack, Dr
    91 Marlborough Crescent
    Riverhead
    TN13 2HL Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    91 Marlborough Crescent
    Riverhead
    TN13 2HL Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector12360010001
    ROBINSON, Kenneth John
    The Little House Duck End
    Cranford
    NN14 4AD Kettering
    Northamptonshire
    Diretor
    The Little House Duck End
    Cranford
    NN14 4AD Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Director2616420001
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Diretor
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    EnglandBritishAccountant12317760001
    WRIGHT, Paul Martin
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Diretor
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    UkBritishDivisional Finance Director150691780001

    DOEFLEX LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 30/10/1991
    Entregue em 07/11/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/11/1991Registro de uma garantia (395)
    • 20/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 30/11/1987
    Entregue em 07/12/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/12/1987Registro de uma garantia
    • 28/10/1991Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 30/12/1981
    Entregue em 20/01/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H 42/44 holmethorpe avenue, redhill, surrey. Title no:- sy 220987.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/01/1982Registro de uma garantia
    Further guarantee & debentures
    Criado em 02/02/1981
    Entregue em 11/02/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that property undertaking & assets charged by the principal deed and further deed.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 11/02/1981Registro de uma garantia
    Guarantee & debenture
    Criado em 27/03/1980
    Entregue em 09/04/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or dozflex industries limited to the chargee on any account whatsoeever
    Breve descrição
    Fixed & floating charges undertaking and all property assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 09/04/1980Registro de uma garantia

    DOEFLEX LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    26/01/2016Início da liquidação
    08/12/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sandra Lillian Mundy
    James Cowper Llp Latimer House
    5 Cumberland Place
    SO15 2BH Southampton
    Hampshire
    Profissional
    James Cowper Llp Latimer House
    5 Cumberland Place
    SO15 2BH Southampton
    Hampshire
    Alan Peter Whalley
    James Cowper Llp Latimer House
    5 Cumberland Place
    SO15 2BH Southampton
    Profissional
    James Cowper Llp Latimer House
    5 Cumberland Place
    SO15 2BH Southampton

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0