JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED

JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaJAMES BUDGETT SUGARS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01472422
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    • (7499) /

    Onde fica JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    JAMES BUDGETT & SON LIMITED31/12/198031/12/1980
    LEGIBUS SEVENTY-TWO LIMITED11/01/198011/01/1980

    Quais são as últimas contas de JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Qual é o status da última declaração anual para JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 19/03/2014

    7 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 19/03/2013

    6 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House 5 Clanricarde Gardens Tunbridge Wells Kent TN1 1PE em 28/11/2012

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de 229 Crown Street Liverpool Merseyside L8 7RF United Kingdom em 28/03/2012

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    4 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 19/03/2012

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Cancellation of share premium account and / or capital redemption reserve 19/03/2012
    RES13

    Contas preparadas até 31/12/2010

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/05/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas preparadas até 31/12/2009

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/05/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Término da nomeação de Stephen Heslop como diretor

    1 páginasTM01

    Contas preparadas até 31/12/2008

    8 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas190

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas287

    Quem são os diretores de JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    NEWMAN, David Paul
    6 Pear Tree Hill
    Salfords
    RH1 5EG Redhill
    Surrey
    Secretário
    6 Pear Tree Hill
    Salfords
    RH1 5EG Redhill
    Surrey
    British19717140001
    MCDONOUGH, Michael John
    2 Cathedral Close
    SK16 5RN Dukinfield
    Cheshire
    Diretor
    2 Cathedral Close
    SK16 5RN Dukinfield
    Cheshire
    United KingdomBritish21094260001
    BARRELL, Simon Gregory
    11 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretário
    11 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    British41674130001
    FRIER, Alan Leslie
    45 Blackmore Road
    Kelvedon Common
    CM15 0AZ Brentwood
    Essex
    Secretário
    45 Blackmore Road
    Kelvedon Common
    CM15 0AZ Brentwood
    Essex
    British2828040001
    GREGORY, Neil Ralph
    45 Roman Road
    CM4 9AA Ingatestone
    Essex
    Secretário
    45 Roman Road
    CM4 9AA Ingatestone
    Essex
    British9184890001
    HUTCHINSON, Katherine Anna
    52 Pentney Road
    SW12 0NY London
    Secretário
    52 Pentney Road
    SW12 0NY London
    British9289720002
    MACFARLANE, David
    Churchfields House
    Codicote
    SG4 8TH Hitchin
    Hertfordshire
    Secretário
    Churchfields House
    Codicote
    SG4 8TH Hitchin
    Hertfordshire
    British67838620001
    MARCUS, Anthony Herbert Mervyn
    43 Elm Park Mansions
    Park Walk
    SW10 0AW London
    Secretário
    43 Elm Park Mansions
    Park Walk
    SW10 0AW London
    British32970002
    MOORE, Jane Alison
    5 Flag House
    47 Brunswick Court
    SE1 3LH London
    Secretário
    5 Flag House
    47 Brunswick Court
    SE1 3LH London
    British65320720002
    WITHERS, Gavin David
    1 Eversleigh Road
    EN5 1NE Barnet
    Hertfordshire
    Secretário
    1 Eversleigh Road
    EN5 1NE Barnet
    Hertfordshire
    British70079100001
    BARRATT, David
    12 Leeward Quay
    Sovereign Harbour
    BN23 5UD Eastbourne
    Sussex
    Diretor
    12 Leeward Quay
    Sovereign Harbour
    BN23 5UD Eastbourne
    Sussex
    EnglandBritish17037520008
    BARRELL, Simon Gregory
    11 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    Diretor
    11 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    British41674130001
    BRADY, John Patrick, Dr
    Waterstown House
    IRISH Sallins
    Co Kildare
    Ireland
    Diretor
    Waterstown House
    IRISH Sallins
    Co Kildare
    Ireland
    Irish80642440001
    CAMFIELD, Lee Mark, Mr.
    Waterloo Farm
    Mill Lane
    HP22 4PH Wingrave
    Buckinghamshire
    Diretor
    Waterloo Farm
    Mill Lane
    HP22 4PH Wingrave
    Buckinghamshire
    EnglandBritish98252290001
    DILGER, David John
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    Diretor
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    Irish74455510001
    FINK, Stanley, Lord
    13 The Broadwalk
    HA6 2XF Northwood
    Middlesex
    Diretor
    13 The Broadwalk
    HA6 2XF Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish118515860001
    FOSTER, Peter David
    70 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    Diretor
    70 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    British25037710001
    GIBSON, John Frederick
    Dipley Road
    Hartley Witney
    RG27 8JP Hook
    Old Orchard House
    Diretor
    Dipley Road
    Hartley Witney
    RG27 8JP Hook
    Old Orchard House
    EnglandBritish128842240001
    HEAPHY, William Anthony
    10 Eaton Brae
    Orwell Road
    Dublin 6
    Ireland
    Diretor
    10 Eaton Brae
    Orwell Road
    Dublin 6
    Ireland
    Irish17037540001
    HESLOP, Stephen
    Aberlyn
    KY11 3DP Charlestown
    Fyfe
    Diretor
    Aberlyn
    KY11 3DP Charlestown
    Fyfe
    ScotlandBritish153863130001
    JANSSIS, Joseph Charles
    14 Carlton Road
    RH1 2BX Redhill
    Surrey
    Diretor
    14 Carlton Road
    RH1 2BX Redhill
    Surrey
    United KingdomBritish38048490001
    KINDER, John Martineau
    55 Thornhill Square
    N1 1BE London
    Diretor
    55 Thornhill Square
    N1 1BE London
    United KingdomBritish1578300001
    MUGUIRO SARTORIUS, Rafael
    14 Alexander Square
    SW3 2AX London
    Diretor
    14 Alexander Square
    SW3 2AX London
    United KingdomSpanish58967780003
    MURPHY, Gerard Martin, Dr
    Treetops
    2 Moyleen Rise
    SL7 2DP Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    Treetops
    2 Moyleen Rise
    SL7 2DP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish43480870002
    O'HANLON, Paul Anthony
    27 Theberton Street
    Islington
    N1 0QY London
    Diretor
    27 Theberton Street
    Islington
    N1 0QY London
    EnglandBritish2828050001
    SCOTT, Andrew Hillyer
    Lower Lye
    Holloway, East Knoyle
    SP3 6AQ Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Lower Lye
    Holloway, East Knoyle
    SP3 6AQ Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish64012720001
    STONE, Michael John Christopher
    Ozleworth Park
    GL12 7QA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Diretor
    Ozleworth Park
    GL12 7QA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    United KingdomBritish35563920001
    THOMAS, Christopher Owen
    22 Woodlands Road
    SW13 0JZ London
    Diretor
    22 Woodlands Road
    SW13 0JZ London
    EnglandBritish9213140002
    VESTERDAL, Niels
    51b Longridge Road
    SW5 9SF London
    Diretor
    51b Longridge Road
    SW5 9SF London
    United KingdomDanish66012460002
    WITHERS, Gavin David
    1 Eversleigh Road
    EN5 1NE Barnet
    Hertfordshire
    Diretor
    1 Eversleigh Road
    EN5 1NE Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish70079100001

    JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed and floating charge
    Criado em 07/07/2004
    Entregue em 23/07/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transações
    • 23/07/2004Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 07/07/2004
    Entregue em 10/07/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/07/2004Registro de uma garantia (395)

    JAMES BUDGETT SUGARS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/03/2012Início da liquidação
    19/04/2015Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Vincent John Green
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Profissional
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Mark Newman
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Profissional
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0