CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Liquidação |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01521006 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 4 Abbey Orchard Street SW1P 2HT London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES GROUP LIMITED | 31/12/2001 | 31/12/2001 |
| KENNEDY CONSTRUCTION GROUP LIMITED | 08/10/1980 | 08/10/1980 |
Quais são as últimas contas de CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Vencido | Sim |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2017 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2018 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2016 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Vencido | Sim |
|---|---|
| Última declaração de confirmação elaborada até | 17/05/2019 |
| Próxima declaração de confirmação vence | 31/05/2019 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 17/05/2018 |
| Vencido | Sim |
Quais são as últimas submissões para CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereço do domicílio registado alterado de Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom para 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT em 03/10/2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR para Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX em 01/10/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Carillion (Am) Limited como pessoa com controlo significativo em 01/10/2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Ordem do tribunal para liquidar | 2 páginas | COCOMP | ||||||||||
Término da nomeação de Richard Francis Tapp como secretário em 25/06/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Término da nomeação de Lee James Mills como diretor em 18/06/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 17/05/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Nigel Paul Taylor como diretor em 29/09/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 17/05/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Stephen William Hudson como diretor em 17/04/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 17/05/2016 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 17/05/2015 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Nigel Paul Taylor em 17/03/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Stephen William Hudson em 02/03/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Lee James Mills em 02/03/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Mr Richard Francis Tapp em 02/03/2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 24 Birch Street Wolverhampton WV1 4HY para Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR em 02/03/2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 17/05/2014 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 17/05/2013 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Stephen William Hudson em 09/08/2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Quem são os diretores de CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Secretário | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Secretário | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Secretário | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| KIRKIN, Richard William | Secretário | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | British | 1180700001 | ||||||
| LEE, Christopher Michael | Secretário | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | 133709330001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Secretário | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Diretor | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| BODDINGTON, Richard Stewart | Diretor | Quercus House Winsford Road Cholmondeston CW7 4DP Winsford Cheshire | British | 15834890001 | ||||||
| CARNEY, Patrick | Diretor | 22 Carrwood Road SK9 5DL Wilmslow Cheshire | British | 27467650001 | ||||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Diretor | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| CARTER, Sholto Douglas Bowie | Diretor | 103 Appleby Road LA9 6HE Kendal Cumbria | British | 27715730002 | ||||||
| COCKER, Neil David | Diretor | 5 Rossett Close Kingsmead CW9 8WP Northwich Cheshire | England | British | 260158230001 | |||||
| COCLIFF, Stephen Jeffrey | Diretor | Coton Grange Coton Hill SY1 2PD Shrewsbury | England | British | 125427070002 | |||||
| DOUGHTY, Stuart John | Diretor | Bradley Farm House Kinlet DY12 3BU Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 31394540001 | |||||
| GRICE, Ian Michael | Diretor | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| HOUGH, Robert Eric | Diretor | Manor House 10 Theobald Road WA14 3HG Bowdon Cheshire | England | British | 38776360001 | |||||
| HUDSON, Stephen William | Diretor | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 78380050003 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Diretor | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| JONES, Peter Rudulph | Diretor | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Irish | 173952430001 | |||||
| KENNEDY, John Gerard | Diretor | 7 Rivershill Gardens Halebarns WA15 0AZ Altrincham Cheshire | Irish | 58803900001 | ||||||
| KENNEDY, Kathleen | Diretor | Brooks Drive WA15 8TL Hale Barns Cheshire | United Kingdom | Irish | 47720550002 | |||||
| KENNEDY, Patrick James | Diretor | Mayo Brooks Drive Halebarns WA15 8TL Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 47720560001 | |||||
| KIRKIN, Richard William | Diretor | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | England | British | 1180700001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Diretor | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MEMMOTT, Robert William | Diretor | Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DN Warrington Cheshire | British | 109306950001 | ||||||
| MILLS, Lee James | Diretor | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| PARSONS, James Christopher | Diretor | Chudleigh 34 Arthog Road Hale WA15 0LY Altrincham | British | 1180670002 | ||||||
| REID, John Watson | Diretor | The Laurels Park Gates Drive Cheadle Hulme SK8 7DF Cheadle Cheshire | England | British | 12949730002 | |||||
| ROBERTSON, Alan Robert | Diretor | Little Bote House Etherington Hill TN3 0TN Speldhurst Kent | British | 107595570001 | ||||||
| TAYLOR, Nigel Paul | Diretor | 40 Melton Street NW1 2FD London One Euston Square United Kingdom | United Kingdom | British | 162715410001 | |||||
| WILKINS, Andrew Michael | Diretor | PR25 | United Kingdom | British | 125411390001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion (Am) Limited | 06/04/2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Criado em 29/08/1997 Entregue em 10/09/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descrição Subject lying to the southwest side of union street hamilton t/n-lan 95859. subjects lying on the northwest side of goil avenue bellshill t/n-LAN90356. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 13/08/1997 Entregue em 16/08/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys, obligations and liabilities for the time being, owing or incurred by the obligors (as defined therein) to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined therein) and/or on any other account whatsoever | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Cash collateral security | Criado em 13/08/1997 Entregue em 15/08/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Assign the charged account being the account of the company with the depository (being the royal bank of scotland international limited) which account is blocked or designated as charged to the bank and the deposit being all sums at the date of the cash collateral security or thereafter standing to the credit of the charged account together with all interest and other amounts accruing on such sums (in whatever currency) together with all the rights titles and benefits of the company whatsoever present and future therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 10/06/1987 Entregue em 22/06/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H-land and buildings to the south-east side of chaddock lane astley tyldesley wigan greater manchester title no gm 387045 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 10/06/1987 Entregue em 22/06/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H-land and buildings to the north west side of choddock lane tyldesley wigan greater manchester fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 27/10/1983 Entregue em 07/11/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H land forming park of mayo blooks drive halo barns trafford, gt manchester together with all fixture whatsoever now or at any time hereafter afflxed or attached to the property or any part therof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1978. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge | Criado em 27/10/1981 Entregue em 29/10/1981 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For securing the sums due under a loan agreement dated 27 oct 1981 | |
Breve descrição Motor vehicles,daimler sovereign hba 71V daimler sovereign mnc 935W, rolls royce silver spirit dpm 1C. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 31/07/1981 Entregue em 18/08/1981 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed & floating charge undertaking and all property and all property and assetspresent and future including goodwill bookdebts uncalled capital & all fixtures & fittings (inc. Trade fixtures & fittings) fixed plant & machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação compulsória |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0