TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01529353 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
- (7499) /
Onde fica TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Auto Trader House Cutbushpark Industrial Estate Danehill Lower Earley RG6 4UT Reading Berkshire |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
ACORN COLOUR PRINT LIMITED | 19/05/1989 | 19/05/1989 |
ABLEMARGIN LIMITED | 12/05/1988 | 12/05/1988 |
ACORN WEB OFFSET LIMITED | 20/11/1980 | 20/11/1980 |
Quais são as últimas contas de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 03/04/2011 |
Quais são as últimas submissões para TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado do capital em 20/09/2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 03/04/2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Stephen Lane como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Tara Collet como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 20/05/2011 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Sean Glithero como secretário | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 28/03/2010 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 21/05/2010 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Sean Glithero em 30/09/2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Término da nomeação de Elizabeth Jenkin como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 20/05/2010 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Zillah Ellen Byng-Maddick como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Andrew Miller como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Unit 6 Thatcham Business Village Colthrop Lane Thatcham Berkshire RG19 4LW em 15/10/2009 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas preparadas até 29/03/2009 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de mudança de nome Company name changed acorn colour print LIMITED\certificate issued on 13/09/09 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
Quem são os diretores de TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLITHERO, Sean | Secretário | Hyde End Road Spencers Wood RG7 1DL Reading 262 Berkshire United Kingdom | 159905160001 | |||||||
BYNG-MADDICK, Zillah Ellen | Diretor | Danehill Lower Earley RG6 4UT Reading Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Finance Officer | 147214630001 | ||||
COLLET, Tara | Diretor | Wing Close SL7 2RA Marlow 2 Bucks United Kingdom | England | British | Group Financial Controller | 160951420001 | ||||
GLITHERO, Sean Robert | Diretor | Spencers Wood RG7 1DL Reading 262 Hyde End Road Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 129229070002 | ||||
ALLATT, Richard John | Secretário | 3 Spencer Walk BD23 2TX Skipton North Yorkshire | British | Director | 34728560001 | |||||
BESWITHERICK, David Peter | Secretário | 12 Horncastle Close BL8 1XE Bury Lancashire | British | Accountant | 15959630001 | |||||
GRIFFITH, David Richard | Secretário | 3 Foxcroft Church Crookham GU13 0JN Fleet Hampshire | British | 42734490001 | ||||||
HORNER, Angela Susan | Secretário | Birchview Birch Park Brockholes HD7 7BJ Huddersfield West Yorkshire | British | 13754360001 | ||||||
HOWARD, Katherine Frances | Secretário | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
JENKIN, Elizabeth | Secretário | Sundew Close RG40 5YB Wokingham 7 Berkshire United Kingdom | British | 137518870001 | ||||||
LACEY, Eugenia | Secretário | 151 Ash Street GU12 6LJ Ash Surrey | British | Treasurer | 79114130001 | |||||
MAYCOCK, Terence | Secretário | 10 Mentmore Gardens Appleton WA4 3HF Warrington | British | Accountant | 60515120001 | |||||
MILLER, Andrew Arthur | Secretário | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | Director | 162220750001 | |||||
MILLER, Andrew Arthur | Secretário | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
MILNE, Warwick | Secretário | 1 Whitland Avenue Heaton BL1 5FB Bolton Lancashire | British | Director | 86677260001 | |||||
MORAN, Michael John | Secretário | 97 Woodward Close Winnersh Farm RG11 5UU Wokingham Berkshire | British | Accountant | 49267860001 | |||||
PERRISS, Robyn | Secretário | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | Accountant | 97879810002 | |||||
FROGGETT, David | Diretor | Birchview Birch Park Brockholes HD7 7BJ Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 60401370001 | |||||
HARRIS, John Robert | Diretor | Court Haw Llanfair Talhairn LL22 8YP Abergele Conwy | British | Newspaper Executive | 33371970002 | |||||
HODGSON, Simon | Diretor | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | Accountant | 6848030001 | |||||
HORNER, Angela Susan | Diretor | Birchview Birch Park Brockholes HD7 7BJ Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 13754360001 | |||||
HOWARD, Katherine Frances | Diretor | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | Accountant | 86019470001 | |||||
HUNNINGS, Leonard William | Diretor | Melroy 26 Golf Links Road BH22 8BY Ferndown Dorset | British | Publisher | 6848040001 | |||||
LANE, Stephen John Roger | Diretor | 55 Matlock Road Caversham RG4 7BP Reading Berkshire | England | British | Accountant | 123670600001 | ||||
MILLER, Andrew Arthur | Diretor | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 162220750001 | ||||
MUIRHEAD, Brian Geoffrey | Diretor | Foxley House High Street OX7 5RH Great Rollright Oxfordshire | England | United Kingdom | Co Director | 155633620001 | ||||
PERRISS, Robyn | Diretor | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | Accountant | 97879810002 | |||||
SCHOFIELD, Peter | Diretor | The Whitehouse Church Lane Nacton IP10 0ES Ipswich Suffolk | British | Managing Director | 29860820002 |
TRADER MEDIA PRINT (LEEDS) LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Global accession deed | Criado em 03/10/2003 Entregue em 10/10/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 24/11/1989 Entregue em 06/12/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land & buildings off pontefract road, normanton, wakefield west yorkshire t/nos wyk 449821 wyk 427708 and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage debenture | Criado em 18/03/1988 Entregue em 31/03/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts and the benefit of any licences legal mortgage over unit 3 carr lane industrial estate, lowmoor, bradford, west yorkshire. T.n wyk 391126 and/or proceeds of sale thereof. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 10/04/1987 Entregue em 18/04/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descrição F/H unit b carr lane industrial estate law moor bradford county of west yorkshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 05/08/1986 Entregue em 19/08/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery stocks shares other securities all intellectual property rights. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage debenture | Criado em 22/03/1984 Entregue em 28/03/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof a fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0