SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01614052 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
- Agências de publicidade (73110) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| CORDIANT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | 16/03/1995 | 16/03/1995 |
| SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | 21/05/1982 | 21/05/1982 |
| BLANCHBERRY LIMITED | 15/02/1982 | 15/02/1982 |
Quais são as últimas contas de SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 5 páginas | DS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Justin Kenneth Billingsley como diretor em 02/07/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Ms Annette King como diretor em 29/06/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 27/03/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Ms Nicola Raj como secretário em 07/06/2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nomeação de Ms Sophie Marie Cassandre Martin-Chantepie como diretor em 31/03/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Justin Kenneth Billingsley como diretor em 31/03/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Robert Senior como diretor em 31/03/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Robert Senior como diretor em 31/03/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Alex Bekkerman como diretor em 31/03/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 27/03/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Raj Basran como secretário em 18/01/2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 27/03/2016 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Alan Harker como diretor em 03/07/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Alex Bekkerman como diretor em 30/06/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Robert Senior como diretor em 30/06/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Miss Joanne Munis como secretário em 07/04/2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Sarah Anne Bailey como secretário em 02/04/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Quem são os diretores de SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNIS, Joanne | Secretário | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | 196642710001 | |||||||
| RAJ, Nicola | Secretário | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building United Kingdom | 233357370001 | |||||||
| CARRIGAN, James Joseph, Mr. | Diretor | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | England | British | 127439710001 | |||||
| KING, Annette | Diretor | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | United Kingdom | British | 152540840001 | |||||
| MARTIN-CHANTEPIE, Sophie Marie Cassandre | Diretor | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | France | French | 228671040001 | |||||
| BAILEY, Sarah Anne | Secretário | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | 185511320001 | |||||||
| BASRAN, Raj | Secretário | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | 170042570001 | |||||||
| BINDING, David Wyn | Secretário | 48 Midhurst Avenue Muswell Hill N10 3EN London | British | 5994480001 | ||||||
| DAVIS, Robert | Secretário | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | British | 155474540001 | ||||||
| EARL, Elizabeth Louise Kiernan | Secretário | 9 Helena Road SL4 1JN Windsor Berkshire | British | 105197540001 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Secretário | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| EWING, Susanna | Secretário | 72f Sinclair Road W14 0NJ London | British | 122102410001 | ||||||
| GONZALEZ-GOMEZ, Minna Katariina | Secretário | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | Finnish | 119965730001 | ||||||
| JANS, Annamaria | Secretário | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||
| KURTZ, Catherine Elizabeth Strathmore | Secretário | 6 Berkeley Road TN1 1YR Tunbridge Wells Kent | British | 54236170003 | ||||||
| WALLS ECKLEY, Gillian | Secretário | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | 160075100001 | |||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Secretário | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||
| WYLLIE, Alison | Secretário | Flat 2 186 Ladbroke Grove W10 5LZ London | British | 107811220001 | ||||||
| BEKKERMAN, Alex | Diretor | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | England | American | 198886380001 | |||||
| BILLINGSLEY, Justin Kenneth | Diretor | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | England | Australian | 228671340001 | |||||
| BINDING, David Wyn | Diretor | 48 Midhurst Avenue Muswell Hill N10 3EN London | British | 5994480001 | ||||||
| BUNTON, Christopher John | Diretor | 12 The Chowns AL5 2BN Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 1321820001 | |||||
| COURET, Philippe Francois Pierre | Diretor | Flat 9 1 Prince Of Wales Terrace W8 5PG London | French | 68861790003 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Diretor | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| GRAHAM, Alec | Diretor | Linden Lea, Packhorse Road Bessels Green TN13 2QP Sevenoaks Kent | British | 73621260001 | ||||||
| HARKER, Alan | Diretor | Avonmore Road Kensington Village W14 8DG London Pembroke Building England | England | British | 174823410001 | |||||
| HOWELL, Peter Graham | Diretor | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||
| JANS, Annamaria | Diretor | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||
| SAATCHI, Charles | Diretor | 26 St Leonard's Terrace Chelsea SW3 4QG London | British | 11321230001 | ||||||
| SAATCHI, Maurice Nathan, The Lord | Diretor | 44 Bruton Place Berkeley Square W1X 7AA London | United Kingdom | British | 33348130002 | |||||
| SENIOR, Robert William | Diretor | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | England | British | 178019870001 | |||||
| SMYTH, Wendy | Diretor | Holly House Burtonhole Lane Mill Hill NW7 1AZ London | United Kingdom | British | 54779980001 | |||||
| WATSON, Robert Drummond | Diretor | 2 Whybourne Crest TN2 5BS Tunbridge Wells Kent | British | 11918650001 | ||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Diretor | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Diretor | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mms Uk Holdings Limited | 06/04/2016 | Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 15/12/1997 Entregue em 24/12/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement dated 30TH september 1997 (as defined) and/or the security documents (as defined) when the same become due for payment or discharge | |
Breve descrição By way of first legal mortgage the property (if any); by way of first fixed charge all present and future f/h and l/h property wheresoever situate; all plant machinery and other equipment; all book and other debts; the goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 16/04/1993 Entregue em 04/05/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantee and the standby facility agreement (as defined) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Subject facilities pledge agreement bridge facility pledge agreement | Criado em 27/03/1991 Entregue em 12/04/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee, under the terms of each relevant facility (as defined) and the agreement and/or this charge. | |
Breve descrição The company's interest in all securities and instrument collateral (see 395 and cont'd sheets for full details). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Subject facilities pledge agreement. New facility and standby facility pledge agreement | Criado em 27/03/1991 Entregue em 12/04/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee under the terms of each relevant facility (as defined) and the agreement and/or this charge | |
Breve descrição The company's interest in all securities and instrument collateral (see 395 and cont'd sheets for full details). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Subject facilities pledge agreement. | Criado em 27/03/1991 Entregue em 12/04/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee under the terms of each relevant facility (as defined) and the agreement and/or this charge | |
Breve descrição The company's interest in all securities and instrument collateral (see form 395 & cont'd sheets for full details). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0