POSTERSCOPE LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | POSTERSCOPE LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01630792 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de POSTERSCOPE LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica POSTERSCOPE LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 10 Triton Street Regent's Place NW1 3BF London United Kingdom |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de POSTERSCOPE LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
HARRISON, SALINSON & COMPANY LIMITED | 26/05/1982 | 26/05/1982 |
HARRISON HOME FURNISHING LIMITED | 23/04/1982 | 23/04/1982 |
Quais são as últimas contas de POSTERSCOPE LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2019 |
Quais são as últimas submissões para POSTERSCOPE LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Estado do capital em 02/12/2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomeação de Mr Dennis Romijn como diretor em 19/11/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Stephen Charles Whyte como diretor em 19/11/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019 | 9 páginas | AA | ||||||||||||||
Término da nomeação de Andrew John Moberly como secretário em 29/02/2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018 | 9 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 9 páginas | AA | ||||||||||||||
Término da nomeação de Anne Teresa Rickard como diretor em 28/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Stephen Charles Whyte como diretor em 28/03/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Mary Margaret Basterfield como diretor em 09/02/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 9 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nomeação de Ms Mary Margaret Basterfield como diretor em 12/10/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Claire Margaret Price como diretor em 12/10/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 9 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 31/01/2016 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Quem são os diretores de POSTERSCOPE LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMIJN, Dennis | Diretor | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom | Netherlands | Dutch | Company Director | 272475570001 | ||||
WILSON, Glen Brooks | Diretor | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom | England | British | Deputy Managing Director | 53530020004 | ||||
BLETSO, David Roy | Secretário | Ember Place Carleton Close KT10 8EE Esher Surrey | British | Finance Director | 105756170002 | |||||
CORE, Peter | Secretário | 37 Linhope Street NW1 6HU London | British | Accountant | 42044680002 | |||||
GRIFFITHS, Matthew Lloyd | Secretário | 27 Barrow Green Road RH8 0NJ Oxted Surrey | British | Company Secretary | 10140500002 | |||||
HOLGATE, Nicholas James | Secretário | 14 Chalcott Gardens KT6 5HJ Long Ditton Surrey | British | Finance Director | 181596610001 | |||||
MOBERLY, Andrew John | Secretário | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom United Kingdom | 153997170001 | |||||||
O'RIELLY, Kathryn | Secretário | Ramsden Road SW12 8RD London 111b United Kingdom | British | Finance Director | 138119040001 | |||||
SALINSON, Judith Rosemary | Secretário | 8c Grove End House Grove End Road NW8 9HN London | British | 39794240002 | ||||||
THOMAS, Caroline Emma Roberts | Secretário | Broomsleigh Street NW6 1QQ London 5 | British | 149084960001 | ||||||
ADAMS, Michele Susan | Diretor | 30 Kendal Road BN3 5HZ Hove East Sussex | United Kingdom | British | Director | 73578720001 | ||||
BALL, Maggie | Diretor | 98 Ridley Road Forest Gate E7 0LX London | British | Account Director | 10140490001 | |||||
BASTERFIELD, Mary Margaret | Diretor | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 295094520001 | ||||
BLETSO, David Roy | Diretor | Ember Place Carleton Close KT10 8EE Esher Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 105756170002 | ||||
BOND, Steve Alan | Diretor | Clover Hill House Coldharbour Road K14 6JN West Byfleet Surrey | England | British | Managing Director | 182585950001 | ||||
BOOTH, Linda | Diretor | 122 Harbut Road SW11 2RE London | British | International Director | 40225210001 | |||||
BRYANT, Frank | Diretor | 36 Wickets Way Hainault IG6 3DF Ilford Essex | United Kingdom | British | Director | 53422810001 | ||||
CORE, Peter | Diretor | 37 Linhope Street NW1 6HU London | British | Accountant | 42044680002 | |||||
DAVIES, James Matthew | Diretor | 28 Amesbury Road BR1 2QJ Bromley Kent | Uk | British | Director | 101263830001 | ||||
DAVIS, Nicholas George Philip | Diretor | 72 Old Shoreham Road BN1 5DD Brighton East Sussex | United Kingdom | British | Director | 44794620002 | ||||
GLYDON, Patrick Richard | Diretor | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom United Kingdom | England | British | Company Director | 110646220001 | ||||
GORDON, David Russell | Diretor | 41 Compton Road Wimbledon SW19 7QA London | United Kingdom | British | Director | 79643420001 | ||||
GRIFFITHS, Matthew Lloyd | Diretor | 27 Barrow Green Road RH8 0NJ Oxted Surrey | England | British | Company Secretary | 10140500002 | ||||
HARRISON, David Ernest | Diretor | Gretels Corner Grimms Hill HP16 9BA Great Missenden Buckinghamshire | British | Chairman | 6181360001 | |||||
HOLGATE, Nicholas James | Diretor | 14 Chalcott Gardens KT6 5HJ Long Ditton Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 181596610001 | ||||
JOHNSON, Shirley | Diretor | 19 Woodgrange Avenue Ealing W5 2NY London | British | Company Director | 41843150001 | |||||
JONES, Bryn | Diretor | 3 Highdown KT4 7JA Worcester Park Surrey | British | Buying Director | 10140480001 | |||||
KNOTT, Mungo | Diretor | 21 Windsor Drive EN4 8UE Barnet Hertfordshire | British | Buying Director | 49149110001 | |||||
LANGRIDGE, Roy Edward | Diretor | Star House Star Corner SM14 8DG Colerne Wiltshire | British | Director | 26923350001 | |||||
MADDISON-ROBERTS, Keith | Diretor | 2 Balfour Place SL7 3TB Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 34725230001 | ||||
O'HARE, Malachy Stephen | Diretor | 1 Laurel Park Randalstown BT41 3HJ County Antrim Northern Ireland | Irish | Managing Director(Ireland | 145805940001 | |||||
PRICE, Claire Margaret | Diretor | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom United Kingdom | England | British | Company Director | 181956820001 | ||||
RICKARD, Anne Teresa | Diretor | The Gables Grove Hill HA1 3HE Harrow On The Hill Middlesex | England | British | Chief Executive | 49624130001 | ||||
ROSENTHAL, Robert | Diretor | 11 Great Bushey Drive N20 8QN London | United Kingdom | British | Director | 98645340001 | ||||
SALINSON, Judith Rosemary | Diretor | 8c Grove End House Grove End Road NW8 9HN London | England | British | Managing Director | 39794240002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de POSTERSCOPE LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dentsu Aegis London Limited | 06/04/2016 | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
POSTERSCOPE LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Criado em 17/11/1993 Entregue em 24/11/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility agreement dated 10TH november 1993 and this deed | |
Breve descrição All stocks shares and/or other securities of the companies specified on form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Supplemental composite guarantee and charge | Criado em 12/11/1993 Entregue em 25/11/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the "facilities" (as defined) and this charge | |
Breve descrição All of the company's stocks shares and/or other securities as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Composite guarantee and charge | Criado em 14/09/1992 Entregue em 25/09/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the composite guarantee and charge and facilities agreement dated 7TH may 1991 (as defined) | |
Breve descrição First floating charge over undertaking all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future including stock in trade the deposit relating to the charged property (as defined) see form 395 ref M102. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge over credit balances | Criado em 20/02/1989 Entregue em 28/02/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee d/d 16/12/88 for £31,000 infavour of C.I.a limited in respect of an agreement made on 15/12/88 | |
Breve descrição The sum of £31,000 together with interest accrued or to the held by the bank on an account earmarked or designated by reference to the company account no. 03811492. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0