POSTERSCOPE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPOSTERSCOPE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01630792
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de POSTERSCOPE LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica POSTERSCOPE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    10 Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de POSTERSCOPE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HARRISON, SALINSON & COMPANY LIMITED26/05/198226/05/1982
    HARRISON HOME FURNISHING LIMITED23/04/198223/04/1982

    Quais são as últimas contas de POSTERSCOPE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2019

    Quais são as últimas submissões para POSTERSCOPE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Estado do capital em 02/12/2020

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Cancel share prem a/c 23/11/2020
    RES13

    Nomeação de Mr Dennis Romijn como diretor em 19/11/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Stephen Charles Whyte como diretor em 19/11/2020

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019

    9 páginasAA

    Término da nomeação de Andrew John Moberly como secretário em 29/02/2020

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017

    9 páginasAA

    Término da nomeação de Anne Teresa Rickard como diretor em 28/03/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen Charles Whyte como diretor em 28/03/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Mary Margaret Basterfield como diretor em 09/02/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Nomeação de Ms Mary Margaret Basterfield como diretor em 12/10/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Claire Margaret Price como diretor em 12/10/2016

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    9 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/01/2016 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/02/2016

    Estado do capital em 04/02/2016

    • Capital: GBP 9,000
    SH01

    Quem são os diretores de POSTERSCOPE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ROMIJN, Dennis
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    Diretor
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCompany Director272475570001
    WILSON, Glen Brooks
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    Diretor
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritishDeputy Managing Director53530020004
    BLETSO, David Roy
    Ember Place
    Carleton Close
    KT10 8EE Esher
    Surrey
    Secretário
    Ember Place
    Carleton Close
    KT10 8EE Esher
    Surrey
    BritishFinance Director105756170002
    CORE, Peter
    37 Linhope Street
    NW1 6HU London
    Secretário
    37 Linhope Street
    NW1 6HU London
    BritishAccountant42044680002
    GRIFFITHS, Matthew Lloyd
    27 Barrow Green Road
    RH8 0NJ Oxted
    Surrey
    Secretário
    27 Barrow Green Road
    RH8 0NJ Oxted
    Surrey
    BritishCompany Secretary10140500002
    HOLGATE, Nicholas James
    14 Chalcott Gardens
    KT6 5HJ Long Ditton
    Surrey
    Secretário
    14 Chalcott Gardens
    KT6 5HJ Long Ditton
    Surrey
    BritishFinance Director181596610001
    MOBERLY, Andrew John
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Secretário
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    153997170001
    O'RIELLY, Kathryn
    Ramsden Road
    SW12 8RD London
    111b
    United Kingdom
    Secretário
    Ramsden Road
    SW12 8RD London
    111b
    United Kingdom
    BritishFinance Director138119040001
    SALINSON, Judith Rosemary
    8c Grove End House
    Grove End Road
    NW8 9HN London
    Secretário
    8c Grove End House
    Grove End Road
    NW8 9HN London
    British39794240002
    THOMAS, Caroline Emma Roberts
    Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    5
    Secretário
    Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    5
    British149084960001
    ADAMS, Michele Susan
    30 Kendal Road
    BN3 5HZ Hove
    East Sussex
    Diretor
    30 Kendal Road
    BN3 5HZ Hove
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector73578720001
    BALL, Maggie
    98 Ridley Road
    Forest Gate
    E7 0LX London
    Diretor
    98 Ridley Road
    Forest Gate
    E7 0LX London
    BritishAccount Director10140490001
    BASTERFIELD, Mary Margaret
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    Diretor
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director295094520001
    BLETSO, David Roy
    Ember Place
    Carleton Close
    KT10 8EE Esher
    Surrey
    Diretor
    Ember Place
    Carleton Close
    KT10 8EE Esher
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director105756170002
    BOND, Steve Alan
    Clover Hill House
    Coldharbour Road
    K14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Diretor
    Clover Hill House
    Coldharbour Road
    K14 6JN West Byfleet
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director182585950001
    BOOTH, Linda
    122 Harbut Road
    SW11 2RE London
    Diretor
    122 Harbut Road
    SW11 2RE London
    BritishInternational Director40225210001
    BRYANT, Frank
    36 Wickets Way
    Hainault
    IG6 3DF Ilford
    Essex
    Diretor
    36 Wickets Way
    Hainault
    IG6 3DF Ilford
    Essex
    United KingdomBritishDirector53422810001
    CORE, Peter
    37 Linhope Street
    NW1 6HU London
    Diretor
    37 Linhope Street
    NW1 6HU London
    BritishAccountant42044680002
    DAVIES, James Matthew
    28 Amesbury Road
    BR1 2QJ Bromley
    Kent
    Diretor
    28 Amesbury Road
    BR1 2QJ Bromley
    Kent
    UkBritishDirector101263830001
    DAVIS, Nicholas George Philip
    72 Old Shoreham Road
    BN1 5DD Brighton
    East Sussex
    Diretor
    72 Old Shoreham Road
    BN1 5DD Brighton
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector44794620002
    GLYDON, Patrick Richard
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Diretor
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director110646220001
    GORDON, David Russell
    41 Compton Road
    Wimbledon
    SW19 7QA London
    Diretor
    41 Compton Road
    Wimbledon
    SW19 7QA London
    United KingdomBritishDirector79643420001
    GRIFFITHS, Matthew Lloyd
    27 Barrow Green Road
    RH8 0NJ Oxted
    Surrey
    Diretor
    27 Barrow Green Road
    RH8 0NJ Oxted
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary10140500002
    HARRISON, David Ernest
    Gretels Corner Grimms Hill
    HP16 9BA Great Missenden
    Buckinghamshire
    Diretor
    Gretels Corner Grimms Hill
    HP16 9BA Great Missenden
    Buckinghamshire
    BritishChairman6181360001
    HOLGATE, Nicholas James
    14 Chalcott Gardens
    KT6 5HJ Long Ditton
    Surrey
    Diretor
    14 Chalcott Gardens
    KT6 5HJ Long Ditton
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director181596610001
    JOHNSON, Shirley
    19 Woodgrange Avenue Ealing
    W5 2NY London
    Diretor
    19 Woodgrange Avenue Ealing
    W5 2NY London
    BritishCompany Director41843150001
    JONES, Bryn
    3 Highdown
    KT4 7JA Worcester Park
    Surrey
    Diretor
    3 Highdown
    KT4 7JA Worcester Park
    Surrey
    BritishBuying Director10140480001
    KNOTT, Mungo
    21 Windsor Drive
    EN4 8UE Barnet
    Hertfordshire
    Diretor
    21 Windsor Drive
    EN4 8UE Barnet
    Hertfordshire
    BritishBuying Director49149110001
    LANGRIDGE, Roy Edward
    Star House
    Star Corner
    SM14 8DG Colerne
    Wiltshire
    Diretor
    Star House
    Star Corner
    SM14 8DG Colerne
    Wiltshire
    BritishDirector26923350001
    MADDISON-ROBERTS, Keith
    2 Balfour Place
    SL7 3TB Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    2 Balfour Place
    SL7 3TB Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector34725230001
    O'HARE, Malachy Stephen
    1 Laurel Park
    Randalstown
    BT41 3HJ County Antrim
    Northern Ireland
    Diretor
    1 Laurel Park
    Randalstown
    BT41 3HJ County Antrim
    Northern Ireland
    IrishManaging Director(Ireland145805940001
    PRICE, Claire Margaret
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Diretor
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director181956820001
    RICKARD, Anne Teresa
    The Gables Grove Hill
    HA1 3HE Harrow On The Hill
    Middlesex
    Diretor
    The Gables Grove Hill
    HA1 3HE Harrow On The Hill
    Middlesex
    EnglandBritishChief Executive49624130001
    ROSENTHAL, Robert
    11 Great Bushey Drive
    N20 8QN London
    Diretor
    11 Great Bushey Drive
    N20 8QN London
    United KingdomBritishDirector98645340001
    SALINSON, Judith Rosemary
    8c Grove End House
    Grove End Road
    NW8 9HN London
    Diretor
    8c Grove End House
    Grove End Road
    NW8 9HN London
    EnglandBritishManaging Director39794240002

    Quem são as pessoas com controle significativo de POSTERSCOPE LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    06/04/2016
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro1939690
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    POSTERSCOPE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 17/11/1993
    Entregue em 24/11/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility agreement dated 10TH november 1993 and this deed
    Breve descrição
    All stocks shares and/or other securities of the companies specified on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Societe Generale
    Transações
    • 24/11/1993Registro de uma garantia (395)
    • 22/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental composite guarantee and charge
    Criado em 12/11/1993
    Entregue em 25/11/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the "facilities" (as defined) and this charge
    Breve descrição
    All of the company's stocks shares and/or other securities as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co.Limitedas Agent and Trustee for the Banks
    Transações
    • 25/11/1993Registro de uma garantia (395)
    • 22/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and charge
    Criado em 14/09/1992
    Entregue em 25/09/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the composite guarantee and charge and facilities agreement dated 7TH may 1991 (as defined)
    Breve descrição
    First floating charge over undertaking all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future including stock in trade the deposit relating to the charged property (as defined) see form 395 ref M102.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co.Limitedas Trustee and Agent for the Banks
    Transações
    • 25/09/1992Registro de uma garantia (395)
    • 22/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over credit balances
    Criado em 20/02/1989
    Entregue em 28/02/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee d/d 16/12/88 for £31,000 infavour of C.I.a limited in respect of an agreement made on 15/12/88
    Breve descrição
    The sum of £31,000 together with interest accrued or to the held by the bank on an account earmarked or designated by reference to the company account no. 03811492.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 28/02/1989Registro de uma garantia
    • 22/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0