COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED

COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCOMFORT LODGE (U.K.) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01653513
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    • Hotéis e alojamentos semelhantes (55100) / Alojamento, restauração e similares

    Onde fica COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    JOYHATCH LIMITED23/07/198223/07/1982

    Quais são as últimas contas de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    Quais são as últimas submissões para COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    10 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 27/06/2018

    9 páginasLIQ03

    Resolução de insolvência

    Resolution insolvency:re res assets in specie
    1 páginasLIQ MISC RES

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Maple Court Central Park Reeds Crescent Watford Hertfordshire WD24 4QQ

    2 páginasAD03

    Endereço do domicílio registado alterado de Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford Herts WD24 4QQ para 1 More London Place London SE1 2AF em 18/07/2017

    2 páginasAD01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para Maple Court Central Park Reeds Crescent Watford Hertfordshire WD24 4QQ

    2 páginasAD02

    Resolução de insolvência

    Resolution insolvency:resolution in respect of remuneration etc
    1 páginasLIQ MISC RES

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 28/06/2017

    LRESSP

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Término da nomeação de Oded Lifschitz como diretor em 07/06/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Christopher Philip Heath como diretor em 07/06/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Simon Robert Vincent como diretor em 07/06/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Brian Wilson como diretor em 09/06/2017

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 03/06/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Brian Wilson em 26/04/2017

    2 páginasCH01

    Segunda apresentação para a nomeação de Christopher Heath como administrador

    6 páginasRP04AP01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    18 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stuart Beasley em 12/08/2016

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr Christopher Heath como diretor em 15/07/2016

    3 páginasAP01
    Anotações
    DataAnotação
    24/01/2017Clarification A second filed AP01 was registered on 24/01/2017.

    Declaração anual preparada até 03/06/2016 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital17/06/2016

    Estado do capital em 17/06/2016

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Robert Vincent em 21/08/2014

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 03/06/2015 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital09/06/2015

    Estado do capital em 09/06/2015

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Quem são os diretores de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HLT SECRETARY LIMITED
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secretário
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    125128960001
    BEASLEY, Stuart
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish188237620002
    PERCIVAL, James Owen
    Castle Hill
    HP4 1HE Berkhamsted
    18
    England
    United Kingdom
    Diretor
    Castle Hill
    HP4 1HE Berkhamsted
    18
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish161274380001
    HUGHES, Barbara
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    Secretário
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    British45702460001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Secretário
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secretário
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    ANDREW, David
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    Diretor
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    British41761510002
    BAMSEY, John Anthony
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    Diretor
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    EnglandBritish130102260001
    BOULD, Christopher John
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    Diretor
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    British110275470001
    BRADLEY, Adrian Paul
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish90379240002
    DOBBS, John Anthony
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    British120544260001
    FARROW, James Roger Charles
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    Diretor
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    British9585240001
    FRIEDMAN, Howard
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Usa106914780001
    GOSLING, Peter Charles
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    Diretor
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    EnglandEnglish142633640001
    HARRIS, Anthony Richard
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    Diretor
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    British64357620006
    HARVEY, Paul Victor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    Diretor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    British116809270001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Diretor
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HEATH, Christopher Philip
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    United Kingdom
    Diretor
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    United Kingdom
    EnglandBritish205835660001
    HIRST, Michael Barry
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish40994810001
    HUGHES, Andrew Lawrence
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish109749210001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Diretor
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    British143730250001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Diretor
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    British143730250001
    JAMES, Paul Frederick
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    British48791500001
    JONES, Annie Marie
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish162019090001
    LICHMAN, Laurence
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    Diretor
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    British143730380001
    LIFSCHITZ, Oded
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    Diretor
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    United KingdomAustralian / Israeli172992020002
    LYLE, Gordon William
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Diretor
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish143730330001
    MAIDEN, George Barry
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Diretor
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British8832120001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40294180002
    NEUMANN, Wolfgang
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Diretor
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Austria87699600002
    PHILIP, John Crosbie
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish102495550001
    POTTER, Anthony Grahame
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British62316310001
    RABIN, Elizabeth Jane
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish125139540001
    ROGERS, John
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish162807030001
    SHILL, Rosemarie
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    Diretor
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    United KingdomBritish89948030001

    Quem são as pessoas com controle significativo de COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    06/04/2016
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro01350772
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 24/03/1986
    Entregue em 26/03/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 500,000
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Town & County Factors Limited
    Transações
    • 26/03/1986Registro de uma garantia
    • 20/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 24/03/1986
    Entregue em 26/03/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 1,500,000
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • W.Crowther & Sons PLC
    Transações
    • 26/03/1986Registro de uma garantia
    Standard security registered in scotland on 12/2/85.
    Criado em 14/02/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26/6/84 entitled "second debenture 'a'"
    Breve descrição
    Lease by livingston development corporation in favour of the co. Recorded in the division of the general register of sasines for the county for midlothian on 10/9/84.
    Pessoas com direito
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    Standard security registered in scotland on 12/2/85.
    Criado em 14/02/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two seperate debentures issued by the co to the creditor dated 26/6/84. entitled "first debenture 'a'" and "first debenture 'b"
    Breve descrição
    Lease by livingston development corporation in favour of the co. Recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 10/9/84.
    Pessoas com direito
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    Second equitable charge
    Criado em 02/02/1985
    Entregue em 02/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26 june 84 or under the terms of this charge.
    Breve descrição
    All that piece or parcel of land k/a site 5 phoenix way swansea enterprise park llansamlet, swansea. (See doc for further details).
    Pessoas com direito
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transações
    • 02/02/1985Registro de uma garantia
    Equitable charge
    Criado em 02/02/1985
    Entregue em 02/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two debentures dated 26 june 84 or under the terms of this charge.
    Breve descrição
    All that piece or parcel of land k/a site 5 phoenix way swansea enterprise park llansamlet, swansea. (See doc for further details).
    Pessoas com direito
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transações
    • 02/02/1985Registro de uma garantia
    Second equitable charge
    Criado em 02/02/1985
    Entregue em 02/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26 april 1984 or under the terms of this charge.
    Breve descrição
    All that piece or parcel of land comprising 5.6 acres situate at the corner of old common road and london road black dam basingstoke, hampshire. (See doc for further details).
    Pessoas com direito
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transações
    • 02/02/1985Registro de uma garantia
    Equitable charge
    Criado em 02/02/1985
    Entregue em 02/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the two debentures dated 26 june 84 or under the terms of this charge
    Breve descrição
    All that piece or parcel of land which comprises 5.6 acres situate at the corner of old common road and london road black dam basingstoke hampshire (see doc for details).
    Pessoas com direito
    • W.Crowther & Sons PLC
    Transações
    • 02/02/1985Registro de uma garantia
    Second equitable charge
    Criado em 18/01/1985
    Entregue em 01/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26/6/84
    Breve descrição
    All that piece or parcel of land which comprises 5.6 acres or thereabouts situate at the corner of old common road and london road black dam basingstoke, hampshire (see doc M23 for details).
    Pessoas com direito
    • Comfort Lodge Limited
    Transações
    • 01/02/1985Registro de uma garantia
    • 19/10/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Second equitable charge.
    Criado em 18/01/1985
    Entregue em 01/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26/6/84
    Breve descrição
    All that piece or parcel of land known as site 5 phoenix way, swansea enterprise park llansamlet swansea. (See doc M22 for details).
    Pessoas com direito
    • Comfort Lodge Limited
    Transações
    • 01/02/1985Registro de uma garantia
    • 19/10/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security registered in scotland on 12/2/85.
    Criado em 17/01/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 26/6/84 entitled "second debenture 'b'"
    Breve descrição
    Lease by livingstone development corporation in favour of the company recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 10/9/84.
    Pessoas com direito
    • Comfort Lodge LTD.
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    • 19/10/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 26/06/1984
    Entregue em 12/07/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 2000,000 supplemental to the joint venture agreement and finance agreement dated 28 june 1984
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • W. Crowther & Sons PLC.
    Transações
    • 12/07/1984Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 26/06/1984
    Entregue em 12/07/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 950,000 supplemental to the joint venture agreement and finance agreement dated 28TH june 1984
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • W. Crowther & Sons PLC.
    Transações
    • 12/07/1984Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 26/06/1984
    Entregue em 12/07/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 950,000 supplemental to the joint venture agreement and finance agreement dated 28 june 1983
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Comfort Lodge Limited
    Transações
    • 12/07/1984Registro de uma garantia
    • 20/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 26/06/1984
    Entregue em 12/07/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 6,000,000 supplemental to a joint venture agreement and finance agreement dated 28 june 1983.
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • W.Crowther & Sons PLC.
    Transações
    • 12/07/1984Registro de uma garantia

    COMFORT LODGE (U.K.) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    28/06/2017Início da liquidação
    10/11/2018Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profissional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profissional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0