WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED

WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaWEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01665733
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Lindred House 20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    COLTDATA LIMITED21/09/198221/09/1982

    Quais são as últimas contas de WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2021

    Quais são as últimas submissões para WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2021 sem atualizações

    2 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2021

    9 páginasAA

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2020

    18 páginasAA

    O processo de dissolução compulsória foi descontinuado

    1 páginasDISS40

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr David Gardner como diretor em 11/12/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Glen Norman Williams como diretor em 11/12/2020

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Alteração dos detalhes de Corporate Solutions Group Limited como pessoa com controlo significativo em 18/12/2019

    2 páginasPSC05

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Milton Gate 60 Chiswell Street London EC1Y 4AG United Kingdom para Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR

    1 páginasAD02

    Satisfação total da garantia 016657330010

    1 páginasMR04

    Endereço do domicílio registado alterado de Ashmead House Eversley Way Crabtree Office Village Egham TW20 8RY para Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR em 20/12/2019

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de a G Secretarial Limited como secretário em 18/12/2019

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de David Gardner como diretor em 18/12/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Glen Norman Williams como diretor em 18/12/2019

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Liam Matthew Duncalf como diretor em 18/12/2019

    2 páginasAP01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 28/02/2020 para 31/03/2020

    1 páginasAA01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 16/12/2019

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Quem são os diretores de WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DUNCALF, Liam Matthew
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Diretor
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    EnglandBritishFinance Director257070630001
    GARDNER, David
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Diretor
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    EnglandBritishCeo277805290001
    CHRISTOFOROU, Chris
    11 The Fieldings
    SM7 2HF Banstead
    Surrey
    Secretário
    11 The Fieldings
    SM7 2HF Banstead
    Surrey
    BritishDirector63740050003
    CUNLIFFE, Neil Stephen
    11 Halfpenny Close
    Barming
    ME16 9AJ Maidstone
    Kent
    Secretário
    11 Halfpenny Close
    Barming
    ME16 9AJ Maidstone
    Kent
    BritishAccountant57673290002
    DUNCAN, Ian
    76 Forest Dene
    TN6 2EX Jarvis Brook
    East Sussex
    Secretário
    76 Forest Dene
    TN6 2EX Jarvis Brook
    East Sussex
    BritishFinancial Director96393280001
    O'SULLIVAN, Matthew
    7 Queens Crescent
    TW10 6HG Richmond
    Surrey
    Secretário
    7 Queens Crescent
    TW10 6HG Richmond
    Surrey
    BritishAccountant46307060002
    PRATT, Brian Leonard
    153 Edwin Road
    Rainham
    ME8 0AQ Gillingham
    Kent
    Secretário
    153 Edwin Road
    Rainham
    ME8 0AQ Gillingham
    Kent
    British2130000002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Secretário
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    90084920001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretário
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BOUVERIE REGISTRARS LIMITED
    61-67 Old Street
    EC1V 9HX London
    Secretário
    61-67 Old Street
    EC1V 9HX London
    104164110001
    ANDERSON, Nigel Barry
    Vikings 57 Furze Road
    BN13 3BH Worthing
    West Sussex
    Diretor
    Vikings 57 Furze Road
    BN13 3BH Worthing
    West Sussex
    BritishManaging Director16225300001
    BAILEY, Stephen George
    52 Knaves Acre
    Headcorn
    TN27 9TJ Ashford
    Kent
    Diretor
    52 Knaves Acre
    Headcorn
    TN27 9TJ Ashford
    Kent
    BritishElectronic Engineer6842160001
    BOWLES, James David
    Eversley Way
    TW20 8RY Crabtree Office Village
    Ashmead House
    Egham
    Diretor
    Eversley Way
    TW20 8RY Crabtree Office Village
    Ashmead House
    Egham
    United KingdomBritishAccountant125381890004
    BURRELL, Roger Frank
    9 Old House Court
    Church Lane
    SL3 6LN Wexham
    Slough Berks
    Diretor
    9 Old House Court
    Church Lane
    SL3 6LN Wexham
    Slough Berks
    BritishDirector52598200001
    CATERRALL, Susan Thomas
    125 Fiddlers Lane
    Irlam
    M44 6QB Manchester
    Lancashire
    Diretor
    125 Fiddlers Lane
    Irlam
    M44 6QB Manchester
    Lancashire
    BritishNorthern Operations 32316720001
    CHRISTOFOROU, Chris
    11 The Fieldings
    SM7 2HF Banstead
    Surrey
    Diretor
    11 The Fieldings
    SM7 2HF Banstead
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant63740050003
    COTTON, Daniele George
    11 Gaston Bridge Road
    TW17 8HH Shepperton
    Surrey
    Diretor
    11 Gaston Bridge Road
    TW17 8HH Shepperton
    Surrey
    EnglandBritishDirector92912590001
    CUNLIFFE, Neil Stephen
    11 Halfpenny Close
    Barming
    ME16 9AJ Maidstone
    Kent
    Diretor
    11 Halfpenny Close
    Barming
    ME16 9AJ Maidstone
    Kent
    BritishAccountant57673290002
    GARDNER, David
    Eversley Way
    TW20 8RY Crabtree Office Village
    Ashmead House
    Egham
    Diretor
    Eversley Way
    TW20 8RY Crabtree Office Village
    Ashmead House
    Egham
    United KingdomBritishChief Operations Officer258372770001
    JOHNSON, Duncan Edward
    Baigens
    Winchester Road
    GU34 1SL Chawton
    Hampshire
    Diretor
    Baigens
    Winchester Road
    GU34 1SL Chawton
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director266556880001
    MACLEAN, Peter
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    Diretor
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector157773140001
    MCBRIDE, Paul John
    Three Wells
    Main Street
    CV35 7NJ Haseley Knob
    Warwick
    Diretor
    Three Wells
    Main Street
    CV35 7NJ Haseley Knob
    Warwick
    BritishCommunications Consultant54180670001
    MORRISON, Michael John
    Eversley Way
    TW20 8RY Crabtree Office Village
    Ashmead House
    Egham
    Diretor
    Eversley Way
    TW20 8RY Crabtree Office Village
    Ashmead House
    Egham
    United KingdomBritishDirector198336910001
    O'SULLIVAN, Matthew
    7 Queens Crescent
    TW10 6HG Richmond
    Surrey
    Diretor
    7 Queens Crescent
    TW10 6HG Richmond
    Surrey
    EnglandBritishAccountant46307060002
    PHILLIPS, David Paul
    22 The Mount
    KT22 9EE Fetcham
    Surrey
    Diretor
    22 The Mount
    KT22 9EE Fetcham
    Surrey
    BritishDirector42422020002
    PRATT, Brian Leonard
    153 Edwin Road
    Rainham
    ME8 0AQ Gillingham
    Kent
    Diretor
    153 Edwin Road
    Rainham
    ME8 0AQ Gillingham
    Kent
    BritishAccountant2130000002
    WEBB, Andrew James
    12 Granary Close
    Weavering
    ME14 5UB Maidstone
    Kent
    Diretor
    12 Granary Close
    Weavering
    ME14 5UB Maidstone
    Kent
    BritishDirector30065010001
    WEBB, Andrew James
    12 Granary Close
    Weavering
    ME14 5UB Maidstone
    Kent
    Diretor
    12 Granary Close
    Weavering
    ME14 5UB Maidstone
    Kent
    BritishManager30065010001
    WEBB, James Edward Terence
    Belmont Sutton Road
    Langley
    ME17 3NF Maidstone
    Kent
    Diretor
    Belmont Sutton Road
    Langley
    ME17 3NF Maidstone
    Kent
    United KingdomOtherChartered Structural Engineer2129990001
    WHITTELL, Peter Denis
    The Court House
    Chart Road
    ME17 3AW Sutton Valence
    Kent
    Diretor
    The Court House
    Chart Road
    ME17 3AW Sutton Valence
    Kent
    EnglandBritishDirector2963760003
    WHITTELL, Peter Dennis
    The Oast 95 Spot Lane
    Bearsted
    ME15 8PF Maidstone
    Kent
    Diretor
    The Oast 95 Spot Lane
    Bearsted
    ME15 8PF Maidstone
    Kent
    BritishElectronic Engineer2963760002
    WILLIAMS, Glen Norman
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Diretor
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    EnglandBritishDirector193675720001

    Quem são as pessoas com controle significativo de WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    06/04/2016
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Liability Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro3356968
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    WEBB ELECTRONICS & COMMUNICATIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 08/07/2016
    Entregue em 14/07/2016
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/07/2016Registro de uma garantia (MR01)
    • 28/10/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 08/07/2016
    Entregue em 11/07/2016
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Octopus Apollo Vct PLC
    Transações
    • 11/07/2016Registro de uma garantia (MR01)
    • 07/01/2020Satisfação de uma garantia (MR04)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 15/03/2005
    Entregue em 18/03/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 18/03/2005Registro de uma garantia (395)
    • 05/09/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 18/12/2003
    Entregue em 02/01/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 02/01/2004Registro de uma garantia (395)
    • 08/06/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 19/09/2003
    Entregue em 24/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/09/2003Registro de uma garantia (395)
    • 05/09/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 19/09/2003
    Entregue em 24/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/09/2003Registro de uma garantia (395)
    • 05/09/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 09/10/2000
    Entregue em 11/10/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Pessoas com direito
    • Euro Sales Finance PLC
    Transações
    • 11/10/2000Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 04/07/1997
    Entregue em 08/07/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/07/1997Registro de uma garantia (395)
    • 03/10/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 23/11/1993
    Entregue em 08/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 03/10/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 28/11/1991
    Entregue em 10/12/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 10/12/1991Registro de uma garantia (395)
    • 25/06/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Letter of charge
    Criado em 05/07/1989
    Entregue em 14/07/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All moneys standing to the credit of any account.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/07/1989Registro de uma garantia
    • 16/02/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0