JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED

JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaJAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01689995
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    JAGUAR COMMUNICATIONS PLC24/04/200824/04/2008
    EASYBROOK LIMITED07/01/198307/01/1983

    Quais são as últimas contas de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2017

    Quais são as últimas submissões para JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 30/11/2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Reduce share prem a/c 14/11/2017
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 31/03/2017

    16 páginasAA

    legacy

    224 páginasPARENT_ACC

    Declaração de confirmação apresentada em 25/10/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Término da nomeação de Vodafone Corporate Secretaries Limited como diretor em 31/05/2017

    1 páginasTM01

    Nomeação de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited como diretor em 31/05/2017

    2 páginasAP02

    Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN

    1 páginasAD04

    Término da nomeação de Vodafone Corporate Secretaries Limited como secretário em 31/05/2017

    1 páginasTM02

    Nomeação de Matthew Egan como diretor em 31/05/2017

    2 páginasAP01

    Nomeação de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited como secretário em 31/05/2017

    2 páginasAP04

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2016

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 13/10/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 11/05/2016

    • Capital: GBP 1,000
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Reduce share prem a/c 22/04/2016
    RES13

    Término da nomeação de Steven David Showell como diretor em 04/01/2016

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2303594
    232519770001
    EGAN, Matthew
    Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    35
    United Kingdom
    Diretor
    Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    35
    United Kingdom
    United KingdomBritish232755050001
    SMITH, Neil Colin
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Diretor
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish204358750001
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2303594
    232519770001
    BOLTON, Jonathan Mark
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    Secretário
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    British15931960005
    BOLTON, Jonathan Mark
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    Secretário
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    British15931960005
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Secretário
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    DAVIDSON, Lorraine
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    Secretário
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    British103543780001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Secretário
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secretário
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secretário
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    MOORE, Paul Anthony
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    152569550001
    RUSSELL, Gary Peter
    9 Pirton Close
    AL4 9YJ St Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    9 Pirton Close
    AL4 9YJ St Albans
    Hertfordshire
    British44428050001
    STOCKMAN, Richard Graham
    3 Albert Street
    AL1 1RT St Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    3 Albert Street
    AL1 1RT St Albans
    Hertfordshire
    British7490950001
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2357692
    75473330004
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Diretor
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    CLARKE, Gregory Allison
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    Diretor
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    British143319900001
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Diretor
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    COLEBROOK, Richard John
    30 Prospect Lane
    AL5 2PL Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    30 Prospect Lane
    AL5 2PL Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandUnited Kingdom2606430002
    COOPER, Nicholas Ian
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    Diretor
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    UkBritish122128470002
    DAVIS, Philip Stephen James
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135958960001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Diretor
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    FITZ, Joseph Daniel
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    Diretor
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    British70579740002
    GARARD, Andrew Sheldon
    Waldegrave House
    293 Waldegrave Road
    TW1 4SU Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    Waldegrave House
    293 Waldegrave Road
    TW1 4SU Twickenham
    Middlesex
    British69630190003
    GIBSON, Ian Jeffrey
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    Diretor
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish78528840005
    HEWITT, Martin Robert
    46 Milliners Court
    Lattimore Road
    AL1 3XT St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    46 Milliners Court
    Lattimore Road
    AL1 3XT St. Albans
    Hertfordshire
    British2606450004
    HOGGARTH, Royston
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    Diretor
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    EnglandBritish67927330001
    JAMES, Kevin
    6 Maxwell Close
    WD3 2BR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Diretor
    6 Maxwell Close
    WD3 2BR Rickmansworth
    Hertfordshire
    British55357740001
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Diretor
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    KINCH, Alan Royston
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomEnglish163334420001
    LERWILL, Robert Earl
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    Diretor
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    British51239200003
    MOLYNEUX, Mary Bridget
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Diretor
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Australian63615470001
    NORTON, Graham Howard
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    Diretor
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    British91014890001
    PHILLIP, Kerry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Diretor
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish185033430001
    QUINN, Peter Herbert
    Dog House
    HP5 1UQ Latimer
    Buckinghamshire
    Diretor
    Dog House
    HP5 1UQ Latimer
    Buckinghamshire
    British663570001

    Quem são as pessoas com controle significativo de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06/04/2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaUnlimited With Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro1541957
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rent deposit deed
    Criado em 29/04/2002
    Entregue em 07/05/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the tenant (as defined therein) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The interest in the account a seperate designated interest bearing deposit account where the deposited sum of £211,712 is placed together with all monies including interest and other accruals standing to the credit of the said account.
    Pessoas com direito
    • Euroinvest Estates Limited
    Transações
    • 07/05/2002Registro de uma garantia (395)
    • 02/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 01/03/1996
    Entregue em 11/03/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all the deposits together with all interest in account no 60082953. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 11/03/1996Registro de uma garantia (395)
    • 06/08/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Credit agreement
    Criado em 08/02/1993
    Entregue em 11/02/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £19,839.47
    Breve descrição
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 11/02/1993Registro de uma garantia (395)
    • 29/06/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Credit agreement
    Criado em 13/02/1991
    Entregue em 02/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £19290.36
    Breve descrição
    All the company's right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance particulars of which are set out on form M395 reference M338 c.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 02/02/1991Registro de uma garantia
    • 29/06/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattles mortgage
    Criado em 04/06/1990
    Entregue em 06/06/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    One used jaguar 'e' type coupe. Registeration no jag 164L, chassis no. 1551428BW.
    Pessoas com direito
    • Forward Trust Limited
    Transações
    • 06/06/1990Registro de uma garantia
    • 10/09/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 17/01/1986
    Entregue em 29/01/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (See doc M17). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 29/01/1986Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 27/06/1985
    Entregue em 04/07/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges ovr the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts a legal mortgage over l/h property k/a the limies, 32/34 upper marlborough road, st albans, hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/07/1985Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0