HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED

HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01731768
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    • Instalações de fitness (93130) / Atividades artísticas, recreativas e de espetáculos

    Onde fica HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SPENCER MOTOR GROUP LIMITED12/01/199012/01/1990
    SPENCER OF BRIGG LIMITED14/06/198314/06/1983

    Quais são as últimas contas de HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Qual é o status da última declaração anual para HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    4 páginas4.71

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de * Active House 21 North Fourth Street Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1HL* em 09/10/2013

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 19/09/2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração anual preparada até 29/08/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada

    1 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado

    1 páginasAD02

    Nomeação de Mr Paul Antony Woolf como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Norman Field como diretor

    1 páginasTM01

    Contas preparadas até 31/12/2011

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 29/08/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    Declaração anual preparada até 31/08/2011 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Nomeação de Matthew Graham Merrick como diretor

    4 páginasAP01
    Anotações
    DataAnotação
    29/09/2011This document is a duplicate of the AP01 registered on 12/09/2011

    Nomeação de James Archibald como secretário

    4 páginasAP03
    Anotações
    DataAnotação
    29/09/2011This document is a duplicate of the AP03 registered on 12/09/2011

    Nomeação de James Archibald como secretário

    3 páginasAP03

    Nomeação de Matthew Graham Merrick como diretor

    3 páginasAP01

    Contas preparadas até 31/12/2010

    15 páginasAA

    Quem são os diretores de HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ARCHIBALD, James
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Secretário
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    British162965050001
    BUCKNALL, Matthew William
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Diretor
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishCompany Director162066820001
    MERRICK, Matthew Graham
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Diretor
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishUk Finance Director162110530001
    WOOLF, Paul Antony
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Diretor
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishDirector160679880001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Secretário
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Secretário
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    BritishDirector58345490001
    LONG, Jean
    19 Cliff Closes Road
    DN15 7HT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Secretário
    19 Cliff Closes Road
    DN15 7HT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    British11609680001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Secretário
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Secretário
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Secretário
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    BritishChartered Secretary123616460002
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director Esporta Group58961410002
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Diretor
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishExecutive Director, Esporta Gr96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Diretor
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector146698270001
    DHODY, Jog
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Diretor
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer, Esporta Gr104269910002
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Diretor
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    EnglandBritishDirector58345490001
    FIELD, Norman Mark
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Diretor
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth AfricanManaging Director161860310001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Diretor
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive Esporta Group69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Diretor
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    BritishDivisional Director Esporta Gr100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Diretor
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector135618280002
    MCCOLLUM, Kevin Boyd
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector121972580001
    MCGUIGAN, Marc Edward
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    Diretor
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    EnglandBritishOperations Director Esporta Gr93677590002
    MOORE, Trevor Philip
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishManaging Director, Operations113047410001
    SEGAL, Richard Lawrence
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Diretor
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector138744060001
    SPENCER, Elizabeth Laura
    Humberston Country Club
    Humberston Avenue Humberston
    DN36 4SJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    Diretor
    Humberston Country Club
    Humberston Avenue Humberston
    DN36 4SJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishHousewife19057710002
    SPENCER, Jonathan Graham
    Humberston Country Club
    Humberston Avenue Humberston
    DN36 4SJ Grimsby
    North Eastlincolnshire
    Diretor
    Humberston Country Club
    Humberston Avenue Humberston
    DN36 4SJ Grimsby
    North Eastlincolnshire
    BritishSales Manager20593340002
    TIMMS, Glenn Gordon
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishChief Executive, Esporta Group54133140004
    WEATHERLEY, Kenneth Frank
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    Diretor
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    BritishDirector50477690001

    HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed and floating security document
    Criado em 18/06/2009
    Entregue em 26/06/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transações
    • 26/06/2009Registro de uma garantia (395)
    • 03/10/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Group debenture
    Criado em 08/02/2006
    Entregue em 18/02/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transações
    • 18/02/2006Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 27/01/2004
    Entregue em 07/02/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transações
    • 07/02/2004Registro de uma garantia (395)
    • 03/11/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 27/01/2004
    Entregue em 03/02/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 03/02/2004Registro de uma garantia (395)
    • 07/03/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental charge
    Criado em 28/11/2003
    Entregue em 12/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    L/H property being humberston country club, humberston avenue, humberston, grimsby all property, present and future book debts, all equipment, present and future licences, insurances, indebtedness owed by esporta h & f fropco (1B) limited to the company.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 12/12/2003Registro de uma garantia (395)
    • 03/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 05/09/2002
    Entregue em 09/09/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n HS280597 land and buildings lying to the north of humberston avenue, humberston. T/n HS226008 humberston country club, humberston avenue, grimsby and t/n HS226007 humberston country club, humberston avenue, grimsby. By way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Electra Partners Europe Limited (As Noteholders' Agent and Noteholders' Security Agent for Thenote Finance Parties)
    Transações
    • 09/09/2002Registro de uma garantia (395)
    • 14/01/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 15/10/1999
    Entregue em 23/10/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the mezzanine financing documents (including the guarantee dated 15TH october 1999 and the debenture)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Electra Managers Limited(The "Mezzanine Security Agent")
    Transações
    • 23/10/1999Registro de uma garantia (395)
    • 19/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 15/10/1999
    Entregue em 28/10/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and security trustee for the finance parties (as therein defined)) on any account whatsoever, under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and debenture)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Coutts & Company
    Transações
    • 28/10/1999Registro de uma garantia (395)
    • 03/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 10/03/1999
    Entregue em 24/03/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners (The Lender)
    Transações
    • 24/03/1999Registro de uma garantia (395)
    • 03/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 10/03/1999
    Entregue em 23/03/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land and buildings on the north side of humberston avenue grimsby t/no;-HS226007 and HS226008 and land at the rear of 191 humberston avenue t/no;-HS228117 (part). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Coutts & Company
    Transações
    • 23/03/1999Registro de uma garantia (395)
    • 03/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 26/04/1994
    Entregue em 06/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on the north side of humberston avenue grimsby humberside t/n HS226OO7.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 09/03/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 17/12/1990
    Entregue em 04/01/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land and buildings in winterton road scunthorpe humberside.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 04/01/1991Registro de uma garantia
    • 17/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 20/02/1989
    Entregue em 27/02/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land and buildings to the north of brumby wood lane scunthorpe humberside.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 27/02/1989Registro de uma garantia
    • 17/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 20/02/1989
    Entregue em 27/02/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Garage premises situate and k/a 5 brumby wood lane, scunthorpe humberside.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 27/02/1989Registro de uma garantia
    • 17/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 07/09/1987
    Entregue em 08/09/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a consignment agreement d/d 7/9/87
    Breve descrição
    All the chargor's interest in any vehicle delivered to it under the terms of the said consignment agreement.
    Pessoas com direito
    • Psa Wholesale Limited
    Transações
    • 08/09/1987Registro de uma garantia
    • 17/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 30/06/1987
    Entregue em 13/07/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    106 scotter road scunthorpe county of humberside title no: ll 4401.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/07/1987Registro de uma garantia
    • 17/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed
    Criado em 06/05/1987
    Entregue em 08/05/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All new and unused passenger cars and light commercial vehicles (please see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Psa Wholesale Limited
    Transações
    • 08/05/1987Registro de uma garantia
    • 17/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 18/05/1984
    Entregue em 24/05/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/05/1984Registro de uma garantia
    • 18/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    24/09/2013Início da liquidação
    20/11/2014Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Profissional
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profissional
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0