ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01817913 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
- Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação
Onde fica ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Royal Pavilion Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Hampshire United Kingdom |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
TOREX RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED | 12/06/2002 | 12/06/2002 |
AMERSHAM MEDICAL SYSTEMS LIMITED | 21/05/1984 | 21/05/1984 |
Quais são as últimas contas de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/03/2012 |
Qual é o status da última declaração anual para ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Declaração anual |
|
---|
Quais são as últimas submissões para ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/03/2013 para 30/09/2013 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Andrew Thomson como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 30/07/2013 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado do capital em 24/06/2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Nomeação de David William Hart Gray como secretário | 3 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Gareth Wilson como secretário | 2 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2012 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 34 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaração anual preparada até 30/07/2012 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado | 1 páginas | AD04 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Adrian Stevens como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/06/2011 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
Exercício contabilístico atual encurtado de 30/06/2012 para 31/03/2012 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Adrian Charles Stevens em 12/09/2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Andrew James Edward Thomson em 12/09/2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Mr Gareth Antony Wilson em 12/09/2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Andrea Fiumicelli em 12/09/2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* em 18/08/2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* em 05/08/2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Quem são os diretores de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAY, David William Hart | Secretário | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | British | 177357740001 | ||||||
FIUMICELLI, Andrea | Diretor | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Italy | Italian | Company Director | 135619020001 | ||||
CRABTREE, Nicholas Patrick | Secretário | Sherwood 11 Green Lane Chesham Bois HP6 5LN Amersham Buckinghamshire | British | Computer Consultant | 17678130002 | |||||
EDELMAN, Howard Todd | Secretário | Elizabeth Bay Road 2011 Elizabeth Bay 84/108 Nsw Australia | Australian | Company Secretary | 126124430005 | |||||
HILL, Teifion Mark | Secretário | 59 Hill Top Avenue Cheadle Hulme SK8 7HZ Stockport Cheshire | British | 100105520001 | ||||||
HORN, Nigel David | Secretário | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||
MEIRE, Hylton Bruce | Secretário | 30 Durham Avenue BR2 0QB Bromley Kent | British | 5361780001 | ||||||
WILSON, Gareth Antony | Secretário | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | 162045740001 | |||||||
CLARKE, Robert Samuel | Diretor | 4 Lyne Way Warners End HP1 3PL Hemel Hempstead Hertfordshire | British | Sales & Marketing | 44712370001 | |||||
COHEN, Gary Michael | Diretor | 178 Hopetoun Avenue, Watsons Bay Nsw 2030 Australia | Australia | Australian | Company Director | 125992970001 | ||||
COWLES, Neil | Diretor | 37 Oldborough Drive CV35 9HQ Loxley Warwickshire | British | Director | 79753520001 | |||||
CRABTREE, Nicholas Patrick | Diretor | Sherwood 11 Green Lane Chesham Bois HP6 5LN Amersham Buckinghamshire | England | British | Finance Director | 17678130002 | ||||
DAY, Robert William | Diretor | Weathertop Blackmires Lane, Silverstone NN12 8UZ Towcester Northamptonshire | British | Director | 66520250001 | |||||
EALES, Gillian Margaret | Diretor | 20 Woodside Road Bickley BR1 2ES Bromley Kent | British | Business Administrator | 16296060001 | |||||
FRANKS, Nigel | Diretor | 8 Herston Close HP21 9UR Aylesbury Buckinghamshire | British | Operations Director | 39004110002 | |||||
GARRINGTON, Stephen John | Diretor | 15 Chesterton Close Hunt End B97 5XS Redditch Worcestershire | British | Director | 45513680001 | |||||
GRAHAM, Stephen Paul | Diretor | Brackenridge Mereside Road WA16 6QR Mere Cheshire | United Kingdom | British | Director | 97528710001 | ||||
HENRY, William Patrick | Diretor | 9 Grafton Road GL50 2ET Cheltenham Gloucestershire | England | American | Company Director | 119049370001 | ||||
JAMES, Gavin Keith, Mr. | Diretor | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | Finance Director | 44173560008 | ||||
KUMAR, Ravi | Diretor | 14 Parkham Close Daisy Hill Westhaughton BL5 2GT Bolton Lancashire | British | Company Director | 101025710001 | |||||
MACKAY, James Gordon | Diretor | Daventry Road OX16 3JT Banbury Isoft Group Plc Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 178097680001 | ||||
MACKAY, James Gordon | Diretor | Pogles Wood Widmoor HP10 0JG Wooburn Green Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 178097680001 | ||||
MEIRE, Hylton Bruce | Diretor | 30 Durham Avenue BR2 0QB Bromley Kent | British | Doctor | 5361780001 | |||||
MORRIS, Eamonn | Diretor | 25 Coppinger Wood IRISH Blackrock Co Dublin Ireland | Ireland | Irish | Director | 65876940001 | ||||
PEARMAN, Mark Chalice | Diretor | The Old Rectory Honiley CV8 1NP Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 57516220003 | ||||
RAWCLIFFE, Richard William | Diretor | 113 Towngate Eccleston PR7 5QS Chorley Lancashire England | British | Director | 86831530001 | |||||
RICHARDS, Paul | Diretor | The Barn Green Lane South Newington OX15 4JH Banbury | United Kingdom | British | Company Director | 126777780001 | ||||
RICHARDS, Paul | Diretor | The New Barn Grange Farm South Newington OX15 4JW Banbury Oxfordshire | British | Director | 82595090001 | |||||
STEVENS, Adrian Charles | Diretor | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Company Director | 76964750002 | ||||
THOMSON, Andrew James Edward | Diretor | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 147270780001 | ||||
WATSON, Robert John | Diretor | Holly House Felden Lane Felden HP3 0BF Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | Managing Director | 16296070002 | ||||
WHELAN, John | Diretor | 26 Lynton Park Road SK8 6JA Cheadle Hulme Cheshire | Uk | British | Director | 105872500001 | ||||
WHISTON, Timothy Andrew | Diretor | Boothshill Farm Booths Lane WA13 0PF Lymm Cheshire | England | British | Director | 69575560002 | ||||
WOODBRIDGE, Mark Gavin | Diretor | The Bungalow Marton CV23 9RS Rugby Warwickshire | British | Finance Director | 74738270002 |
ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Criado em 30/12/2009 Entregue em 13/01/2010 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A deed of accession | Criado em 27/11/2007 Entregue em 13/12/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Supplemental guarantee and debenture | Criado em 24/08/2006 Entregue em 31/08/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the principal borrower, each chargor and each other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição L/H suite 304 spirella building bridge road letchworth garden city herts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Criado em 24/08/2006 Entregue em 31/08/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003 | Criado em 13/04/2006 Entregue em 28/04/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH april 1998 | Criado em 08/08/2002 Entregue em 16/08/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account to the company with the bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 04/04/2001 Entregue em 07/04/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0