SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED

SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01832838
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Amen Corner
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Berkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    COMPUTERGROUP LIMITED17/10/198417/10/1984
    CABLEGRACE LIMITED16/07/198416/07/1984

    Quais são as últimas contas de SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/10/2014

    Qual é o status da última declaração anual para SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginas4.71

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 14/07/2015

    LRESSP

    Término da nomeação de Steven David Burr como diretor em 30/06/2015

    1 páginasTM01

    legacy

    4 páginasSH20

    Estado do capital em 27/05/2015

    • Capital: GBP 1,000
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Share premium account cancelled 20/05/2015
    RES13

    Contas anuais preparadas até 31/10/2014

    12 páginasAA

    Declaração anual preparada até 06/07/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital09/07/2014

    Estado do capital em 09/07/2014

    • Capital: GBP 84,620,041
    SH01

    Nomeação de Ms Tara Dawn Trower como secretário

    2 páginasAP03

    Nomeação de Ms Tara Dawn Trower como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Roberto Putland como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Roberto Putland como secretário

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 31/10/2013

    12 páginasAA

    Declaração anual preparada até 06/07/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 17/04/2013

    • Capital: GBP 84,620,040
    3 páginasSH01

    Contas anuais preparadas até 31/10/2012

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 06/07/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Nomeação de Mr Roberto Adriano Putland como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Jonathan Savage como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/10/2011

    15 páginasAA

    Término da nomeação de Thomas Perkins como secretário

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TROWER, Tara Dawn
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    187391680001
    TROWER, Tara Dawn
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish134963980001
    HILL, Derek
    Woodside Cottage 192 Church Lane
    Marple
    SK6 7LA Stockport
    Cheshire
    Secretário
    Woodside Cottage 192 Church Lane
    Marple
    SK6 7LA Stockport
    Cheshire
    British43301210001
    LA CALAMITA, John Michael
    113 Lord Seaton Road
    M2P 1K8 North York
    Ontario
    Canada
    Secretário
    113 Lord Seaton Road
    M2P 1K8 North York
    Ontario
    Canada
    British51659910001
    ORMROD, James
    10 Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berks
    Secretário
    10 Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berks
    Other130250210001
    PERKINS, Thomas Clark
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    147686750001
    PHILLIPS, Lawrence Stephen
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    Secretário
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    British11800250003
    PRICHARD, Teresa Joan
    4 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    Secretário
    4 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    British42862810001
    PUTLAND, Roberto
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    162796870001
    ROY, David Maitland
    14 Lovell Road
    Oakley
    MK43 7RZ Bedford
    Secretário
    14 Lovell Road
    Oakley
    MK43 7RZ Bedford
    British46026850002
    EDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    Secretário
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    69779900001
    BURR, Steven David
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish138588120001
    CRONIN, Thomas Alfred
    20 Ilchester Mansions
    Abingdon Road
    W8 6AE London
    Diretor
    20 Ilchester Mansions
    Abingdon Road
    W8 6AE London
    Canadian56798460001
    DAMP, Paul David
    9 Bowring Walk
    M3H 525 North York
    Ontario
    Canada
    Diretor
    9 Bowring Walk
    M3H 525 North York
    Ontario
    Canada
    CanadaCanadian230526150001
    GAFFNEY, Thomas Anthony
    19 Pensford Avenue
    TW9 4HR Richmond
    Surrey
    Diretor
    19 Pensford Avenue
    TW9 4HR Richmond
    Surrey
    Canadian/Irish54394580001
    GILL, Dara Singh
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Great BritainBritish149165080001
    GILL, Stephen
    Woodlee Hall
    Callow Hill
    GU25 4LL Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    Woodlee Hall
    Callow Hill
    GU25 4LL Virginia Water
    Surrey
    British56193720001
    GLAZEBROOK, Colin
    High Ridge Chadwell Rise
    SG12 9LA Ware
    Hertfordshire
    Diretor
    High Ridge Chadwell Rise
    SG12 9LA Ware
    Hertfordshire
    British16711410001
    GRANT, Andrew Michael
    22 Witches Lane
    TN13 2AX Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    22 Witches Lane
    TN13 2AX Sevenoaks
    Kent
    British59643580001
    HAWES, Kenneth Robert
    Beech House 361 Hale Road
    Halebarns
    WA15 8TB Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    Beech House 361 Hale Road
    Halebarns
    WA15 8TB Altrincham
    Cheshire
    British16711440001
    HILL, Derek
    Woodside Cottage 192 Church Lane
    Marple
    SK6 7LA Stockport
    Cheshire
    Diretor
    Woodside Cottage 192 Church Lane
    Marple
    SK6 7LA Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish43301210001
    LAMBTON, Mark Norman
    Station Road
    GU10 5JZ Bentley
    Lavender Cottage
    Surrey
    Diretor
    Station Road
    GU10 5JZ Bentley
    Lavender Cottage
    Surrey
    United KingdomBritish162510100001
    LAY, Graham Richard David
    33 Hollybush Lane
    Datchworth
    SG3 6RE Knebworth
    Herts
    Diretor
    33 Hollybush Lane
    Datchworth
    SG3 6RE Knebworth
    Herts
    EnglandBritish33300160001
    LEWTHWAITE, Mark
    Tokers Green Lane
    RG4 9AY Kidmore End
    Highfields
    South Oxfordshire
    Diretor
    Tokers Green Lane
    RG4 9AY Kidmore End
    Highfields
    South Oxfordshire
    EnglandBritish134517020001
    LINTON, William Warwick
    18 Edgehill Road
    Etobicoke
    Ontario
    M9a 4n3
    Canada
    Diretor
    18 Edgehill Road
    Etobicoke
    Ontario
    M9a 4n3
    Canada
    CanadaCanadian115579350001
    LUKES, Edward Frank
    16
    St Mary Abbots Terrace
    W14 8NX London
    Diretor
    16
    St Mary Abbots Terrace
    W14 8NX London
    American44180480001
    MACDONALD, Iain Archibald
    Blackford House Macclesfield Road
    SK9 7BH Alderley Edge
    Cheshire
    Diretor
    Blackford House Macclesfield Road
    SK9 7BH Alderley Edge
    Cheshire
    British3614100001
    MADDEN, James
    724 Harbor Island Drive
    Newport Beach 92660
    California
    Usa
    Diretor
    724 Harbor Island Drive
    Newport Beach 92660
    California
    Usa
    American65642080001
    MCGOUN, Michael Frederick
    The Old Rectory Church Lane
    Mobberley
    WA16 7RD Knutsford
    Cheshire
    Diretor
    The Old Rectory Church Lane
    Mobberley
    WA16 7RD Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritish8300340001
    MCLAREN, Donald Ian
    17
    Catherwood Court
    Kanata
    Ontario K2k 2ki
    Canada
    Diretor
    17
    Catherwood Court
    Kanata
    Ontario K2k 2ki
    Canada
    Canadian62159130001
    MOSES, Dhyanchand
    3716 Nash Lane
    Plano
    Texas 75025
    Usa
    Diretor
    3716 Nash Lane
    Plano
    Texas 75025
    Usa
    American64548230001
    PAYNE, Stuart Michael
    2 Highgrove Close
    BR7 5SA Chislehurst
    Kent
    Diretor
    2 Highgrove Close
    BR7 5SA Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish17465450001
    PUTLAND, Roberto Adriano
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish162794370001
    SANDIFORD, Peter
    Lakeview Terrace
    Ottawa
    2
    Ontario, K1s3h4
    Canada
    Diretor
    Lakeview Terrace
    Ottawa
    2
    Ontario, K1s3h4
    Canada
    CanadaCanadian129544830001
    SAVAGE, Jonathan
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealander152970170001

    SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage debenture
    Criado em 30/11/1993
    Entregue em 01/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit b boulevard ind: park beacon road beeston broxton nottingham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Bank of Canada Europe Limited
    Transações
    • 01/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 05/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 18/06/1992
    Entregue em 26/06/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land and buildings k/as finney green cottage 134 manchester road wilmslow macclesfield cheshire t/no ch 341638 fixed charge over the benefit of all covenants and rights,plant machinery, fixtures and fittings.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 26/06/1992Registro de uma garantia (395)
    • 01/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 26/07/1991
    Entregue em 15/08/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of legal mortgage f/h property k/a unit b, bolevard industrial park, beeston, nottingham. Fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 15/08/1991Registro de uma garantia
    • 27/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Group guarantee debenture
    Criado em 29/11/1984
    Entregue em 19/12/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or cablegrace limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transações
    • 19/12/1984Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 31/10/1984
    Entregue em 12/11/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transações
    • 12/11/1984Registro de uma garantia
    • 27/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    14/07/2015Início da liquidação
    07/09/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0