HARBOUR PROPERTIES LIMITED

HARBOUR PROPERTIES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHARBOUR PROPERTIES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01833719
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Cornwall House Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    West Midlands
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    FLAMELINK LIMITED18/07/198418/07/1984

    Quais são as últimas contas de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2022

    Quais são as últimas submissões para HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Notificação de Dollplace Limited como pessoa com controlo significativo em 13/06/2023

    2 páginasPSC02

    Cessação de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited como pessoa com controlo significativo em 13/06/2023

    1 páginasPSC07

    Memorando e estatutos

    26 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Conflict of interest 07/06/2023
    RES13
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 07/06/2023

    • Capital: GBP 3
    3 páginasSH01

    Estado do capital em 08/06/2023

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 23/04/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Peter Christopher Ralston em 20/09/2021

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Robert Paul Reed em 20/09/2021

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr James Martin Cornell em 20/09/2021

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2022

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/04/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2021

    8 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Ancosec Limited em 20/09/2021

    1 páginasCH04

    Alteração dos detalhes de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited como pessoa com controlo significativo em 20/09/2021

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de Nelson House Central Boulevard, Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8BG para Cornwall House Blythe Gate Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8AF em 20/09/2021

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2020

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/04/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 23/04/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Quem são os diretores de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ANCOSEC LIMITED
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    Secretário
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro3611403
    111724450001
    CORNELL, James Martin
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Diretor
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    EnglandBritish148803950001
    RALSTON, Peter Christopher
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Diretor
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    United KingdomBritish110237280002
    REED, Robert Paul
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Diretor
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    United KingdomBritish148032280006
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Secretário
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    British49654480002
    EVANS, David Malcolm
    Springdale
    Shobley
    BH24 3HT Ringwood
    Hampshire
    Secretário
    Springdale
    Shobley
    BH24 3HT Ringwood
    Hampshire
    British27482710001
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretário
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    British10297860001
    LYNE, Sarah Jane
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    Secretário
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    British49635520003
    READ, Jonathan David
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    Secretário
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    British77460610002
    SWAIN, John Kenneth
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    Secretário
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    British33262350001
    AUSTEN, Jonathan Martin
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    Diretor
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish51921200001
    CHATER, Beth Salena
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish60464290003
    DEIGMAN, Patrick
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Diretor
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish37099910001
    DIGBY, Michael Essex
    Hillier Parker May & Rowden
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    Diretor
    Hillier Parker May & Rowden
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    British12476600001
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Diretor
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    EnglandBritish49654480002
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Diretor
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10297860001
    FLETCHER, David Jonathan Richard
    Stratton House
    Stratton Street
    W1X 5FE London
    Diretor
    Stratton House
    Stratton Street
    W1X 5FE London
    United KingdomBritish10597290001
    JOHNSTON, Andrew James
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    Diretor
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish131001620001
    LYALL, Stephen Charles
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    Diretor
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    British44917590001
    MOHANLAL, Satish
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    Diretor
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    British51579180001
    MURRAY, Nicholas Stuart Granville
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Diretor
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish29664370001
    O'SULLIVAN, Michael James
    Greenlawns
    21 Broad Highway
    KT11 2RR Cobham
    Surrey
    Diretor
    Greenlawns
    21 Broad Highway
    KT11 2RR Cobham
    Surrey
    Australian109785090002
    PILGRIM, Simon Richard Ellis
    Maytrees 27 Portmore Park Road
    KT13 8ET Weybridge
    Surrey
    Diretor
    Maytrees 27 Portmore Park Road
    KT13 8ET Weybridge
    Surrey
    British16398280001
    POPE, Nigel Howard
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    Diretor
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    EnglandBritish29583660002
    PULSFORD, Jeffrey Mark
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    Diretor
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish49776690004
    ROGERS, Hugh Edward
    24 Sonning Meadows
    RG4 6XB Sonning
    Berkshire
    Diretor
    24 Sonning Meadows
    RG4 6XB Sonning
    Berkshire
    British13156340003
    SADLER, Nicholas James
    Clivia Windmill Hill
    Coleshill
    HP7 0LZ Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    Clivia Windmill Hill
    Coleshill
    HP7 0LZ Amersham
    Buckinghamshire
    British38200390001
    SMITH, Oliver
    48 Redcliffe Gardens
    SW10 9HB London
    Diretor
    48 Redcliffe Gardens
    SW10 9HB London
    British83475590003

    Quem são as pessoas com controle significativo de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    13/06/2023
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro5595895
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    23/04/2018
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    Sim
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro3608348
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    United Kingdom
    06/04/2016
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    United Kingdom
    Sim
    Forma jurídicaUnlimited With Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro1464587
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    HARBOUR PROPERTIES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal charge
    Criado em 16/11/1999
    Entregue em 19/11/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 16TH november 1999 and on any account whatsoever and other sums due under the legal charge dated 16TH november 1999
    Breve descrição
    F/H property at western avenue uxbridge t/no BM110852 & BM85925 with all buildings erections fixtures and fittings fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Gamma Holding (UK) Limited
    Transações
    • 19/11/1999Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deposit of title deeds
    Criado em 29/05/1985
    Entregue em 11/06/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £73,000 under the terms of a sale and purchase agreement d/d 30/4/85.
    Breve descrição
    Part of land k/a oak view 3 gull copse park gate t/n:- hp 202570.
    Pessoas com direito
    • Jazzman Limited
    Transações
    • 11/06/1985Registro de uma garantia
    • 20/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Criado em 30/04/1985
    Entregue em 04/05/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £66,000 under the terms of an agreement of even date
    Breve descrição
    Land to the north of little park farm, little park farm road, titchfield and the land to the east of hazelgrove foreham T.nos. Hp 95290 & hp 118180.
    Pessoas com direito
    • Cay Builders (Wight) Limited
    Transações
    • 04/05/1985Registro de uma garantia
    • 20/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Criado em 30/04/1985
    Entregue em 04/05/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £21,000 under the terms of an agreement to even date
    Breve descrição
    Land to the north west at hill coppice road. T.N. hp 1083149.
    Pessoas com direito
    • Cay Builders (Wight) Limited
    Transações
    • 04/05/1985Registro de uma garantia
    • 20/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Criado em 30/04/1985
    Entregue em 03/05/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £108,000 under the terms of an agreement of even date
    Breve descrição
    Land at ashley little park gull coppice titchfield T.N. hp 210763.
    Pessoas com direito
    • Blue Sparkle Investments Limited
    Transações
    • 03/05/1985Registro de uma garantia
    • 20/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Criado em 30/04/1985
    Entregue em 03/05/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £50,000 under the terms of an agreement of even date.
    Breve descrição
    Land at ashley little park gull coppice, titchfield T.N. hp 210762.
    Pessoas com direito
    • Middle East Management Limited
    Transações
    • 03/05/1985Registro de uma garantia
    • 20/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Criado em 30/04/1985
    Entregue em 03/05/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee not cxceeding £103,000 under the terms of an agreement of even date.
    Breve descrição
    Land at gull copse park gate. T.N.hp 262278.
    Pessoas com direito
    • Jazzman Limited
    Transações
    • 03/05/1985Registro de uma garantia
    • 20/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 05/02/1985
    Entregue em 05/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement d/d 21 december 1984 or this charge.
    Breve descrição
    Land at park gate titchfield hampshire (see doc M18).
    Pessoas com direito
    • A. J. Peat
    • B. C. Hobbs
    • A. Pascoe Sherlock.
    Transações
    • 05/02/1985Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0