SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED

SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01869628
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HAZELBARON LIMITED07/12/198407/12/1984

    Quais são as últimas contas de SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Qual é o status da última declaração anual para SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    4 páginas4.71

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de * Active House 21 North Fourth Street Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1HL* em 09/10/2013

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 19/09/2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração anual preparada até 29/08/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada

    1 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado

    1 páginasAD02

    Nomeação de Mr Paul Antony Woolf como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Norman Field como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2011

    9 páginasAA

    Declaração anual preparada até 29/08/2012 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    Declaração anual preparada até 31/08/2011 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Nomeação de Matthew Graham Merrick como diretor

    4 páginasAP01
    Anotações
    DataAnotação
    27/09/2011The form is a duplicate of AP01 registered on 12/09/2011

    Nomeação de James Archibald como secretário

    4 páginasAP03
    Anotações
    DataAnotação
    27/09/2011The form is a duplicate of AP03 registered on 12/09/2011

    Nomeação de James Archibald como secretário

    3 páginasAP03

    Nomeação de Matthew Graham Merrick como diretor

    3 páginasAP01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2010

    8 páginasAA

    Quem são os diretores de SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ARCHIBALD, James
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Secretário
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    British162966780001
    BUCKNALL, Matthew William
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Diretor
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishCompany Director162066820001
    MERRICK, Matthew Graham
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Diretor
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishUk Finance Director162110530001
    WOOLF, Paul Antony
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Diretor
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishDirector160679880001
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    Secretário
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    British46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Secretário
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    BritishAccountant58961410002
    DAND, Elizabeth Marie
    43 Montague Road
    TW10 6QJ Richmond
    Surrey
    Secretário
    43 Montague Road
    TW10 6QJ Richmond
    Surrey
    BritishFinancial Controller35024770001
    DREGENT, Patricia Ann Taylor
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    Secretário
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    British6369240002
    PENRICE, Victoria Margaret
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    Secretário
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    British90459300001
    RADIN, Richard
    8 Abbotsbury Road
    W14 8EJ London
    Secretário
    8 Abbotsbury Road
    W14 8EJ London
    British3574810001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Secretário
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Secretário
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    BritishChartered Secretary66825690001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Secretário
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WHEELER, Jonathan
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    Secretário
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    British19812400001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Secretário
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    BritishChartered Secretary123616460002
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    Diretor
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    EnglandBritishAccountant46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director Esporta Ntant58961410002
    BAXTER, Headley Thomas
    8 York House Courtlands
    Sheen Road
    Richmond
    Surrey
    Diretor
    8 York House Courtlands
    Sheen Road
    Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director3574820001
    BAXTER, Susan Marion Fraser
    8 York House
    Courtlands Sheen Road
    TW10 5BD Richmond
    Surrey
    Diretor
    8 York House
    Courtlands Sheen Road
    TW10 5BD Richmond
    Surrey
    BritishAccountant38716650001
    BEADLE, Mark Ronald Sydney
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    Diretor
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    BritishDirector80515670001
    BECKWITH, Peter Michael
    29 Marryat Road
    SW19 London
    Diretor
    29 Marryat Road
    SW19 London
    BritishDirector44336530001
    BERNARD, Maxime Douglas Theobald
    37 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Diretor
    37 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    FrenchManager38716580001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Diretor
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishExecutive Director, Esporta Gr96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Diretor
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector146698270001
    COLES, Charles Graham
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    Diretor
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant12337010002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Diretor
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritishCompany Director3716600001
    DAND, Elizabeth Marie
    Rythebrook House 17 Princes Drive
    KT22 0UL Oxshott
    Surrey
    Diretor
    Rythebrook House 17 Princes Drive
    KT22 0UL Oxshott
    Surrey
    BritishFinancial Controller35024770003
    DHODY, Jog
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Diretor
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer, Esporta Gr104269910002
    FIELD, Norman Mark
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Diretor
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth AfricanCompany Director161860310001
    FOSTER, Michael Raymond
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    Diretor
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    EnglandBritishChartered Accountant53280440001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Diretor
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive Esporta Group69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Diretor
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    BritishDivisional Director, Esporta G100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director30306840002
    HENCHOZ, Patrick
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    Diretor
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    United KingdomSwissDirector93431850001
    HUTCHINS, Paul Raymond
    6 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    Diretor
    6 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    United KingdomBritishManaging Director14450450001

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed and floating security document
    Criado em 18/06/2009
    Entregue em 26/06/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transações
    • 26/06/2009Registro de uma garantia (395)
    • 03/10/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Group debenture
    Criado em 08/02/2006
    Entregue em 18/02/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transações
    • 18/02/2006Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental guarantee and debenture
    Criado em 15/07/1994
    Entregue em 21/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement dated 9TH september 1993 and supplemental to a guarantee and debenture dated 5TH november 1993
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/06/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Letter of charge
    Criado em 15/07/1994
    Entregue em 21/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the books of the bank.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/06/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 27/03/1986
    Entregue em 29/03/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £50,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Premises at hannibal way roundshaw sutton.
    Pessoas com direito
    • The Lawn Tennis Association
    Transações
    • 29/03/1986Registro de uma garantia
    • 20/09/1991Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 13/03/1986
    Entregue em 25/03/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property known as fort of roundshaw playing fields in the london borough of sutton. And/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 25/03/1986Registro de uma garantia
    • 25/05/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 15/07/1985
    Entregue em 23/07/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a building agreement dated 18/2/85
    Breve descrição
    A specific charge of all the companys benefit in the building agreement and its estate or interest from time to time in the hereditaments and property comprised in the building agreement howsoever arising or subsisting relating to land situate at hanibal way, roundshaw sutton, surrey.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 23/07/1985Registro de uma garantia
    • 25/05/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 23/04/1985
    Entregue em 29/04/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and or the proceeds of sale fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/04/1985Registro de uma garantia
    • 25/05/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    24/09/2013Início da liquidação
    20/11/2014Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Profissional
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profissional
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0