SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01869628 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Sim |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?
Endereço do escritório registrado | c/o MAZARS LLP 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
HAZELBARON LIMITED | 07/12/1984 | 07/12/1984 |
Quais são as últimas contas de SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2011 |
Qual é o status da última declaração anual para SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?
Declaração anual |
|
---|
Quais são as últimas submissões para SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 4 páginas | 4.71 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * Active House 21 North Fourth Street Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1HL* em 09/10/2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de solvência | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado do capital em 19/09/2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 29/08/2013 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Nomeação de Mr Paul Antony Woolf como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Norman Field como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2011 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 29/08/2012 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 31/08/2011 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Matthew Graham Merrick como diretor | 4 páginas | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de James Archibald como secretário | 4 páginas | AP03 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de James Archibald como secretário | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Nomeação de Matthew Graham Merrick como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2010 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHIBALD, James | Secretário | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | British | 162966780001 | ||||||
BUCKNALL, Matthew William | Diretor | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | Company Director | 162066820001 | ||||
MERRICK, Matthew Graham | Diretor | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | Uk Finance Director | 162110530001 | ||||
WOOLF, Paul Antony | Diretor | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | Director | 160679880001 | ||||
ASHWORTH, Paul Richard | Secretário | 118 St Anns Hill Wandsworth SW18 2RR London | British | 46410260001 | ||||||
BALL, Michael David | Secretário | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | British | Accountant | 58961410002 | |||||
DAND, Elizabeth Marie | Secretário | 43 Montague Road TW10 6QJ Richmond Surrey | British | Financial Controller | 35024770001 | |||||
DREGENT, Patricia Ann Taylor | Secretário | 17 Spinney Close RM13 8LR Rainham Essex | British | 6369240002 | ||||||
PENRICE, Victoria Margaret | Secretário | Trebartha 51a Frances Road SL4 3AQ Windsor Berkshire | British | 90459300001 | ||||||
RADIN, Richard | Secretário | 8 Abbotsbury Road W14 8EJ London | British | 3574810001 | ||||||
SCALES, Eugene Patrick | Secretário | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | Other | 124193970001 | ||||||
SHILLINGLAW, Gary Preston | Secretário | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | Chartered Secretary | 66825690001 | |||||
TYSON, Roger Thomas Virley | Secretário | 2 Gadd Close RG40 5PQ Wokingham Berkshire | British | 113777700001 | ||||||
WHEELER, Jonathan | Secretário | 19 Glebe Place Chelsea SW3 5LD London | British | 19812400001 | ||||||
WONG, Wai Chung | Secretário | Flat 3 Rowsley Lodge 72a Lady Margaret Road N19 5EL London | British | Chartered Secretary | 123616460002 | |||||
ASHWORTH, Paul Richard | Diretor | 118 St Anns Hill Wandsworth SW18 2RR London | England | British | Accountant | 46410260001 | ||||
BALL, Michael David | Diretor | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | Finance Director Esporta Ntant | 58961410002 | ||||
BAXTER, Headley Thomas | Diretor | 8 York House Courtlands Sheen Road Richmond Surrey | British | Company Director | 3574820001 | |||||
BAXTER, Susan Marion Fraser | Diretor | 8 York House Courtlands Sheen Road TW10 5BD Richmond Surrey | British | Accountant | 38716650001 | |||||
BEADLE, Mark Ronald Sydney | Diretor | 14 Fen Meadow TN15 9HT Ightham Kent | British | Director | 80515670001 | |||||
BECKWITH, Peter Michael | Diretor | 29 Marryat Road SW19 London | British | Director | 44336530001 | |||||
BERNARD, Maxime Douglas Theobald | Diretor | 37 Crofton Avenue Chiswick W4 3EW London | French | Manager | 38716580001 | |||||
CHARLTON, Stephen Paul | Diretor | 9 Rowan Close L40 4LP Burscough Lancashire | England | British | Executive Director, Esporta Gr | 96743210001 | ||||
CLELAND, Jonathan Bradley | Diretor | North Fourth Street MK9 1HL Milton Keynes Active House 21 Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 146698270001 | ||||
COLES, Charles Graham | Diretor | Willow Cottage Chalfont Lane WD3 5PP Chorleywood Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 12337010002 | ||||
CREED, Stuart John | Diretor | Jade House The Avenue Claverton Down BA2 7AX Bath | United Kingdom | British | Company Director | 3716600001 | ||||
DAND, Elizabeth Marie | Diretor | Rythebrook House 17 Princes Drive KT22 0UL Oxshott Surrey | British | Financial Controller | 35024770003 | |||||
DHODY, Jog | Diretor | North Fourth Street MK9 1HL Milton Keynes Active House 21 Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chief Financial Officer, Esporta Gr | 104269910002 | ||||
FIELD, Norman Mark | Diretor | North Fourth Street MK9 1HL Milton Keynes Active House 21 Buckinghamshire | United Kingdom | South African | Company Director | 161860310001 | ||||
FOSTER, Michael Raymond | Diretor | 4 Church Close Westoning MK45 5DH Bedford | England | British | Chartered Accountant | 53280440001 | ||||
GILLIS, Neil Duncan | Diretor | Lodge Farm High Street, Thelnetham IP22 1JL Diss Norfolk | England | British | Chief Executive Esporta Group | 69204500003 | ||||
GUYER, Paul John | Diretor | Oakwood House 29 Leydene Park GU32 1HF East Meon Hampshire | British | Divisional Director, Esporta G | 100971720002 | |||||
HALL, Andrew James | Diretor | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | Company Director | 30306840002 | ||||
HENCHOZ, Patrick | Diretor | Huntington Court Huntington Lane HR4 7RA Hereford Herefordshire | United Kingdom | Swiss | Director | 93431850001 | ||||
HUTCHINS, Paul Raymond | Diretor | 6 Coombe Gardens Wimbledon SW20 0QU London | United Kingdom | British | Managing Director | 14450450001 |
SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating security document | Criado em 18/06/2009 Entregue em 26/06/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Group debenture | Criado em 08/02/2006 Entregue em 18/02/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Supplemental guarantee and debenture | Criado em 15/07/1994 Entregue em 21/07/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement dated 9TH september 1993 and supplemental to a guarantee and debenture dated 5TH november 1993 | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Letter of charge | Criado em 15/07/1994 Entregue em 21/07/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the books of the bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 27/03/1986 Entregue em 29/03/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £50,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descrição Premises at hannibal way roundshaw sutton. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 13/03/1986 Entregue em 25/03/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição L/H property known as fort of roundshaw playing fields in the london borough of sutton. And/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge | Criado em 15/07/1985 Entregue em 23/07/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a building agreement dated 18/2/85 | |
Breve descrição A specific charge of all the companys benefit in the building agreement and its estate or interest from time to time in the hereditaments and property comprised in the building agreement howsoever arising or subsisting relating to land situate at hanibal way, roundshaw sutton, surrey.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage debenture | Criado em 23/04/1985 Entregue em 29/04/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and or the proceeds of sale fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
SURREY TENNIS & COUNTRY CLUB (STCC) LIMITED possui casos de insolvência?
Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0