WICKES NOMINEE LIMITED

WICKES NOMINEE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaWICKES NOMINEE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01874380
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de WICKES NOMINEE LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica WICKES NOMINEE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de WICKES NOMINEE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    WICKES UK HOLDINGS LIMITED16/12/198516/12/1985
    WICKES INVESTMENTS LIMITED07/02/198507/02/1985
    SHINEFORE LIMITED27/12/198427/12/1984

    Quais são as últimas contas de WICKES NOMINEE LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em30/06/2015
    Próximas contas vencem em31/03/2016
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Quais são as últimas submissões para WICKES NOMINEE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Detalhes do diretor alterados para Miss Deborah Grimason em 13/10/2016

    2 páginasCH01

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginas4.71

    Endereço do domicílio registado alterado de Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton Northamptonshire NN5 7UG para 45 Church Street Birmingham B3 2RT em 06/01/2016

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 21/12/2015

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 14/12/2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração anual preparada até 18/10/2015 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital22/10/2015

    Estado do capital em 22/10/2015

    • Capital: GBP 335,012
    SH01

    Nomeação de Miss Deborah Grimason como diretor em 10/09/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Anthony David Buffin como diretor em 10/09/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de John Peter Carter como diretor em 10/09/2015

    1 páginasTM01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/12/2014 para 30/06/2015

    1 páginasAA01

    Declaração anual preparada até 18/10/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/11/2014

    Estado do capital em 04/11/2014

    • Capital: GBP 335,012
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    1 páginasAA

    Término da nomeação de Andrew Stephen Pike como secretário em 23/09/2014

    1 páginasTM02

    Nomeação de Tp Directors Ltd como diretor em 19/09/2014

    2 páginasAP02

    Resoluções

    Resolutions
    16 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Nomeação de Anthony David Buffin como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 18/10/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/11/2013

    Estado do capital em 04/11/2013

    • Capital: GBP 335,012
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    1 páginasAA

    Término da nomeação de Paul Hampden Smith como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de WICKES NOMINEE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GRIMASON, Deborah
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Diretor
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    EnglandBritish185755960002
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Diretor
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro03480295
    191205550001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Secretário
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Secretário
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretário
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Diretor
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BATTERSBY, Geoffrey Brian
    13 15 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RE London
    Diretor
    13 15 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RE London
    British41548740003
    BHOTE, Sanaya Homi
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    Diretor
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    British72716110002
    BIRD, Richard Sidney
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Diretor
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    British111500210001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    Lodge Way House
    Lodge Way Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish178011680001
    CARTER, John Peter
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Diretor
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish46226920007
    CORNER, Michael Richmond
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    Diretor
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    British21206150001
    GRIMSEY, William
    The Capita Group Plc
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    Diretor
    The Capita Group Plc
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    United KingdomBritish50647840002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HORNE, Nicholas Paul Stewart
    4 Braemar Close
    GU7 1SA Godalming
    Surrey
    Diretor
    4 Braemar Close
    GU7 1SA Godalming
    Surrey
    British983490001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    LLEWELLYN, Trefor Wilmot
    Hill Farm House
    Ipsden
    OX10 6AD Wallingford
    Oxfordshire
    Diretor
    Hill Farm House
    Ipsden
    OX10 6AD Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish107250730001
    PENNY, Michael William Harrison
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    Diretor
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish144262470001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Diretor
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    STRADLING, Stuart Rhys
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    Diretor
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    United KingdomBritish44265550001
    SWEETBAUM, Henry Alan
    11 Park Village West
    NW1 4AE London
    Diretor
    11 Park Village West
    NW1 4AE London
    United KingdomAmerican10349960001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Diretor
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001

    WICKES NOMINEE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A mezzanine debenture
    Criado em 28/07/2003
    Entregue em 13/08/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ing Bank N.V. , London Branch, (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transações
    • 13/08/2003Registro de uma garantia (395)
    • 31/03/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Senior security accession deed
    Criado em 29/01/2003
    Entregue em 13/02/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transações
    • 13/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 31/03/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Subordinated security accession deed
    Criado em 29/01/2003
    Entregue em 13/02/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transações
    • 13/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 05/08/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent
    Criado em 16/01/2001
    Entregue em 31/01/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ing Bank N.V.,London Branch
    Transações
    • 31/01/2001Registro de uma garantia (395)
    • 27/06/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 29/12/2000
    Entregue em 09/01/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transações
    • 09/01/2001Registro de uma garantia (395)
    • 05/02/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security accession deed between wickes nominee limited, the parent (as defined) and ing bank N.V. london branch (being supplemental to a debenture dated 26TH september 2000)
    Criado em 27/10/2000
    Entregue em 06/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors (as defined) to the secured parties (as defined) under the finance documents (as defined) (or any of them)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transações
    • 06/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 20/02/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 07/01/1997
    Entregue em 15/01/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 15/01/1997Registro de uma garantia (395)
    • 30/09/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Limited recourse guarantee and debenture
    Criado em 12/12/1996
    Entregue em 20/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and all or any of the o f the companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 30/09/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 03/07/1996
    Entregue em 10/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 10/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    WICKES NOMINEE LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    21/12/2015Início da liquidação
    09/05/2017Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profissional
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Profissional
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0