COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01877766 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 50 - 52 Chancery Lane WC2A 1HL London |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
PARADISE MOTORS LIMITED | 15/01/1985 | 15/01/1985 |
Quais são as últimas contas de COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 30/06/2015 |
Qual é o status da última declaração anual para COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?
Declaração anual |
|
---|
Quais são as últimas submissões para COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 31/12/2015 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 22 Chancery Lane London WC2A 1LS | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para 22 Chancery Lane London WC2A 1LS | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Término da nomeação de Robert Martin Fielding como diretor em 17/09/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/12/2014 para 30/06/2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Quindell Court 1 Barnes Wallis Road Segensworth East Fareham Hampshire PO15 5UA England para 50 - 52 Chancery Lane London WC2A 1HL em 19/08/2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 13 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração dos objetos da sociedade | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Nomeação de Mr Kenneth John Fowlie como diretor em 29/05/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Ms Kirsten Morrison como secretário em 29/05/2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Edward Ian Charles Walker como secretário em 29/05/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Término da nomeação de Laurence Moorse como diretor em 29/05/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 4 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Indemnity House Sir Frank Whittle Way Blackpool Lancashire FY4 2FB para Quindell Court 1 Barnes Wallis Road Segensworth East Fareham Hampshire PO15 5UA em 02/03/2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 31/12/2014 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Laurence Moorse como diretor em 10/12/2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de David Badal Sandhu como diretor em 10/12/2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Robert Martin Fielding como diretor em 10/12/2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Edward Ian Charles Walker como secretário | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Ian Farrelly como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Quem são os diretores de COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORRISON, Kirsten | Secretário | Chancery Lane WC2A 1HL London 50 - 52 England | 198645830001 | |||||||
FOWLIE, Kenneth John | Diretor | Chancery Lane WC2A 1HL London 50 - 52 England | Australia | Australian | Lawyer | 197320660001 | ||||
BOBBINS, Valerie Jean | Secretário | Dickleburgh Manor Dickleburgh IP21 4NJ Diss Norfolk | British | 3124710004 | ||||||
FARRELLY, Ian | Secretário | Barnes Wallis Road PO15 5UA Fareham 1 Hampshire England | 180946700001 | |||||||
HARRISON, Peter John | Secretário | Sir Frank Whittle Way FY4 2FB Blackpool Indemnity House Lancashire England | United Kingdom | Finance Director | 98870750001 | |||||
ORME, Geoffrey Michael | Secretário | 8 Grange Road FY8 2BN Lytham St Annes Lancashire | British | Finance Director | 116893470001 | |||||
WALKER, Edward Ian Charles | Secretário | 1 Barnes Wallis Road Segensworth East PO15 5UA Fareham Quindell Court Hampshire England | 189125300001 | |||||||
BOBBINS, Kenneth | Diretor | Dickleburgh Manor Norwich Road Dickleburgh IP21 4NJ Diss Norfolk | United Kingdom | British | Company Director | 21179050003 | ||||
BOBBINS, Mark | Diretor | 2 Gilby Avenue Hunstanton Norfolk | British | Salesman | 6822070001 | |||||
BOBBINS, Valerie Jean | Diretor | Dickleburgh Manor Dickleburgh IP21 4NJ Diss Norfolk | United Kingdom | British | Company Director | 3124710004 | ||||
CANAVAN, Lorraine Mary | Diretor | 23 Fieldens Farm Lane Mellor Brook BB2 7PD Blackburn Lancashire | British | Hr Manager | 45874210002 | |||||
FIELDING, Robert Martin | Diretor | Chancery Lane WC2A 1HL London 50 - 52 England | England | British | Company Director | 187535920001 | ||||
MOORSE, Laurence | Diretor | 1 Barnes Wallis Road Segensworth East PO15 5UA Fareham Quindell Court Hampshire England | England | British | Company Director | 78291360003 | ||||
ORME, Geoffrey Michael | Diretor | 8 Grange Road FY8 2BN Lytham St Annes Lancashire | England | British | Finance Director | 116893470001 | ||||
PALMER, Adrian Matthew | Diretor | Rotherfield Lodge Beacon Road TN6 1UQ Crowborough East Sussex | British | Chief Executive | 29054400004 | |||||
SANDHU, David Badal | Diretor | Sir Frank Whittle Way FY4 2FB Blackpool Indemnity House Lancashire England | United Kingdom | British | Director | 73704510004 |
COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Master agreement | Criado em 30/08/1994 Entregue em 31/08/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All rights title and interest in the sub-hire agreements described in supplementary schedules entered into pursuant to the master agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Prompt credit application | Criado em 08/01/1993 Entregue em 15/01/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £35,923.30 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Breve descrição All right title and interest in and to all sums payable under the insurance (for full details see form 395 tc ref: M128C). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee & debenture | Criado em 26/10/1991 Entregue em 07/11/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due or to become due from the company and/or motor aid hire limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição See form 395 ref 542C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Credit agreement entitled "prompt credit application" | Criado em 15/01/1991 Entregue em 23/01/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £41,377.10, being the total amount payable by the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Breve descrição All right, title and interest in and to all sums payable under the insurance (see form 395 for full details). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 25/10/1989 Entregue em 02/11/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fixed and floating charge | Criado em 26/09/1985 Entregue em 01/10/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0