COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED

COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCOLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01877766
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    50 - 52 Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PARADISE MOTORS LIMITED15/01/198515/01/1985

    Quais são as últimas contas de COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2015

    Qual é o status da última declaração anual para COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2015

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/12/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital28/01/2016

    Estado do capital em 28/01/2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 22 Chancery Lane London WC2A 1LS

    1 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para 22 Chancery Lane London WC2A 1LS

    1 páginasAD02

    Término da nomeação de Robert Martin Fielding como diretor em 17/09/2015

    1 páginasTM01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/12/2014 para 30/06/2015

    1 páginasAA01

    Endereço do domicílio registado alterado de Quindell Court 1 Barnes Wallis Road Segensworth East Fareham Hampshire PO15 5UA England para 50 - 52 Chancery Lane London WC2A 1HL em 19/08/2015

    1 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    13 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Nomeação de Mr Kenneth John Fowlie como diretor em 29/05/2015

    2 páginasAP01

    Nomeação de Ms Kirsten Morrison como secretário em 29/05/2015

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Edward Ian Charles Walker como secretário em 29/05/2015

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Laurence Moorse como diretor em 29/05/2015

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 2

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 4

    2 páginasMR04

    Endereço do domicílio registado alterado de Indemnity House Sir Frank Whittle Way Blackpool Lancashire FY4 2FB para Quindell Court 1 Barnes Wallis Road Segensworth East Fareham Hampshire PO15 5UA em 02/03/2015

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 31/12/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/01/2015

    Estado do capital em 02/01/2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nomeação de Mr Laurence Moorse como diretor em 10/12/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Badal Sandhu como diretor em 10/12/2014

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Robert Martin Fielding como diretor em 10/12/2014

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Edward Ian Charles Walker como secretário

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Ian Farrelly como secretário

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MORRISON, Kirsten
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    Secretário
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    198645830001
    FOWLIE, Kenneth John
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    Diretor
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    AustraliaAustralianLawyer197320660001
    BOBBINS, Valerie Jean
    Dickleburgh Manor
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    Secretário
    Dickleburgh Manor
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    British3124710004
    FARRELLY, Ian
    Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    1
    Hampshire
    England
    Secretário
    Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    1
    Hampshire
    England
    180946700001
    HARRISON, Peter John
    Sir Frank Whittle Way
    FY4 2FB Blackpool
    Indemnity House
    Lancashire
    England
    Secretário
    Sir Frank Whittle Way
    FY4 2FB Blackpool
    Indemnity House
    Lancashire
    England
    United KingdomFinance Director98870750001
    ORME, Geoffrey Michael
    8 Grange Road
    FY8 2BN Lytham St Annes
    Lancashire
    Secretário
    8 Grange Road
    FY8 2BN Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishFinance Director116893470001
    WALKER, Edward Ian Charles
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Secretário
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    189125300001
    BOBBINS, Kenneth
    Dickleburgh Manor Norwich Road
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    Diretor
    Dickleburgh Manor Norwich Road
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director21179050003
    BOBBINS, Mark
    2 Gilby Avenue
    Hunstanton
    Norfolk
    Diretor
    2 Gilby Avenue
    Hunstanton
    Norfolk
    BritishSalesman6822070001
    BOBBINS, Valerie Jean
    Dickleburgh Manor
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    Diretor
    Dickleburgh Manor
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director3124710004
    CANAVAN, Lorraine Mary
    23 Fieldens Farm Lane
    Mellor Brook
    BB2 7PD Blackburn
    Lancashire
    Diretor
    23 Fieldens Farm Lane
    Mellor Brook
    BB2 7PD Blackburn
    Lancashire
    BritishHr Manager45874210002
    FIELDING, Robert Martin
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    Diretor
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    EnglandBritishCompany Director187535920001
    MOORSE, Laurence
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Diretor
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director78291360003
    ORME, Geoffrey Michael
    8 Grange Road
    FY8 2BN Lytham St Annes
    Lancashire
    Diretor
    8 Grange Road
    FY8 2BN Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director116893470001
    PALMER, Adrian Matthew
    Rotherfield Lodge
    Beacon Road
    TN6 1UQ Crowborough
    East Sussex
    Diretor
    Rotherfield Lodge
    Beacon Road
    TN6 1UQ Crowborough
    East Sussex
    BritishChief Executive29054400004
    SANDHU, David Badal
    Sir Frank Whittle Way
    FY4 2FB Blackpool
    Indemnity House
    Lancashire
    England
    Diretor
    Sir Frank Whittle Way
    FY4 2FB Blackpool
    Indemnity House
    Lancashire
    England
    United KingdomBritishDirector73704510004

    COLEGATE VEHICLE HIRE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Master agreement
    Criado em 30/08/1994
    Entregue em 31/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All rights title and interest in the sub-hire agreements described in supplementary schedules entered into pursuant to the master agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Leasing Limited
    Transações
    • 31/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 26/06/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Prompt credit application
    Criado em 08/01/1993
    Entregue em 15/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £35,923.30 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Breve descrição
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance (for full details see form 395 tc ref: M128C).
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 15/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 26/06/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 26/10/1991
    Entregue em 07/11/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company and/or motor aid hire limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    See form 395 ref 542C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/11/1991Registro de uma garantia (395)
    • 24/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Credit agreement entitled "prompt credit application"
    Criado em 15/01/1991
    Entregue em 23/01/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £41,377.10, being the total amount payable by the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Breve descrição
    All right, title and interest in and to all sums payable under the insurance (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited.
    Transações
    • 23/01/1991Registro de uma garantia
    • 26/06/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 25/10/1989
    Entregue em 02/11/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 02/11/1989Registro de uma garantia
    • 24/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating charge
    Criado em 26/09/1985
    Entregue em 01/10/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 01/10/1985Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0