NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED

NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaNORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01900786
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Votec House The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Berkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LEGIBUS 593 LIMITED29/03/198529/03/1985

    Quais são as últimas contas de NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/04/2014

    Qual é o status da última declaração anual para NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01
    A3MG97HM

    Declaração anual preparada até 12/10/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/10/2014

    Estado do capital em 14/10/2014

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X3IGFAUZ

    Contas preparadas até 30/04/2014

    5 páginasAA
    A39KMKS9

    Contas preparadas até 30/04/2013

    5 páginasAA
    A2Z468U8

    Declaração anual preparada até 12/10/2013 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    X2JQTDLC

    Nomeação de Mr Steven Westbrook como secretário em 25/10/2013

    2 páginasAP03
    X2JQTDL4

    Endereço do domicílio registado alterado de 210 Wharfedale Road Winnersh Triangle Wokingham Berkshire RG41 5TP United Kingdom em 25/10/2013

    1 páginasAD01
    X2JQTDKW

    Término da nomeação de Alun Philip John como diretor em 26/06/2013

    1 páginasTM01
    X2BBYG1K

    Nomeação de Mr Nigel John Palmer como diretor em 03/05/2013

    2 páginasAP01
    X27LOTOY

    Nomeação de Mr Steven Westbrook como diretor em 03/05/2013

    2 páginasAP01
    X27LOTFR

    Término da nomeação de Susan Miller como secretário em 25/03/2013

    1 páginasTM02
    X24V72LF

    Contas preparadas até 30/04/2012

    5 páginasAA
    A211RJM1

    Declaração anual preparada até 12/10/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    X1LMB48P

    Contas preparadas até 30/04/2011

    5 páginasAA
    A11IIFG3

    Declaração anual preparada até 12/10/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    X71N1YUL

    Término da nomeação de William Ian David Lazarus como diretor em 30/06/2011

    1 páginasTM01
    X71N0YUK

    Declaração anual preparada até 12/10/2010 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    XNUOFO9E

    Contas preparadas até 30/04/2010

    5 páginasAA
    ACI6WL3U

    Contas preparadas até 30/04/2009

    5 páginasAA
    AICSNGUT

    Declaração anual preparada até 12/10/2009 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    XSWZWEIC

    Detalhes do diretor alterados para Alun Philip John em 11/10/2009

    2 páginasCH01
    XSWZUEIA

    Detalhes do diretor alterados para William Ian David Lazarus em 11/10/2009

    2 páginasCH01
    XSWZVEIB

    Detalhes do secretário alterados para Susan Miller em 11/10/2009

    1 páginasCH03
    XSWZTEI9

    Quem são os diretores de NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WESTBROOK, Steven
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    Secretário
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    182410630001
    PALMER, Nigel John
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    Diretor
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    EnglandBritishChief Executive178019970001
    WESTBROOK, Steven
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    Diretor
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    EnglandBritishFinance Director76995140002
    DAW, Michael Charles
    Simonswood Cottage
    Wellingtonia Avenue Finchampstead
    RG45 6AF Crowthorne
    Berkshire
    Secretário
    Simonswood Cottage
    Wellingtonia Avenue Finchampstead
    RG45 6AF Crowthorne
    Berkshire
    British54233210001
    HENDRIE, Joanne
    6 Selcourt Close
    Woodley
    RG5 3AS Reading
    Berkshire
    Secretário
    6 Selcourt Close
    Woodley
    RG5 3AS Reading
    Berkshire
    British56419280001
    MILLER, Susan
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    British66529190001
    RILEY, Marian Linda
    3 Aldershot Road
    GU13 9NG Fleet
    Hampshire
    Secretário
    3 Aldershot Road
    GU13 9NG Fleet
    Hampshire
    British46356770001
    SUGDEN, Martin Leslie
    Hill House
    Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    Secretário
    Hill House
    Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    British63057200002
    DAW, Michael Charles
    Simonswood Cottage
    Wellingtonia Avenue Finchampstead
    RG45 6AF Crowthorne
    Berkshire
    Diretor
    Simonswood Cottage
    Wellingtonia Avenue Finchampstead
    RG45 6AF Crowthorne
    Berkshire
    BritishCompany Director54233210001
    HALLIWELL, Jane Hunt
    64 Granville Gardens
    EN11 9QD Hoddesdon
    Hertfordshire
    Diretor
    64 Granville Gardens
    EN11 9QD Hoddesdon
    Hertfordshire
    UkBritishAccountant47183850002
    HENRY, Michael Julian
    228 St Margarets Road
    TW1 1NL Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    228 St Margarets Road
    TW1 1NL Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishGroup F D67046810001
    JOHN, Alun Philip
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director22249120002
    JOHN, Alun Philip
    Paddock Woods 25 Tudor Close
    Grayshott
    GU26 6HP Hindhead
    Surrey
    Diretor
    Paddock Woods 25 Tudor Close
    Grayshott
    GU26 6HP Hindhead
    Surrey
    BritishCompany Director22249120001
    LAZARUS, William Ian David
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director7282030001
    NICOL, John Bain
    Crabtree Lodge Bracknell Lane
    Hazeley Heath
    RG27 8LT Hartley Witney
    Hampshire
    Diretor
    Crabtree Lodge Bracknell Lane
    Hazeley Heath
    RG27 8LT Hartley Witney
    Hampshire
    BritishCompany Director63660230001
    NICOL, Susanna Mary
    Kitscroft Up Green
    Eversley
    RG27 0PE Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    Kitscroft Up Green
    Eversley
    RG27 0PE Basingstoke
    Hampshire
    BritishCompany Director21967780001
    SUGDEN, Martin Leslie
    Hill House
    Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    Diretor
    Hill House
    Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    BritishDirector63057200002
    WESTROPP, Anthony Henry
    Wootton Downs Farmhouse
    OX20 1AF Woodstock
    Oxfordshire
    Diretor
    Wootton Downs Farmhouse
    OX20 1AF Woodstock
    Oxfordshire
    BritishDirector22515790002

    NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed and floating charge
    Criado em 15/08/1986
    Entregue em 27/08/1986
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 27/08/1986Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 08/07/1986
    Entregue em 21/07/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an invoice discounting agreement, d/d 8/7/86.
    Breve descrição
    All the book and other debts due to the company from time to time howsoever by way of a first fixed charge.
    Pessoas com direito
    • Kellock Limited
    Transações
    • 21/07/1986Registro de uma garantia
    Composite guarantee & debenture
    Criado em 25/02/1986
    Entregue em 03/03/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    (For full details see doc. M13). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Citibank N.A.
    Transações
    • 03/03/1986Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 03/09/1985
    Entregue em 09/09/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 09/09/1985Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0