NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01900786 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Votec House The Vo-Tec Centre Hambridge Lane RG14 5TN Newbury Berkshire |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
LEGIBUS 593 LIMITED | 29/03/1985 | 29/03/1985 |
Quais são as últimas contas de NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 30/04/2014 |
Qual é o status da última declaração anual para NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?
Declaração anual |
|
---|
Quais são as últimas submissões para NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/10/2014 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas preparadas até 30/04/2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Contas preparadas até 30/04/2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/10/2013 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Steven Westbrook como secretário em 25/10/2013 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 210 Wharfedale Road Winnersh Triangle Wokingham Berkshire RG41 5TP United Kingdom em 25/10/2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Término da nomeação de Alun Philip John como diretor em 26/06/2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Nigel John Palmer como diretor em 03/05/2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Steven Westbrook como diretor em 03/05/2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Susan Miller como secretário em 25/03/2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas preparadas até 30/04/2012 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/10/2012 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas preparadas até 30/04/2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/10/2011 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Término da nomeação de William Ian David Lazarus como diretor em 30/06/2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/10/2010 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas preparadas até 30/04/2010 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Contas preparadas até 30/04/2009 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/10/2009 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Alun Philip John em 11/10/2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para William Ian David Lazarus em 11/10/2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Susan Miller em 11/10/2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Quem são os diretores de NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTBROOK, Steven | Secretário | The Vo-Tec Centre Hambridge Lane RG14 5TN Newbury Votec House Berkshire England | 182410630001 | |||||||
PALMER, Nigel John | Diretor | The Vo-Tec Centre Hambridge Lane RG14 5TN Newbury Votec House Berkshire England | England | British | Chief Executive | 178019970001 | ||||
WESTBROOK, Steven | Diretor | The Vo-Tec Centre Hambridge Lane RG14 5TN Newbury Votec House Berkshire England | England | British | Finance Director | 76995140002 | ||||
DAW, Michael Charles | Secretário | Simonswood Cottage Wellingtonia Avenue Finchampstead RG45 6AF Crowthorne Berkshire | British | 54233210001 | ||||||
HENDRIE, Joanne | Secretário | 6 Selcourt Close Woodley RG5 3AS Reading Berkshire | British | 56419280001 | ||||||
MILLER, Susan | Secretário | Wharfedale Road Winnersh Triangle RG41 5TP Wokingham 210 Berkshire United Kingdom | British | 66529190001 | ||||||
RILEY, Marian Linda | Secretário | 3 Aldershot Road GU13 9NG Fleet Hampshire | British | 46356770001 | ||||||
SUGDEN, Martin Leslie | Secretário | Hill House Heckfield RG27 0JY Hook Hampshire | British | 63057200002 | ||||||
DAW, Michael Charles | Diretor | Simonswood Cottage Wellingtonia Avenue Finchampstead RG45 6AF Crowthorne Berkshire | British | Company Director | 54233210001 | |||||
HALLIWELL, Jane Hunt | Diretor | 64 Granville Gardens EN11 9QD Hoddesdon Hertfordshire | Uk | British | Accountant | 47183850002 | ||||
HENRY, Michael Julian | Diretor | 228 St Margarets Road TW1 1NL Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Group F D | 67046810001 | ||||
JOHN, Alun Philip | Diretor | Wharfedale Road Winnersh Triangle RG41 5TP Wokingham 210 Berkshire United Kingdom | England | British | Managing Director | 22249120002 | ||||
JOHN, Alun Philip | Diretor | Paddock Woods 25 Tudor Close Grayshott GU26 6HP Hindhead Surrey | British | Company Director | 22249120001 | |||||
LAZARUS, William Ian David | Diretor | Wharfedale Road Winnersh Triangle RG41 5TP Wokingham 210 Berkshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 7282030001 | ||||
NICOL, John Bain | Diretor | Crabtree Lodge Bracknell Lane Hazeley Heath RG27 8LT Hartley Witney Hampshire | British | Company Director | 63660230001 | |||||
NICOL, Susanna Mary | Diretor | Kitscroft Up Green Eversley RG27 0PE Basingstoke Hampshire | British | Company Director | 21967780001 | |||||
SUGDEN, Martin Leslie | Diretor | Hill House Heckfield RG27 0JY Hook Hampshire | British | Director | 63057200002 | |||||
WESTROPP, Anthony Henry | Diretor | Wootton Downs Farmhouse OX20 1AF Woodstock Oxfordshire | British | Director | 22515790002 |
NORBAIN COMPUTER SUPPLIES LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Criado em 15/08/1986 Entregue em 27/08/1986 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 08/07/1986 Entregue em 21/07/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an invoice discounting agreement, d/d 8/7/86. | |
Breve descrição All the book and other debts due to the company from time to time howsoever by way of a first fixed charge. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Composite guarantee & debenture | Criado em 25/02/1986 Entregue em 03/03/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descrição (For full details see doc. M13). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 03/09/1985 Entregue em 09/09/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0