CASTLE HOME VIDEO LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CASTLE HOME VIDEO LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01938596 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
- Criação artística (90030) / Atividades artísticas, recreativas e de espetáculos
Onde fica CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 33 Wigmore Street W1U 1QX London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| INDEPENDENT VIDEO SERVICES LIMITED | 28/11/1985 | 28/11/1985 |
| SHARPIRON LIMITED | 13/08/1985 | 13/08/1985 |
Quais são as últimas contas de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2013 |
Qual é o status da última declaração anual para CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Declaração anual |
|
|---|
Quais são as últimas submissões para CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 18/12/2014 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Maximilian Dressendoerfer em 17/10/2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Mark David Ranyard em 17/10/2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Contas preparadas até 31/12/2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 27/08/2014
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN England para Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB | 1 páginas | AD03 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 18/12/2013 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS United Kingdom | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Davenport Lyons 30 Old Burlington Street London W1S 3NL England em 10/09/2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Mark David Ranyard como diretor em 30/04/2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nomeação de Maximilian Dressendoerfer como diretor em 30/04/2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nomeação de John Leslie Dobinson como diretor em 30/04/2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Timothy Spencer Smith como diretor em 30/04/2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 364-366 Kensington High Street London W14 8NS England em 06/06/2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Contas preparadas até 31/12/2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 18/12/2012 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nomeação de Timothy Spencer Smith como diretor em 21/11/2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Abolanle Abioye como secretário em 21/11/2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Adam Martin Barker como diretor em 21/11/2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de David Richard James Sharpe como diretor em 21/11/2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Quem são os diretores de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBINSON, John Leslie | Diretor | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | United Kingdom | British | 34942720003 | |||||
| DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr | Diretor | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | Germany | German | 157717080010 | |||||
| RANYARD, Mark David | Diretor | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | England | British | 154884950002 | |||||
| ABIOYE, Abolanle | Secretário | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | British | 88802330001 | ||||||
| COOK, Edward John Nicholas | Secretário | Flat 2 47 Crooked Billet SW19 4RQ London | British | 59798700002 | ||||||
| HOLDER, Ian Keith | Secretário | 39a Great Percy Street WC1X 9RD London | British | 60759970001 | ||||||
| JOY, Matthew Robert | Secretário | 2 Chestnut Place KT21 2DY Ashtead Surrey | British | 115905420001 | ||||||
| O'BRIEN, Judith Elizabeth | Secretário | Glinton Cottage Milton Avenue Chalfont St Peter SL9 8QW Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 53890870001 | ||||||
| STANDING, Sarah Elizabeth Anne | Secretário | 1 Pilsdon Close Inner Park Road Wimbledon SW19 6DR London | British | 41378870002 | ||||||
| CITY GROUP PLC | Secretário | 25 City Road EC1Y 1BQ London | 35794270001 | |||||||
| BARKER, Adam Martin | Diretor | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | British | 162279360001 | |||||
| BEECHER, Jonathan Roderick | Diretor | Great Oaks 7 Woodway Merrow GU1 2TF Guildford Surrey | British | 4641390002 | ||||||
| BRYANT, David Thomas | Diretor | Ramillies Road W4 1JW London 37 United Kingdom | England | British | 129141390001 | |||||
| COKELL, Joseph | Diretor | Talltrees Orpington Road BR7 6RA Chislehurst Kent | Gb-Eng | British | 76396440001 | |||||
| CONSTANT, Richard Michael | Diretor | 6 Balniel Gate SW1V 3SD London | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||
| COOK, Edward John Nicholas | Diretor | 25 Ernle Road Wimbledon SW20 0HH London | British | 59798700004 | ||||||
| FISHER, Thomas Clive | Diretor | 1 Nevelle Close Binfield RG42 4AZ Bracknell Berkshire | England | British | 26978160002 | |||||
| MUIR, Boyd Johnston | Diretor | The Street Albury GU5 9AX Guildford Old Rectory Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 129432950001 | |||||
| SEMON, Roger | Diretor | Kingsfield Kings Lane Cobblers Hill HP16 9PN Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 59798610002 | |||||
| SHAND, Terence Richard | Diretor | Winkins Wood Farm Shillinglee Road Plaistow RH14 0PQ Billingshurst West Sussex | British | 4641400002 | ||||||
| SHARPE, David Richard James | Diretor | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | Irish | 166109150001 | |||||
| SMITH, Timothy Spencer | Diretor | Avonmore Road Kensington Village W14 8TS London Beaumont House United Kingdom | England | British | 130003340001 | |||||
| WALLACE, Paul Frederick | Diretor | Westfield House Nunnery Lane TN11 8HA Penshurst Kent | England | British | 76655520001 |
CASTLE HOME VIDEO LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Criado em 07/05/1991 Entregue em 09/05/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee & debenture | Criado em 22/12/1988 Entregue em 11/01/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage debenture | Criado em 19/10/1987 Entregue em 28/10/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Fixed and floating charge | Criado em 26/06/1987 Entregue em 03/07/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed charge on all book & other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (exceeding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 26/06/1987 Entregue em 03/07/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição L/H property k/a flat 7 rippon house, hornchurch essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0