O L DEC 18 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaO L DEC 18 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01942994
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de O L DEC 18 LIMITED?

    • (6521) /

    Onde fica O L DEC 18 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Juniper House
    The Drive
    CM13 3BE Warley Hill Business Park
    Brentwood
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de O L DEC 18 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    COMMERZBANK LEASING DECEMBER (18) LIMITED13/04/201013/04/2010
    A & L CF SEPTEMBER (1) LIMITED07/07/200307/07/2003
    SOVEREIGN LIMITED30/04/198730/04/1987
    HARRISON GREEN INVESTMENTS LIMITED30/08/198530/08/1985

    Quais são as últimas contas de O L DEC 18 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até14/03/2010

    Quais são as últimas submissões para O L DEC 18 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    7 páginas4.71

    Endereço do domicílio registado alterado de 43-45 Butts Green Road Hornchurch Essex RM11 2JX em 14/03/2012

    1 páginasAD01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 06/12/2011

    8 páginas4.68

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 07/12/2010

    LRESSP

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Endereço do domicílio registado alterado de Verrington House Old London Road Knockholt Sevenoaks Kent TN14 7LU em 20/12/2010

    2 páginasAD01

    Término da nomeação de Michael Beebee como diretor

    2 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen Edward Hubble como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Paul Burrows como diretor

    2 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de 30 Gresham Street London EC2V 7PG United Kingdom em 09/12/2010

    2 páginasAD01

    Nomeação de Stephen Edward Hubble como secretário

    3 páginasAP03

    Término da nomeação de James Wall como secretário

    2 páginasTM02

    Término da nomeação de Neil Aiken como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Anthony Levy como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Richard Birch como diretor

    2 páginasTM01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Contas anuais preparadas até 14/03/2010

    11 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Richard Alastair Birch em 30/11/2010

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 01/07/2010 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/07/2010

    Estado do capital em 14/07/2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Detalhes do secretário alterados

    3 páginasCH03

    Resoluções

    Resolutions
    17 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed a & l cf september (1) LIMITED\certificate issued on 13/04/10
    2 páginasCERTNM
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Quem são os diretores de O L DEC 18 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HUBBLE, Stephen Edward
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    Secretário
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    British156260480001
    HUBBLE, Stephen Edward
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director48992140001
    DUVAL, Michael John
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    Secretário
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    British72879690001
    HAWKER, Richard Allen
    31 Narborough Road South
    LE3 2HA Leicester
    Leistershire
    Secretário
    31 Narborough Road South
    LE3 2HA Leicester
    Leistershire
    British78397850001
    HEPPLEWHITE, Julian
    The Old Rectory
    Rectory End
    LE8 9EW Burton Overy
    Leicestershire
    Secretário
    The Old Rectory
    Rectory End
    LE8 9EW Burton Overy
    Leicestershire
    British51619950002
    SINCLAIR FORD, Ian Andrew
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    Secretário
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    British58189030001
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Secretário
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    BritishChief Executive27312630001
    WALL, James Cameron
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    Secretário
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    British149989130001
    AIKEN, Neil Gordon
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    Diretor
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Banker43380390001
    BEEBEE, Michael Christopher
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    Diretor
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    United KingdomBritishInvestment Banker101122510002
    BIRCH, Richard Alastair
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    Diretor
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    United KingdomBritishUnited Kingdom76806940008
    BRITTAIN, Frederick Humphrey
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    Diretor
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    BritishDirector23574940002
    BURROWS, Paul Richard
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    Diretor
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    United KingdomEnglishAccountant126643220002
    DUFFY, Anthony Paul
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    Diretor
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    EnglandBritishDeputy Md Girobank72286750001
    EVANS, Martin William
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    Diretor
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    EnglandBritishAccountant55210060002
    FAULKNER, Geoffrey Arthur
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Diretor
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker147921000001
    GUGGLBERGER, Klaus
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    Diretor
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    AustrianDirector32780800002
    JARDINE, John
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    Diretor
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    BritishFinance House Director31897840002
    JONES, Christopher Stanley
    Flat 34 Roberts Court
    45-49 Barkston Gardens Kensington
    SW5 0ES London
    Diretor
    Flat 34 Roberts Court
    45-49 Barkston Gardens Kensington
    SW5 0ES London
    United KingdomBritishBanker152017480001
    LEE, Andrew Philip, Mr.
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    Diretor
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    United KingdomBritishFinance House Director73882180001
    LEVY, Anthony David
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    Diretor
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant98888430001
    MARKS, Norman
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Diretor
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    BritishFinance House Director48820520002
    MORLEY, Colin Richard
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    United Kingdom
    Diretor
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant89102840002
    PATERSON, William Hamilton
    Laigh Brownmuir House
    Glassford
    ML10 6TX Strathaven
    Lanarkshire
    Diretor
    Laigh Brownmuir House
    Glassford
    ML10 6TX Strathaven
    Lanarkshire
    ScotlandBritishBanker147129850001
    ROGERS, Malcolm Courtney
    2 Wheatley Royd Barn
    Brearley Lane Luddendenfoot
    HX2 6HX Halifax
    West Yorkshire
    Diretor
    2 Wheatley Royd Barn
    Brearley Lane Luddendenfoot
    HX2 6HX Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritishBanker72877280001
    ROUGIER, Alan Toby
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Diretor
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director, Specialised Finance108954830002
    SCOTT, Ian Garden
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    Diretor
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishCompany Director79132120001
    SWANN, Andrew Blyth
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishBanker60626890003
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Diretor
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    United KingdomBritishManaging Director27312630001
    TOWERS, Robert Leslie
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    Diretor
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    United KingdomBritishBanker65275200002

    O L DEC 18 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A lessor proceeds account assignment
    Criado em 15/03/2010
    Entregue em 26/03/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All its rights title and interest present and future in and to the assigned moneys and the assigned account together with any certificates of deposit, deposit receipts or other instruments or securities relatiing thereto see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Maersk Line UK Limited
    Transações
    • 26/03/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Chattel mortgage
    Criado em 04/03/2010
    Entregue em 12/03/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All present and future rights and title to and interest in the containers and compressors identified in schedule 1, including all component parts, accessories or other equipment attached. All insurances and any requisition compensation paid to or received by the company see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Maersk Line UK Limited
    Transações
    • 12/03/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Specific legal mortgage no 7
    Criado em 31/08/2004
    Entregue em 01/09/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The equipment identified by serial numbers described in or attached to schedule 1 to the specific mortgage the benefit of all insurances of the specific equipment and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transações
    • 01/09/2004Registro de uma garantia (395)
    Specific legal mortgage no 6
    Criado em 30/07/2004
    Entregue em 02/08/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the company's right, title and interest present and future in and to: (a) the equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to the specific mortgage (the "specific equipment") (b) the benefit of all insurances of the specific equipment (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment; and (d) all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transações
    • 02/08/2004Registro de uma garantia (395)
    Specific legal mortgage no.5
    Criado em 30/06/2004
    Entregue em 05/07/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The equipment indentified by the serial numbers described in or attached to the schedule 1 to the specific mortgage the benefit of all insurances of the specific equipment any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment and all warranties contracts or agreements relating to the condition operation use or repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transações
    • 05/07/2004Registro de uma garantia (395)
    Specific legal mortgage no 4
    Criado em 28/05/2004
    Entregue em 01/06/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The equipment indentified by the serial numbers described in or attached to the schedule 1 to the specific mortgage the benefit of all insurances of the specific equipment any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment and all warranties contracts or agreements relating to the condition operation use or repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transações
    • 01/06/2004Registro de uma garantia (395)
    Specific legal mortgage no 3
    Criado em 29/04/2004
    Entregue em 07/05/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All right title and interest in and to the equipment, the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable and all warranties contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transações
    • 07/05/2004Registro de uma garantia (395)
    Specific legal mortgage no 2
    Criado em 31/03/2004
    Entregue em 06/04/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the company's right, title and interest in the equipment, the benefit of all insurances, any compensation payable, all warranties, contracts or other agreements relating to the equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transações
    • 06/04/2004Registro de uma garantia (395)
    Specific legal mortgage no 1
    Criado em 27/02/2004
    Entregue em 04/03/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All right title and interest in and to the equipment,the benefit of all insurances,warranties,contracts or other agreements thereon; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transações
    • 04/03/2004Registro de uma garantia (395)
    A container mortgage
    Criado em 27/02/2004
    Entregue em 04/03/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All right title and interest and benefit in and to the equipment,benefit of all insurances and any compensation payable; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transações
    • 04/03/2004Registro de uma garantia (395)
    Lessor proceeds account
    Criado em 27/02/2004
    Entregue em 04/03/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All right title and interest in and to the interest bearing dollar account no 39775201 and all moneys,certificates of deposit or other instruments thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transações
    • 04/03/2004Registro de uma garantia (395)

    O L DEC 18 LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    23/10/2012Data de dissolução
    07/12/2010Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Jonathan Mark Birch
    Frp Advisory Llp 10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Profissional
    Frp Advisory Llp 10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Gareth Rutt Morris
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Profissional
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0