LOMBARD ASSET LEASING LIMITED

LOMBARD ASSET LEASING LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaLOMBARD ASSET LEASING LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01952037
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?

    • Intermediação financeira n.c.o.p. (64999) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    135 Bishopsgate
    London
    EC2M 3UR London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    FIELDCHARM LIMITED02/10/198502/10/1985

    Quais são as últimas contas de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2014

    Qual é o status da última declaração anual para LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Satisfação total da garantia 6

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 4

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 3

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 2

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 1

    4 páginasMR04

    Declaração anual preparada até 31/10/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital05/11/2015

    Estado do capital em 05/11/2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomeação de Adam Holden como diretor em 11/05/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Andrew Paul Gadsby como diretor em 11/05/2015

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2014

    15 páginasAA

    Nomeação de Mr Peter Edmund Lord como diretor em 27/02/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nigel Timothy John Clibbens como diretor em 27/02/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 31/10/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital31/10/2014

    Estado do capital em 31/10/2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas preparadas até 30/09/2013

    19 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/10/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/11/2013

    Estado do capital em 20/11/2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de * 3 Princess Way Redhill Surrey RH1 1NP* em 23/09/2013

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Andrew Paul Gadsby como diretor

    2 páginasAP01

    Contas preparadas até 30/09/2012

    19 páginasAA

    Término da nomeação de Andrew Barnard como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 30/10/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Nomeação de Rbs Secretarial Services Limited como secretário

    2 páginasAP04

    Quem são os diretores de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Secretário
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registroSC269847
    169073830001
    HOLDEN, Adam
    Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Smith House
    Middlesex
    England
    Diretor
    Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Smith House
    Middlesex
    England
    EnglandBritishBank Official185018800001
    LORD, Peter Edmund
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    Diretor
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishFinance House Manager195549570001
    BROMLEY, Heidi Elizabeth
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    Secretário
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    British33605720002
    CAMERON, Lindsey Helen
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Secretário
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Other132335590001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Secretário
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    DALY, Kirsty
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secretário
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    160758120001
    EVANS, Margaret Janet
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    Secretário
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    British2289880001
    STRANAGHAN, Patricia Ann
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    Secretário
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    British39114460001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Secretário
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    WILLIAMSON, Amy
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secretário
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    166979420001
    WRAITH CARTER, Gillian
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    Secretário
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    British109333000001
    ASHWORTH, George Smith-Salmond
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    EnglandEnglishBanker152638710001
    BALDOCK, Alexander David
    Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    218
    United Kingdom
    Diretor
    Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    218
    United Kingdom
    United KingdomBritishBank Official132330380001
    BARNARD, Andrew David
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    Diretor
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    EnglandBritishBank Official137736080001
    BEESTON, Alistair John
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    BritishBanker10670790001
    CARTE, Brian Addison
    Fairfield Lodge
    Hardwick Close Knott Park
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    Diretor
    Fairfield Lodge
    Hardwick Close Knott Park
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritishBanker/Governor Of Motability145559220001
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Diretor
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director123744930001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant49141230004
    FITCH, John Derek
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    Diretor
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    BritishDirector & Gen Manager8461210001
    GADSBY, Andrew Paul
    London
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    Diretor
    London
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official74834980002
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Diretor
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritishFinance House Manager107984310001
    JOHNSON, Jeffrey
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    Diretor
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    BritishAccountant103077710001
    KAPUR, Neeraj
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    Diretor
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    United KingdomBritishBank Official122158360001
    KNOWLES, Christopher George
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    Diretor
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    BritishBank Executive67501900002
    LYNAM, Paul Anthony
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    Diretor
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    United KingdomIrishManaging Director100755360001
    MABERLY, Michael Alan
    Endellion
    Money Row Green Holyport
    SL6 2NA Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    Endellion
    Money Row Green Holyport
    SL6 2NA Maidenhead
    Berkshire
    BritishFactor1288990001
    MARROW, Paul
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    Diretor
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishBanker85771600001
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Diretor
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritishBanker63084840002
    POWELL, Martin Edward
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    Diretor
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    United KingdomBritishDirector Risk & Regulation59795080001
    PRIESTMAN, Richard Mark
    31 Hove Park Villas
    BN3 6HH Hove
    Sussex
    Diretor
    31 Hove Park Villas
    BN3 6HH Hove
    Sussex
    EnglandBritishChartered Accountant74412220002
    PURDY, John Douglas
    Kendals
    Little Heath Lane, Potten End
    HP4 2RY Berkhamsted
    Hertfordshire
    Diretor
    Kendals
    Little Heath Lane, Potten End
    HP4 2RY Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant68943220001
    ROOME, Harry Mccrea
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    Diretor
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    EnglandBritishAccountant/Banker64898180001
    STUART, John David
    69 Howards Thicket
    SL9 7NU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    69 Howards Thicket
    SL9 7NU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishDirector76974710001
    SULLIVAN, Christopher Paul
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    Diretor
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant/Banker67033830004

    LOMBARD ASSET LEASING LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of covenant
    Criado em 20/07/2001
    Entregue em 26/07/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 4 of the recoveries agreement dated 12 july 1999 and/or the security assignment dated 12 july 1999 (all terms as defined)
    Breve descrição
    All its right title and interest present and future in and to the vessel being the M.V. p&o nedlloyd cook registered under a certificate of british ships, official number 904689.
    Pessoas com direito
    • Girobank PLC
    Transações
    • 26/07/2001Registro de uma garantia (395)
    • 03/10/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage of a ship
    Criado em 20/07/2001
    Entregue em 26/07/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 4 of the recoveries agreement dated 12 july 1999 and/or the security assignment dated 12 july 1999 (all terms as defined)
    Breve descrição
    All of its interest in the the M.V. p&o nedlloyd cook registered under a certificate of british ships with official number 904689.
    Pessoas com direito
    • Girobank PLC
    Transações
    • 26/07/2001Registro de uma garantia (395)
    • 03/10/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    First priority british statutory ship mortgage
    Criado em 19/09/2000
    Entregue em 06/10/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All and any monies due or to become due in rebate of charterhire payable by the owner to the charterer pursuant to clauses 10.1.1(b), 15.8.2 and 16.3.10 of the charterparty and clause 4 of the dpp and any and all moneys liabilities actual or contingent present or future due owing payable or incurred from the company (as owner) to the chargee under the dpp, the deed of covenant, this mortgage and the lessor security assignment
    Breve descrição
    64 sixty fourth shares in the ship "midnight merchant" registered on the british register with o/n;-903597 and it's appurtenances.
    Pessoas com direito
    • Nedship Bank Nv
    Transações
    • 06/10/2000Registro de uma garantia (395)
    • 02/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Lessor security assignment relating to "midnight merchant"
    Criado em 19/09/2000
    Entregue em 02/10/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All and any monies by way of rebate of charterhire payable by the owner to the charterer pursuant to clauses 10.1.1(b), 15.8.2 and 16.3.10 of the charterparty and clause 4.1(c) of the dpp and any and all moneys liabilities and obligations (actual or contingent whether or not existing or hereafter arising, principal or surety, whether or not for the payment of money and any obligation or liability to pay damages) from the owner to the mortgagee (in it's capacity as security trustee) under the security documents.
    Breve descrição
    All the company's rights title benefir and interest in and to a). The insurances and requisition compensation b). The security assignment and all payments to the company in respect thereof and all claims and rights arising therefrom. In relation to M.V. "midnight merchant". See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nedship Bank Nv
    Transações
    • 02/10/2000Registro de uma garantia (395)
    • 02/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of covenant relating to "midnight merchant"
    Criado em 19/09/2000
    Entregue em 02/10/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All and any monies by way of rebate of charterhire payable by the owner to the charterer pursuant to clauses 10.1.1(b), 15.8.2 and 16.3.10 of the charterparty and clause 4.1(c) of the dpp and any and all moneys liabilities and obligations (actual or contingent whether or not existing or hereafter arising, principal or surety, whether or not for the payment of money and any obligation or liability to pay damages) from the owner to the mortgagee (in it's capacity as security trustee) under the security documents.
    Breve descrição
    All the company's right title and interest in and to the mortgaged property being roll on roll off cargo passenger vessel hull number 290 named "midnight merchant" and all parts engines boats and equipment and all other equiment leased otherwise thatn pursuant to the transaction documents and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nedship Bank Nv
    Transações
    • 02/10/2000Registro de uma garantia (395)
    • 02/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    An accounts assignment
    Criado em 23/08/1999
    Entregue em 25/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    In favour of the chargee all sums owing by the company by way of recoveries under or pursuant to a recoveries and loss sharing agreement dated 12TH july 1999 (the "recoveries and loss sharing agreement") in respect of a lease agreement dated 6TH july 1999 (the "lease")
    Breve descrição
    The company's right title and interest present and future in and to interest-bearing deposit accounts denominated in sterling and dollars in the name of the company held with the national westminster bank PLC into which the company pays any net sales or total loss proceed in respect of the ship or any other moneys irrevocably and unconditionally received by the company,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Girobank PLC
    Transações
    • 25/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 02/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A deed of assignment
    Criado em 12/07/1999
    Entregue em 22/07/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a recoveries and loss sharing agreement dated 12 july 1999
    Breve descrição
    The company's right title and interest in and to the benefit of all insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Girobank PLC
    Transações
    • 22/07/1999Registro de uma garantia (395)
    • 02/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Lessor mortgage and assignment
    Criado em 19/11/1997
    Entregue em 20/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The obligation of the company to use reasonable endeavours to procure that the net sale proceeds resulting from a sale of the aircraft are, if paid to the company by a purchaser of the aircraft, paid directly into the proceeds account and the obligations of the company to pay rebates of rental to airtours international airways limited under clause 10.2.5 and clause 19.3 of the head lease agreement (the secured obligations)
    Breve descrição
    One dassault falcon 900B aircraft with manufacturers serial number 165 and UK reg mark g-eves and all present and future rights titles and interest in the net proceeds of sale and the warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Colne Leasing Limited
    Transações
    • 20/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 02/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0