LOMBARD ASSET LEASING LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | LOMBARD ASSET LEASING LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01952037 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?
- Intermediação financeira n.c.o.p. (64999) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 135 Bishopsgate London EC2M 3UR London |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
FIELDCHARM LIMITED | 02/10/1985 | 02/10/1985 |
Quais são as últimas contas de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 30/09/2014 |
Qual é o status da última declaração anual para LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?
Declaração anual |
|
---|
Quais são as últimas submissões para LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Renúncia do auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 6 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 5 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 31/10/2015 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Adam Holden como diretor em 11/05/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Andrew Paul Gadsby como diretor em 11/05/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/09/2014 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Peter Edmund Lord como diretor em 27/02/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Nigel Timothy John Clibbens como diretor em 27/02/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 31/10/2014 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas preparadas até 30/09/2013 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 31/10/2013 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * 3 Princess Way Redhill Surrey RH1 1NP* em 23/09/2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Andrew Paul Gadsby como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas preparadas até 30/09/2012 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Andrew Barnard como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 30/10/2012 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Rbs Secretarial Services Limited como secretário | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Quem são os diretores de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
HOLDEN, Adam | Diretor | Elmwood Avenue TW13 7QD Feltham Smith House Middlesex England | England | British | Bank Official | 185018800001 | ||||||||
LORD, Peter Edmund | Diretor | EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | England | British | Finance House Manager | 195549570001 | ||||||||
BROMLEY, Heidi Elizabeth | Secretário | 40 Hitchings Way RH2 8EW Reigate Surrey | British | 33605720002 | ||||||||||
CAMERON, Lindsey Helen | Secretário | The Terrace Glenlomond KY13 9HF Kinross Suite Gleann Cottage, 1 | Other | 132335590001 | ||||||||||
CUNNINGHAM, Angela Mary | Secretário | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
DALY, Kirsty | Secretário | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 160758120001 | |||||||||||
EVANS, Margaret Janet | Secretário | 17 Coniston Way RH2 0LN Reigate Surrey | British | 2289880001 | ||||||||||
STRANAGHAN, Patricia Ann | Secretário | Flat 1 25 Somers Road RH2 9DY Reigate Surrey | British | 39114460001 | ||||||||||
WHITTAKER, Carolyn Jean | Secretário | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
WILLIAMSON, Amy | Secretário | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 166979420001 | |||||||||||
WRAITH CARTER, Gillian | Secretário | 8 Great Lime Kilns Southwater RH13 9JL Horsham West Sussex | British | 109333000001 | ||||||||||
ASHWORTH, George Smith-Salmond | Diretor | 2 Laurelsfield AL3 4BZ St Albans Hertfordshire | England | English | Banker | 152638710001 | ||||||||
BALDOCK, Alexander David | Diretor | Westbourne Park Road W11 1EP London 218 United Kingdom | United Kingdom | British | Bank Official | 132330380001 | ||||||||
BARNARD, Andrew David | Diretor | Bell Cottage Bell Road RH12 3QL Warnham Bell Cottage West Sussex England | England | British | Bank Official | 137736080001 | ||||||||
BEESTON, Alistair John | Diretor | Three Oaks Vauxhall Lane Southborough TN4 0XD Tunbridge Wells Kent | British | Banker | 10670790001 | |||||||||
CARTE, Brian Addison | Diretor | Fairfield Lodge Hardwick Close Knott Park KT22 0HZ Oxshott Surrey | United Kingdom | British | Banker/Governor Of Motability | 145559220001 | ||||||||
CLEMETT, Graham Colin | Diretor | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 123744930001 | ||||||||
CLIBBENS, Nigel Timothy John | Diretor | 40a Pennington Road Southborough TN4 0SL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 49141230004 | ||||||||
FITCH, John Derek | Diretor | Douglas Cottage Coombe End KT2 7DQ Kingston Surrey | British | Director & Gen Manager | 8461210001 | |||||||||
GADSBY, Andrew Paul | Diretor | London EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | England | British | Bank Official | 74834980002 | ||||||||
HIGGINS, Peter | Diretor | 2 Grange Close RH1 4LW Bletchingley Surrey | England | British | Finance House Manager | 107984310001 | ||||||||
JOHNSON, Jeffrey | Diretor | Hill House 28 Maldon Road Danbury CM3 4QH Chelmsford Essex | British | Accountant | 103077710001 | |||||||||
KAPUR, Neeraj | Diretor | The Old Granary Hillside Road GU10 3AJ Frensham Surrey | United Kingdom | British | Bank Official | 122158360001 | ||||||||
KNOWLES, Christopher George | Diretor | Whispering Well House Chander Hill Lane, Holymoorside S42 7HN Chesterfield Derbyshire | British | Bank Executive | 67501900002 | |||||||||
LYNAM, Paul Anthony | Diretor | 24 Warwick Road RG2 7AX Reading Berkshire | United Kingdom | Irish | Managing Director | 100755360001 | ||||||||
MABERLY, Michael Alan | Diretor | Endellion Money Row Green Holyport SL6 2NA Maidenhead Berkshire | British | Factor | 1288990001 | |||||||||
MARROW, Paul | Diretor | The Shutters 2 Nightjar Close Ewshot GU10 5TQ Farnham Surrey | United Kingdom | British | Banker | 85771600001 | ||||||||
PEARCE, Nigel | Diretor | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | Banker | 63084840002 | ||||||||
POWELL, Martin Edward | Diretor | Monroe Station Road Hatfield Peverel CM3 2DS Chelmsford | United Kingdom | British | Director Risk & Regulation | 59795080001 | ||||||||
PRIESTMAN, Richard Mark | Diretor | 31 Hove Park Villas BN3 6HH Hove Sussex | England | British | Chartered Accountant | 74412220002 | ||||||||
PURDY, John Douglas | Diretor | Kendals Little Heath Lane, Potten End HP4 2RY Berkhamsted Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 68943220001 | |||||||||
ROOME, Harry Mccrea | Diretor | The Duchies Mill Lane, Pirbright GU24 0BT Woking Surrey | England | British | Accountant/Banker | 64898180001 | ||||||||
STUART, John David | Diretor | 69 Howards Thicket SL9 7NU Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Director | 76974710001 | |||||||||
SULLIVAN, Christopher Paul | Diretor | Princess Way RH1 1NP Redhill 3 Surrey | United Kingdom | British | Accountant/Banker | 67033830004 |
LOMBARD ASSET LEASING LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Deed of covenant | Criado em 20/07/2001 Entregue em 26/07/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 4 of the recoveries agreement dated 12 july 1999 and/or the security assignment dated 12 july 1999 (all terms as defined) | |
Breve descrição All its right title and interest present and future in and to the vessel being the M.V. p&o nedlloyd cook registered under a certificate of british ships, official number 904689. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage of a ship | Criado em 20/07/2001 Entregue em 26/07/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 4 of the recoveries agreement dated 12 july 1999 and/or the security assignment dated 12 july 1999 (all terms as defined) | |
Breve descrição All of its interest in the the M.V. p&o nedlloyd cook registered under a certificate of british ships with official number 904689. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
First priority british statutory ship mortgage | Criado em 19/09/2000 Entregue em 06/10/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All and any monies due or to become due in rebate of charterhire payable by the owner to the charterer pursuant to clauses 10.1.1(b), 15.8.2 and 16.3.10 of the charterparty and clause 4 of the dpp and any and all moneys liabilities actual or contingent present or future due owing payable or incurred from the company (as owner) to the chargee under the dpp, the deed of covenant, this mortgage and the lessor security assignment | |
Breve descrição 64 sixty fourth shares in the ship "midnight merchant" registered on the british register with o/n;-903597 and it's appurtenances. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Lessor security assignment relating to "midnight merchant" | Criado em 19/09/2000 Entregue em 02/10/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All and any monies by way of rebate of charterhire payable by the owner to the charterer pursuant to clauses 10.1.1(b), 15.8.2 and 16.3.10 of the charterparty and clause 4.1(c) of the dpp and any and all moneys liabilities and obligations (actual or contingent whether or not existing or hereafter arising, principal or surety, whether or not for the payment of money and any obligation or liability to pay damages) from the owner to the mortgagee (in it's capacity as security trustee) under the security documents. | |
Breve descrição All the company's rights title benefir and interest in and to a). The insurances and requisition compensation b). The security assignment and all payments to the company in respect thereof and all claims and rights arising therefrom. In relation to M.V. "midnight merchant". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed of covenant relating to "midnight merchant" | Criado em 19/09/2000 Entregue em 02/10/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All and any monies by way of rebate of charterhire payable by the owner to the charterer pursuant to clauses 10.1.1(b), 15.8.2 and 16.3.10 of the charterparty and clause 4.1(c) of the dpp and any and all moneys liabilities and obligations (actual or contingent whether or not existing or hereafter arising, principal or surety, whether or not for the payment of money and any obligation or liability to pay damages) from the owner to the mortgagee (in it's capacity as security trustee) under the security documents. | |
Breve descrição All the company's right title and interest in and to the mortgaged property being roll on roll off cargo passenger vessel hull number 290 named "midnight merchant" and all parts engines boats and equipment and all other equiment leased otherwise thatn pursuant to the transaction documents and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
An accounts assignment | Criado em 23/08/1999 Entregue em 25/08/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido In favour of the chargee all sums owing by the company by way of recoveries under or pursuant to a recoveries and loss sharing agreement dated 12TH july 1999 (the "recoveries and loss sharing agreement") in respect of a lease agreement dated 6TH july 1999 (the "lease") | |
Breve descrição The company's right title and interest present and future in and to interest-bearing deposit accounts denominated in sterling and dollars in the name of the company held with the national westminster bank PLC into which the company pays any net sales or total loss proceed in respect of the ship or any other moneys irrevocably and unconditionally received by the company,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A deed of assignment | Criado em 12/07/1999 Entregue em 22/07/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a recoveries and loss sharing agreement dated 12 july 1999 | |
Breve descrição The company's right title and interest in and to the benefit of all insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Lessor mortgage and assignment | Criado em 19/11/1997 Entregue em 20/11/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido The obligation of the company to use reasonable endeavours to procure that the net sale proceeds resulting from a sale of the aircraft are, if paid to the company by a purchaser of the aircraft, paid directly into the proceeds account and the obligations of the company to pay rebates of rental to airtours international airways limited under clause 10.2.5 and clause 19.3 of the head lease agreement (the secured obligations) | |
Breve descrição One dassault falcon 900B aircraft with manufacturers serial number 165 and UK reg mark g-eves and all present and future rights titles and interest in the net proceeds of sale and the warranties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0