QYJ LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaQYJ LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01959056
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de QYJ LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica QYJ LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    5th Floor Grove House
    248a Marylebone Road
    NW1 6BB London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de QYJ LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    NIGHTFREIGHT LIMITED17/06/199317/06/1993
    NIGHTFREIGHT (HOLDINGS) LIMITED 08/07/198608/07/1986
    ALLKNOCK LIMITED14/11/198514/11/1985

    Quais são as últimas contas de QYJ LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até27/06/2020

    Quais são as últimas submissões para QYJ LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    19 páginasLIQ13

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Endereço do domicílio registado alterado de Ditton Park Riding Court Road Datchet Slough SL3 9GL England para 5th Floor Grove House 248a Marylebone Road London NW1 6BB em 05/04/2022

    2 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 23/03/2022

    LRESSP

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Declaração de confirmação apresentada em 14/12/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Russell Alan Deards como diretor em 13/05/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Ronald Charles Series como diretor em 13/05/2021

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 27/06/2020

    7 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 14/12/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/06/2019

    11 páginasAA

    legacy

    70 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaração de confirmação apresentada em 14/12/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/06/2018

    12 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 14/12/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    legacy

    71 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Término da nomeação de Hugh Owens como diretor em 17/04/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Zoe Lesley Pepper como secretário em 17/04/2018

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Hugh Owens como diretor em 17/04/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Zoe Lesley Pepper como secretário em 17/04/2018

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de QYJ LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DEARDS, Russell Alan
    248a Marylebone Road
    NW1 6BB London
    5th Floor Grove House
    Diretor
    248a Marylebone Road
    NW1 6BB London
    5th Floor Grove House
    EnglandBritishSolicitor130371300003
    MULLIGAN, David Kevin
    248a Marylebone Road
    NW1 6BB London
    5th Floor Grove House
    Diretor
    248a Marylebone Road
    NW1 6BB London
    5th Floor Grove House
    EnglandBritishChief Finance Officer74215210003
    HORSFALL, Ian David
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Secretário
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    British104565220001
    MCGRATH, Raquel
    The Ridgeway
    SL0 9JQ Iver
    Dx House
    Buckinghamshire
    England
    Secretário
    The Ridgeway
    SL0 9JQ Iver
    Dx House
    Buckinghamshire
    England
    British167863700001
    PEPPER, Zoe Lesley
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    Secretário
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    217573310001
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Secretário
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    British35522270001
    WILKES, Sarita Kaur
    The Ridgeway
    SL0 9JQ Iver
    Dx House
    Buckinghamshire
    Secretário
    The Ridgeway
    SL0 9JQ Iver
    Dx House
    Buckinghamshire
    209356360001
    ALLEN, Stephen John
    51 Old Penkridge Road
    WS11 1HY Cannock
    Whitemead
    Staffordshire
    Diretor
    51 Old Penkridge Road
    WS11 1HY Cannock
    Whitemead
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector113733110002
    BASI, Daljit Singh
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    Diretor
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    EnglandBritishFinance Director208533970001
    BLACK, David Russell
    18 College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    Diretor
    18 College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    BritishCompany Director2755270005
    BURNS, Bernard Kenneth Robbie
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Diretor
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    EnglandBritishDirector239557120001
    COBB, David Bilsland
    Hilltop
    15 Richmondwood
    SL5 0JG Sunningdale
    Berkshire
    Diretor
    Hilltop
    15 Richmondwood
    SL5 0JG Sunningdale
    Berkshire
    BritishCompany Director73830490002
    CVETKOVIC, Petar
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    Diretor
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    United KingdomBritishNone150976300002
    DUNN, Lloyd John Charles
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    Diretor
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector105512500001
    HORSFALL, Ian David
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Diretor
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director104565220001
    HOWARD, John Ian
    3 Ditches Green
    Trap Lane Ockley
    RH5 5QX Dorking
    Surrey
    Diretor
    3 Ditches Green
    Trap Lane Ockley
    RH5 5QX Dorking
    Surrey
    BritishCompany Director41614150001
    IRONS, Ronald William
    Walcombe Farm House
    BA5 3AG Wells
    Somerset
    Diretor
    Walcombe Farm House
    BA5 3AG Wells
    Somerset
    BritishTransport And Distribution Con606700001
    JACKSON, Kenneth
    Savile Ings Farm
    Holywell Green
    HX4 9BS Halifax
    West Yorkshire
    Diretor
    Savile Ings Farm
    Holywell Green
    HX4 9BS Halifax
    West Yorkshire
    BritishChief Executive2662570001
    JOHNSON, Luke Oliver
    32 Clarendon Gardens
    W9 1AZ London
    Diretor
    32 Clarendon Gardens
    W9 1AZ London
    EnglandBritishRestaurateur141745230001
    JOHNSON, Peter Robert
    Westmount
    Vyner Road South
    CH43 7PN Birkenhead
    Wirral
    Diretor
    Westmount
    Vyner Road South
    CH43 7PN Birkenhead
    Wirral
    SwitzerlandBritishCompany Director72280480001
    KELLY, Robert David Lindsay
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    Diretor
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    EnglandWelshDirector161123860001
    LOUDEN, Peter
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Diretor
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector172376370001
    MILLER, John
    5 Talbot Court
    Huyton
    L36 5YW Liverpool
    Merseyside
    Diretor
    5 Talbot Court
    Huyton
    L36 5YW Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director74164340001
    OWENS, Hugh
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    Diretor
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    ScotlandScottishChief People Officer214189450001
    PAIN, Ian Richard
    The Ridgeway
    SL0 9JQ Iver
    Dx House
    Buckinghamshire
    England
    Diretor
    The Ridgeway
    SL0 9JQ Iver
    Dx House
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishNone130880070001
    PAINTER, James
    Stoneleigh House Burley Lane
    DE22 5JR Quarndon
    Derbyshire
    Diretor
    Stoneleigh House Burley Lane
    DE22 5JR Quarndon
    Derbyshire
    BritishCompany Director41731410001
    PATTEMORE, Anthony
    4 The Coppice
    LE10 2TF Burbage
    Leicestershire
    Diretor
    4 The Coppice
    LE10 2TF Burbage
    Leicestershire
    BritishDirector115990200001
    PAYNE, Morton
    39 Latchford Road
    Gayton
    CH60 3RN Wirral
    Diretor
    39 Latchford Road
    Gayton
    CH60 3RN Wirral
    BritishCompany Director3765660003
    PEARCE, Michael Graham
    12 Spring Meadow
    Cheslyn Hay
    WS6 7JW Walsall
    Staffordshire
    Diretor
    12 Spring Meadow
    Cheslyn Hay
    WS6 7JW Walsall
    Staffordshire
    BritishDirector49385270002
    PEPPER, Zoe Lesley
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    Diretor
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    EnglandBritishGeneral Counsel236097990001
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Diretor
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director22018030002
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Diretor
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    BritishCompany Director35522270001
    SERIES, Ronald Charles
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    Diretor
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9GL Slough
    Ditton Park
    England
    EnglandBritishChairman118534550001
    SULLIVAN, Ronald Thomas
    Woodbarns Farm Blackmore Road
    Fryerning
    CM4 0PA Ingatestone
    Essex
    Diretor
    Woodbarns Farm Blackmore Road
    Fryerning
    CM4 0PA Ingatestone
    Essex
    United KingdomBritishDirector32440070011
    WATSON, Paul John
    Dairy Cottage Palmers Cross Farm
    Codsall Road
    WV6 9QG Wolverhampton
    Staffordshire
    Diretor
    Dairy Cottage Palmers Cross Farm
    Codsall Road
    WV6 9QG Wolverhampton
    Staffordshire
    BritishManaging Direct29494480003

    Quem são as pessoas com controle significativo de QYJ LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    The Ridgeway
    SL0 9JQ Iver
    Dx House
    Buckinghamshire
    England
    06/04/2016
    The Ridgeway
    SL0 9JQ Iver
    Dx House
    Buckinghamshire
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalEngland
    Local de registroCompanies House
    Número de registro04126056
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    QYJ LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 13/03/2014
    Entregue em 22/03/2014
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Trademark DELIVER2HOME logo b&w no 2391095 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Agent)
    Transações
    • 22/03/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 30/01/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 12/06/2008
    Entregue em 01/07/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    East side of cumbuslang road, cambuslang, glasgow t/no LAN145301.
    Pessoas com direito
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 01/07/2008Registro de uma garantia (395)
    • 02/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Supplemental legal mortgage
    Criado em 05/06/2008
    Entregue em 18/06/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Secured Parties (Security Trustee)
    Transações
    • 18/06/2008Registro de uma garantia (395)
    • 02/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite debenture
    Criado em 30/06/2004
    Entregue em 05/07/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee and the secured parties and to any of them. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    F/H property being depot at josselin road and wollaston way burnt mills industrial estate basildon t/n EX481057. Land and buildings on the south west side of greenbrook road lowerhouse t/n LS730423, land and buildings on the south west side of greenbrook road lowerhouse t/n LA624280. (For details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Securedparties
    Transações
    • 05/07/2004Registro de uma garantia (395)
    • 02/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Supplemental deed to the third guarantee and debenture (the "debenture") dated 20 june 2001 made between nightfreight PLC (now known as nightfreight limited) and the governor and company of the bank of scotland
    Criado em 19/12/2001
    Entregue em 02/01/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    As set out in the assignment dated 03 july 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Breve descrição
    As set out in the 395 registered on 3 july 2001 in relation to the debenture.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 02/01/2002Registro de uma garantia (395)
    • 02/07/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed to the second guarantee and debenture (the "debenture") dated 05 march 2001 made between nightfreight PLC (now known as nightfreight limited) and the governor and company of the bank of scotland
    Criado em 19/12/2001
    Entregue em 02/01/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    As set out in the assignment dated 13 march 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Breve descrição
    As set out in the 395 registered on 13 march 2001 in relation to the debenture.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 02/01/2002Registro de uma garantia (395)
    • 02/07/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 20/06/2001
    Entregue em 03/07/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred by the company (the "chargor") to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (both as defined therein) to which it is expressed to be a party; and each other company to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) (as therein defined) (except as a guarantor for the "chargor") under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents and on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 03/07/2001Registro de uma garantia (395)
    • 21/08/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 02/07/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 05/03/2001
    Entregue em 13/03/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for the benficiaries (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and each other company (as defined) (except as guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents on any account whatsoever and all monies and liabilities owing or incurred to each beneficiary by the compan under or pursuant to the mezzanine finance documents (as defined) and each other company (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/03/2001Registro de uma garantia (395)
    • 02/07/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Criado em 05/11/1997
    Entregue em 19/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Please refer to form 395 for full details of charged assets. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 19/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 08/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment of deposit account moneys
    Criado em 22/08/1997
    Entregue em 09/09/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that principal sum of £131,406.25 or such sum or such part thereof as is for the time being standing to the credit of account number 20014530 at the royal bank of scotland PLC,67 lombard street,london EC3P 3DL with all interest credited thereto and all the right title and interest of the company whatsoever both present and future.
    Pessoas com direito
    • 3I PLC
    Transações
    • 09/09/1997Registro de uma garantia (395)
    • 23/01/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge and release over deposit
    Criado em 22/08/1997
    Entregue em 27/08/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The company charges with full title guarantee the sum (whether of principal,interest or otherwise) at the date of the charge or thereafter standing to the credit of such account of the company with the bank which is designated "provisions for acceptance/contingent liabilities re nightfreight PLC" or which is designated as blocked or which otherwise cannot be operated by the company without the consent of the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 27/08/1997Registro de uma garantia (395)
    • 08/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/08/1997
    Entregue em 27/08/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 27/08/1997Registro de uma garantia (395)
    • 08/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage (customer's account)
    Criado em 15/07/1997
    Entregue em 17/07/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or ot become due from the company and/or nightfreight (great britain) limited and/or nightfreight distribution limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land at redfern street liverpool title number MS370423. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 17/07/1997Registro de uma garantia (395)
    • 13/01/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over credit balances
    Criado em 20/03/1997
    Entregue em 08/04/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to unsecured guaranteed loan notes in favour of bachmann trust company limited for £1,390,000
    Breve descrição
    The sum of £1,390,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 8296464.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/04/1997Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over a deposit
    Criado em 28/10/1996
    Entregue em 01/11/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of fixed charge to the bank the balance for the time being standing to the credit of the following account: deposit account in the name of nightfreight PLC re: loan note guarantee account no: 68166011.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 01/11/1996Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 11/07/1995
    Entregue em 12/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company, nightfreight (great britain) limited and nightfreight distribution limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land and buildings lying to the south east of woolsthorpe close, nottingham nottinghamshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 12/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 11/07/1995
    Entregue em 12/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company, nightfreight (great britain) limited and nightfreight distribution limited to the chargee on any accou nt whatsoever
    Breve descrição
    Unit 9 chasetown industrial estate chasetown staffordshire lichfield including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 12/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 11/07/1995
    Entregue em 12/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company, nightfreight (great britain) limited and nightfreight distribution limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    9A medway city estate frindsbury strood rochester kent including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 12/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 11/07/1995
    Entregue em 12/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company, nightfreight (great britain) limited and nightfreight distribution limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 30 drum industrial estate chester le street durham including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 12/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 11/07/1995
    Entregue em 12/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from nightfreight (great britain) limited, nightfreight distribution limited and the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 16, eaton socon industrial estate howard road st. Neots. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 12/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 11/07/1995
    Entregue em 12/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company, nightfreight di stribution limited and nightfreight (great britain) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    East grinstead tec imberhorne way east grinstead including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 12/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 09/01/1995
    Entregue em 13/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/ or nightfreight (great britain) limited and/or nightfreight distribution limited to the chargee under the terms of the debenture
    Breve descrição
    See charge particulars form for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transações
    • 13/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 30/11/1993
    Entregue em 04/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    F/H-property south of green lane failsworth oldham greater manchester t/n LA228792, GM508300 and GM509657 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery. Floating charge over all moveable fixtures and fittings plant machinery and articles.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 04/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 19/11/1993
    Entregue em 23/11/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other companys named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that f/h property south west of greenbrook road lowerhouse burnley lancashire t/no la 490187 LA528111 ( now known as la 730423 ) and la 624280 with all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 23/11/1993Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 06/11/1993
    Entregue em 09/11/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 09/11/1993Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    QYJ LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    23/03/2022Início da liquidação
    28/05/2023Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Andrew John Duncan
    Leonard Curtis 5th Floor Grove House
    248a Marylebone Road
    NW1 6BB London
    Profissional
    Leonard Curtis 5th Floor Grove House
    248a Marylebone Road
    NW1 6BB London
    Neil A Bennett
    5th Floor Grove House 248a Marylebone Road
    NW1 6BB London
    Profissional
    5th Floor Grove House 248a Marylebone Road
    NW1 6BB London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0